A.N.C. (NOTTINGHAM) LIMITED

A.N.C. (NOTTINGHAM) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàA.N.C. (NOTTINGHAM) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01623641
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di A.N.C. (NOTTINGHAM) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova A.N.C. (NOTTINGHAM) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Parkhouse East Industrial Estate
    Newcastle Under Lyme
    ST5 7RB Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di A.N.C. (NOTTINGHAM) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per A.N.C. (NOTTINGHAM) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 mar 2012

    6 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 ago 2011

    5 pagine4.68

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Russell Allen il 04 set 2010

    3 pagineCH01

    Cessazione della carica di Robert Elliott come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 ago 2010

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Cessazione della carica di Kenneth Koval come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    18 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 giu 2010

    Stato del capitale al 09 giu 2010

    • Capitale: GBP 30,000
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    2 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2009

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Robert William Elliott il 15 dic 2006

    1 pagineCH01

    legacy

    8 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mag 2008

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    8 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mag 2007

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di A.N.C. (NOTTINGHAM) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAWKINS, James Edmund
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Segretario
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishAccountant101387860002
    PARROTT, Stephen John
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    Segretario
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    BritishBusiness Executive48941480002
    ALLEN, Mark Russell
    St. Goedeleplein 14
    1000 Brussels
    Federal Express Europe Inc.
    Belgium
    Amministratore
    St. Goedeleplein 14
    1000 Brussels
    Federal Express Europe Inc.
    Belgium
    BelgiumUnited StatesBusiness Executive77781820007
    HOLT, Michael John
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director121123210001
    DURACK, Sean Patrick
    4 Churchston Avenue
    Bramhall
    SK7 3DA Stockport
    Cheshire
    Segretario
    4 Churchston Avenue
    Bramhall
    SK7 3DA Stockport
    Cheshire
    British87327210001
    RONALD, Paul
    15 Arran Close
    Holmes Chapel
    CW4 7QP Crewe
    Cheshire
    Segretario
    15 Arran Close
    Holmes Chapel
    CW4 7QP Crewe
    Cheshire
    British71473700001
    TAYLOR, Michael John
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    Segretario
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    British64380001
    CALLAGHAN, Andrew Michael
    Graybrook Farm
    Middlewich Road
    WA16 9JQ Allostock
    Cheshire
    Amministratore
    Graybrook Farm
    Middlewich Road
    WA16 9JQ Allostock
    Cheshire
    BritishChief Executive76165950001
    CRANMER, Charles David
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishFinance Director60508750002
    ELLIOTT, Robert William
    B-1420 Braine L'Alleud
    Avenue Des Champs 2
    Belgium
    Amministratore
    B-1420 Braine L'Alleud
    Avenue Des Champs 2
    Belgium
    AmericanBusiness Executive77782020004
    GITTINS, Jonathan Mark
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    BritishCeo75431680002
    HAY, James Brian
    Fairways
    81 Allington Road Newick
    BN8 4ND Lewes
    East Sussex
    Amministratore
    Fairways
    81 Allington Road Newick
    BN8 4ND Lewes
    East Sussex
    BritishChartered Accountant11163140001
    HENDERSON, John Iain
    12 Dale Street
    W4 2BL London
    Amministratore
    12 Dale Street
    W4 2BL London
    BritishChartered Accountant38376070001
    KOVAL, Kenneth Francis
    23 Rue Leon Lepage
    B1000 Brussels
    Belgium
    Amministratore
    23 Rue Leon Lepage
    B1000 Brussels
    Belgium
    AmericanFinance Director118262180001
    MCCANN, Anthony Joseph
    12 Phillimore Gardens
    W8 7QD London
    Amministratore
    12 Phillimore Gardens
    W8 7QD London
    BritishChief Executive20509810002
    PYWELL, Christopher Graham
    Highfield Farm Cobbs Lane
    Hough
    CW2 5JL Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Highfield Farm Cobbs Lane
    Hough
    CW2 5JL Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritishFinance Director37719690005
    SUTTON, Timothy James
    Holly Bank
    Queensway
    Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Holly Bank
    Queensway
    Knutsford
    Cheshire
    BritishFinance Director1278170001

    A.N.C. (NOTTINGHAM) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and fixed and floating security document
    Creato il 25 set 2001
    Consegnato il 04 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future moneys debts and liabilities due (including the guaranteed liabilities) owing or incurred by a chargor to any finance party (including the chargee as security trustee for the finance parties) under or in connection with any finance document (all terms as defined)
    Brevi particolari
    Including premises at unit 6 marston gate development site station rd brogborough milton keynes beds, f/h interest in premises on the south side of parkhouse road east bradwell newcastle under lyme t/no.SF245317, premises at unit 3 watchmoor point camberley, the parkland buildings k/a tangent point central way park royal london NW10 and unit 41 parkhouse industrial estate rosevale road newcastle under lyme staffs. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 09 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 09 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 08 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to an instrument dated 26TH may 1995 constituting £19,000,000 8 per cent secured loan stock 2004 to be issued by broomco (910) limited
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Montagu Equity Limitedas Agent for the Holders from Time to Time of the Stock
    Transazioni
    • 08 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 dic 1993
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 mag 1987
    Consegnato il 27 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 25 nov 1986
    Consegnato il 01 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The book debts & other debts due or owing to the company both present and future.
    Persone aventi diritto
    • A.N.C. Limited
    Transazioni
    • 01 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 28 set 1984
    Consegnato il 17 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's f/h or l/h property and the proceeds of sale thereof floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 29 apr 1982
    Consegnato il 06 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mag 1982Registrazione di un'ipoteca

    A.N.C. (NOTTINGHAM) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 giu 2012Data di scioglimento
    31 ago 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0