ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.

ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01624055
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    Royal Pavilion
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Hampshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CDS GROUP LTD.17 apr 199717 apr 1997
    CLINICAL DATA SYSTEMS GROUP LTD 20 dic 199420 dic 1994
    CLINICAL DATA SYSTEMS LIMITED23 mar 198223 mar 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di David William Hart Gray come segretario in data 31 mar 2013

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Gareth Antony Wilson come segretario in data 31 mar 2013

    2 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2012

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 mar 2013

    Stato del capitale al 01 mar 2013

    • Capitale: GBP 1,440.39
    SH01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    Risoluzioni

    Resolutions
    34 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Adrian Charles Stevens come amministratore in data 30 giu 2012

    2 pagineTM01

    legacy

    2 pagineMG02

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 giu 2012 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Adrian Charles Stevens il 12 set 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrea Fiumicelli il 12 set 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew James Edward Thomson il 12 set 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Gareth Antony Wilson il 12 set 2011

    2 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom in data 18 ago 2011

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT in data 05 ago 2011

    1 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Mr Gareth Antony Wilson come segretario

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Andrew James Edward Thomson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Mackay come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Howard Edelman come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177358100001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianCompany Director135619020001
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant147270780001
    ALTON, Richard
    The Old Bank House
    Windley
    DE56 2LP Belper
    Derbyshire
    Segretario
    The Old Bank House
    Windley
    DE56 2LP Belper
    Derbyshire
    British26776810002
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Segretario
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    AustralianCompany Secretary126124430005
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Segretario
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    WAINWRIGHT, Philip Eric
    11 Stanton Avenue
    DE56 1EE Belper
    Derbyshire
    Segretario
    11 Stanton Avenue
    DE56 1EE Belper
    Derbyshire
    British26620230001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Segretario
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    BritishDirector69575560002
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162049080001
    ALLEN, Christine Florence
    1 Bargate Close
    Bargate
    DE56 0TL Belper
    Derbyshire
    Amministratore
    1 Bargate Close
    Bargate
    DE56 0TL Belper
    Derbyshire
    BritishAdministrator26620250001
    ALLEN, David John
    Quarry Bungalow Duffield Bank
    Duffield
    DE56 4BG Belper
    Derbyshire
    Amministratore
    Quarry Bungalow Duffield Bank
    Duffield
    DE56 4BG Belper
    Derbyshire
    BritishManaging Director37312230002
    ALTON, Richard
    The Old Bank House
    Windley
    DE56 2LP Belper
    Derbyshire
    Amministratore
    The Old Bank House
    Windley
    DE56 2LP Belper
    Derbyshire
    BritishChartered Accountant26776810002
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Amministratore
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director125992970001
    CRYNE, Patrick
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    Amministratore
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    EnglandBritishDirector58894020001
    DICKENS, Roger Joseph
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector63562150001
    GARRINGTON, Stephen John
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    BritishOperations Director45513680001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Amministratore
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector97528710001
    GREEN, Patricia Gale
    Valley View Cross O The Hands
    Turnditch
    DE56 2LT Belper
    Derbyshire
    Amministratore
    Valley View Cross O The Hands
    Turnditch
    DE56 2LT Belper
    Derbyshire
    BritishSales Director26620270001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmericanCompany Director119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director44173560008
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director101025710001
    LODGE, Robin Wilfred Ian
    6 Chemin Du Vieux Motty
    Yens
    1169
    Switzerland
    Amministratore
    6 Chemin Du Vieux Motty
    Yens
    1169
    Switzerland
    SwitzerlandBritishCompany Director154369990002
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director178097680001
    MACKAY, James Gordon
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pogles Wood
    Widmoor
    HP10 0JG Wooburn Green
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishFinancial Director178097680001
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Amministratore
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritishCompany Director126777780001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director76964750002
    VINCENT, David
    38 Primley Park Avenue
    Alwoodley
    LS17 7HU Leeds
    Amministratore
    38 Primley Park Avenue
    Alwoodley
    LS17 7HU Leeds
    BritishChief Executive Officer45459550001
    WAINWRIGHT, Philip Eric
    11 Stanton Avenue
    DE56 1EE Belper
    Derbyshire
    Amministratore
    11 Stanton Avenue
    DE56 1EE Belper
    Derbyshire
    BritishChief Accountant & Secretary26620230001
    WHELAN, John
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    Amministratore
    26 Lynton Park Road
    SK8 6JA Cheadle Hulme
    Cheshire
    UkBritishFinance Director105872500001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    EnglandBritishDirector69575560002
    WILKINSON, Martin
    5 Primrose Drive
    OX26 3WP Bicester
    Oxfordshire
    Amministratore
    5 Primrose Drive
    OX26 3WP Bicester
    Oxfordshire
    BritishDevelopment Director74264310001

    ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 30 dic 2009
    Consegnato il 13 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of accession
    Creato il 27 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch, as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 24 ago 2006
    Consegnato il 31 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    Creato il 13 apr 2006
    Consegnato il 28 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 29 apr 2004
    Consegnato il 07 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any of the parent company's subsidiaries to the finance parties or any of them and such other banks or financial institutions under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Security Trustee
    Transazioni
    • 07 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Set-off agreement
    Creato il 30 gen 2003
    Consegnato il 19 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The companies agree that the bank may at any time and from time to time combine or consolidate all or any of the then existing accounts of the companies with all or any of the liabilities of the companies or any of them to the bank under the ancillary facilities and/or set-off and transfer any sum or sums standing to the credit of one or more of such accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of legal charge
    Creato il 27 ago 2002
    Consegnato il 07 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge over the managed service agreement between isoft laboratory systems limited and western health board dated 29/4/02 and the equipment and software being the subject of the managed service agreement.
    Persone aventi diritto
    • Ba/Ca Asset Finance Limited
    Transazioni
    • 07 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 lug 2002
    Consegnato il 20 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money,obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee and to the lenders (or any of them) in any currency under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including (I) suite 306,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (ii) suite 202,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (iii) units 2.01-2.05 faraday wharf aston science park,holt street,birmingham; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee
    Transazioni
    • 20 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 05 feb 2001
    Consegnato il 21 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under (I) an overdraft letter dated 5 february 2001, (ii) any letter or agreement amending,replacing,varying or extending the facilities available under the overdraft letter and (iii) any letter or agreement providing working capital or other ancillary facilities to the company; and all other money and liabilities expressed to be secured under the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 lug 1983
    Consegnato il 15 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and uncalled capital. With all trade and other fixtures and fittings, fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 13 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0