ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.
Panoramica
Nome della società | ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD. |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01624055 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.?
Indirizzo della sede legale | Royal Pavilion Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Hampshire United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CDS GROUP LTD. | 17 apr 1997 | 17 apr 1997 |
CLINICAL DATA SYSTEMS GROUP LTD | 20 dic 1994 | 20 dic 1994 |
CLINICAL DATA SYSTEMS LIMITED | 23 mar 1982 | 23 mar 1982 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di David William Hart Gray come segretario in data 31 mar 2013 | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gareth Antony Wilson come segretario in data 31 mar 2013 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2012 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata | 1 pagine | AD04 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 34 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Adrian Charles Stevens come amministratore in data 30 giu 2012 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | MG02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2011 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 giu 2012 al 31 mar 2012 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Adrian Charles Stevens il 12 set 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrea Fiumicelli il 12 set 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew James Edward Thomson il 12 set 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Gareth Antony Wilson il 12 set 2011 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Csc Computer Sciences International Ltd Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom in data 18 ago 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Isoft Group Plc Daventry Road Banbury Oxfordshire OX16 3JT in data 05 ago 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Nomina di Mr Gareth Antony Wilson come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew James Edward Thomson come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Mackay come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Howard Edelman come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD.?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAY, David William Hart | Segretario | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | British | 177358100001 | ||||||
FIUMICELLI, Andrea | Amministratore | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | Italy | Italian | Company Director | 135619020001 | ||||
THOMSON, Andrew James Edward | Amministratore | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 147270780001 | ||||
ALTON, Richard | Segretario | The Old Bank House Windley DE56 2LP Belper Derbyshire | British | 26776810002 | ||||||
EDELMAN, Howard Todd | Segretario | Elizabeth Bay Road 2011 Elizabeth Bay 84/108 Nsw Australia | Australian | Company Secretary | 126124430005 | |||||
HILL, Teifion Mark | Segretario | 59 Hill Top Avenue Cheadle Hulme SK8 7HZ Stockport Cheshire | British | 100105520001 | ||||||
WAINWRIGHT, Philip Eric | Segretario | 11 Stanton Avenue DE56 1EE Belper Derbyshire | British | 26620230001 | ||||||
WATERS, Paul Christopher | Segretario | The Old Vicarage High Street B50 4BQ Bidford On Avon Warwickshire | British | 67435560001 | ||||||
WHISTON, Timothy Andrew | Segretario | Boothshill Farm Booths Lane WA13 0PF Lymm Cheshire | British | Director | 69575560002 | |||||
WILSON, Gareth Antony | Segretario | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | 162049080001 | |||||||
ALLEN, Christine Florence | Amministratore | 1 Bargate Close Bargate DE56 0TL Belper Derbyshire | British | Administrator | 26620250001 | |||||
ALLEN, David John | Amministratore | Quarry Bungalow Duffield Bank Duffield DE56 4BG Belper Derbyshire | British | Managing Director | 37312230002 | |||||
ALTON, Richard | Amministratore | The Old Bank House Windley DE56 2LP Belper Derbyshire | British | Chartered Accountant | 26776810002 | |||||
COHEN, Gary Michael | Amministratore | 178 Hopetoun Avenue, Watsons Bay Nsw 2030 Australia | Australia | Australian | Company Director | 125992970001 | ||||
CRYNE, Patrick | Amministratore | The Tannery Town Lane SK14 6HQ Charlesworth Cheshire | England | British | Director | 58894020001 | ||||
DICKENS, Roger Joseph | Amministratore | 6 Woodbourne Road Edgbaston B15 3QH Birmingham West Midlands | British | Director | 63562150001 | |||||
GARRINGTON, Stephen John | Amministratore | 15 Chesterton Close Hunt End B97 5XS Redditch Worcestershire | British | Operations Director | 45513680001 | |||||
GRAHAM, Stephen Paul | Amministratore | Brackenridge Mereside Road WA16 6QR Mere Cheshire | United Kingdom | British | Director | 97528710001 | ||||
GREEN, Patricia Gale | Amministratore | Valley View Cross O The Hands Turnditch DE56 2LT Belper Derbyshire | British | Sales Director | 26620270001 | |||||
HENRY, William Patrick | Amministratore | 9 Grafton Road GL50 2ET Cheltenham Gloucestershire | England | American | Company Director | 119049370001 | ||||
JAMES, Gavin Keith, Mr. | Amministratore | Camelford Bradcutts Lane SL6 9AA Cookham Dean Berkshire | England | British | Finance Director | 44173560008 | ||||
KUMAR, Ravi | Amministratore | 14 Parkham Close Daisy Hill Westhaughton BL5 2GT Bolton Lancashire | British | Company Director | 101025710001 | |||||
LODGE, Robin Wilfred Ian | Amministratore | 6 Chemin Du Vieux Motty Yens 1169 Switzerland | Switzerland | British | Company Director | 154369990002 | ||||
MACKAY, James Gordon | Amministratore | Daventry Road OX16 3JT Banbury Isoft Group Plc Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 178097680001 | ||||
MACKAY, James Gordon | Amministratore | Pogles Wood Widmoor HP10 0JG Wooburn Green Buckinghamshire | United Kingdom | British | Financial Director | 178097680001 | ||||
RICHARDS, Paul | Amministratore | The Barn Green Lane South Newington OX15 4JH Banbury | United Kingdom | British | Company Director | 126777780001 | ||||
STEVENS, Adrian Charles | Amministratore | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | England | British | Company Director | 76964750002 | ||||
VINCENT, David | Amministratore | 38 Primley Park Avenue Alwoodley LS17 7HU Leeds | British | Chief Executive Officer | 45459550001 | |||||
WAINWRIGHT, Philip Eric | Amministratore | 11 Stanton Avenue DE56 1EE Belper Derbyshire | British | Chief Accountant & Secretary | 26620230001 | |||||
WHELAN, John | Amministratore | 26 Lynton Park Road SK8 6JA Cheadle Hulme Cheshire | Uk | British | Finance Director | 105872500001 | ||||
WHISTON, Timothy Andrew | Amministratore | Boothshill Farm Booths Lane WA13 0PF Lymm Cheshire | England | British | Director | 69575560002 | ||||
WILKINSON, Martin | Amministratore | 5 Primrose Drive OX26 3WP Bicester Oxfordshire | British | Development Director | 74264310001 |
ISOFT LABORATORY SYSTEMS LTD. ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Creato il 30 dic 2009 Consegnato il 13 gen 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A deed of accession | Creato il 27 nov 2007 Consegnato il 13 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each borrower as a borrower and from each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 24 ago 2006 Consegnato il 31 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003 | Creato il 13 apr 2006 Consegnato il 28 apr 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 29 apr 2004 Consegnato il 07 mag 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any of the parent company's subsidiaries to the finance parties or any of them and such other banks or financial institutions under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Set-off agreement | Creato il 30 gen 2003 Consegnato il 19 feb 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The companies agree that the bank may at any time and from time to time combine or consolidate all or any of the then existing accounts of the companies with all or any of the liabilities of the companies or any of them to the bank under the ancillary facilities and/or set-off and transfer any sum or sums standing to the credit of one or more of such accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of legal charge | Creato il 27 ago 2002 Consegnato il 07 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari First fixed charge over the managed service agreement between isoft laboratory systems limited and western health board dated 29/4/02 and the equipment and software being the subject of the managed service agreement. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 lug 2002 Consegnato il 20 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money,obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee and to the lenders (or any of them) in any currency under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Including (I) suite 306,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (ii) suite 202,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (iii) units 2.01-2.05 faraday wharf aston science park,holt street,birmingham; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture deed | Creato il 05 feb 2001 Consegnato il 21 feb 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under (I) an overdraft letter dated 5 february 2001, (ii) any letter or agreement amending,replacing,varying or extending the facilities available under the overdraft letter and (iii) any letter or agreement providing working capital or other ancillary facilities to the company; and all other money and liabilities expressed to be secured under the debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 04 lug 1983 Consegnato il 15 lug 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and uncalled capital. With all trade and other fixtures and fittings, fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0