VEGA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVEGA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01624247
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VEGA LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova VEGA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Kaba Ltd Lower Moor Way
    Tiverton Business Park
    EX16 6SS Tiverton
    Devon
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VEGA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GAROG LIMITED19 mag 198219 mag 1982
    PUSHPULL LIMITED24 mar 198224 mar 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di VEGA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per VEGA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 ago 2012

    Stato del capitale al 17 ago 2012

    • Capitale: GBP 405,000
    SH01

    Cessazione della carica di Peter Faerber come amministratore in data 09 dic 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Werner Stadelmann come amministratore in data 09 dic 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Alfred Bewick come amministratore in data 14 feb 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Stephen Charalambos Anoyrkatis come segretario in data 14 feb 2012

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Nigel Homer come segretario in data 14 feb 2012

    1 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2011

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 9 Eagle Park Eagle Park Drive Warrington Cheshire WA2 8JA in data 22 giu 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 giu 2010

    18 pagineAA

    Nomina di Mr Kurt Niederhauser come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Nigel Homer come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di David Ratcliffe come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Ratcliffe come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Paul Andrews come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Andrews come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 30 giu 2009

    17 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di VEGA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ANOYRKATIS, Stephen Charalambos
    Lower Moor Way
    EX16 6SS Tiverton
    C/O Kaba Ltd
    United Kingdom
    Segretario
    Lower Moor Way
    EX16 6SS Tiverton
    C/O Kaba Ltd
    United Kingdom
    168676820001
    BEWICK, Stephen Alfred
    Lower Moor Way
    Tiverton Business Park
    EX16 6SS Tiverton
    C/O Kaba Ltd
    Devon
    England
    Amministratore
    Lower Moor Way
    Tiverton Business Park
    EX16 6SS Tiverton
    C/O Kaba Ltd
    Devon
    England
    EnglandBritish122982330001
    NIEDERHAUSER, Kurt
    c/o Kaba Holding Ag
    Hofwisenstrasse 24
    8153 Rumlang
    24
    Switzerland
    Amministratore
    c/o Kaba Holding Ag
    Hofwisenstrasse 24
    8153 Rumlang
    24
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss153389790001
    ANDREWS, Paul
    15 The Knotches
    Seifton Batch
    SY7 9LQ Craven Arms
    Shropshire
    Segretario
    15 The Knotches
    Seifton Batch
    SY7 9LQ Craven Arms
    Shropshire
    British111433100002
    BRINDLEY, Peter Henry
    1 Albany Close
    West Bergholt
    CO6 3LE Colchester
    Essex
    Segretario
    1 Albany Close
    West Bergholt
    CO6 3LE Colchester
    Essex
    British11552730001
    FARMER, Owen Michael
    17 Kingsclear Park
    GU15 2LS Camberley
    Surrey
    Segretario
    17 Kingsclear Park
    GU15 2LS Camberley
    Surrey
    British57247560001
    HOMER, Nigel
    Lower Moor Way
    Tiverton Business Park
    EX16 6SS Tiverton
    C/O Kaba Ltd
    Devon
    England
    Segretario
    Lower Moor Way
    Tiverton Business Park
    EX16 6SS Tiverton
    C/O Kaba Ltd
    Devon
    England
    153563800001
    KING, Andrew Mark
    23 Yew Croft Avenue
    Harborne
    B17 9TR Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    23 Yew Croft Avenue
    Harborne
    B17 9TR Birmingham
    West Midlands
    British96568110001
    KINSEY, David William
    7 Nares Close
    Old Hall
    WA5 5QT Warrington
    Cheshire
    Segretario
    7 Nares Close
    Old Hall
    WA5 5QT Warrington
    Cheshire
    British16572780001
    MCGORRIGAN, John
    16 Reedfield
    Bamber Bridge
    PR5 8HT Preston
    Lancashire
    Segretario
    16 Reedfield
    Bamber Bridge
    PR5 8HT Preston
    Lancashire
    British17615910001
    RATCLIFFE, David Morley
    3 Woodberry Avenue
    North Harrow
    HA2 6AU Harrow
    Middlesex
    Segretario
    3 Woodberry Avenue
    North Harrow
    HA2 6AU Harrow
    Middlesex
    British15520590001
    ANDREWS, Paul
    15 The Knotches
    Seifton Batch
    SY7 9LQ Craven Arms
    Shropshire
    Amministratore
    15 The Knotches
    Seifton Batch
    SY7 9LQ Craven Arms
    Shropshire
    EnglandBritish111433100002
    BANDIXEN, Sonke
    Langweidstr 2
    8620 Wetzikon
    Zh
    Switzerland
    Amministratore
    Langweidstr 2
    8620 Wetzikon
    Zh
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss51681380001
    COYNE, Anthony Edward
    34 Shipton Close
    Great Sankey
    WA5 5XS Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    34 Shipton Close
    Great Sankey
    WA5 5XS Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish68413490001
    DAVIES, David
    Ribendell
    39 Woodlands Drive
    CW4 8JH Goostrey
    Cheshire
    Amministratore
    Ribendell
    39 Woodlands Drive
    CW4 8JH Goostrey
    Cheshire
    British72615990001
    DELF, Peter James
    Park View
    Winchmore Hill
    N21 1QX London
    16
    Amministratore
    Park View
    Winchmore Hill
    N21 1QX London
    16
    United KingdomBritish2616750001
    FAERBER, Peter
    Huntsmans Close
    WV16 5BE Bridgnorth
    13
    Shropshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Huntsmans Close
    WV16 5BE Bridgnorth
    13
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomSwiss95312870002
    FARMER, Owen Michael
    17 Kingsclear Park
    GU15 2LS Camberley
    Surrey
    Amministratore
    17 Kingsclear Park
    GU15 2LS Camberley
    Surrey
    EnglandBritish57247560001
    GIDDINGS, Barry Stephen
    2 Hunters Close
    Chartridge Lane
    HP5 2RJ Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Hunters Close
    Chartridge Lane
    HP5 2RJ Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish36687570001
    HARRISON, Kenneth Arthur
    156 Oldfield Road
    WA14 4BJ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    156 Oldfield Road
    WA14 4BJ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish69700001
    HOLLOWAY, David John
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish66183100001
    IRWIN, John David
    Seeleys Orchard 39 Penn Road
    HP9 2LN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Seeleys Orchard 39 Penn Road
    HP9 2LN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish59361420001
    JOWICZ, John Peter
    5 Rushes Mill Foxglove Meadows
    Pelsall
    WS3 4QU Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    5 Rushes Mill Foxglove Meadows
    Pelsall
    WS3 4QU Walsall
    West Midlands
    British74250200001
    KEABLE, Alan James
    1 Heron Avenue
    SK16 5QB Dukinfield
    Cheshire
    Amministratore
    1 Heron Avenue
    SK16 5QB Dukinfield
    Cheshire
    EnglandBritish53512330001
    KERRISON, Bernard Edward
    15 Meadowcroft
    CM24 8LD Stansted
    Essex
    Amministratore
    15 Meadowcroft
    CM24 8LD Stansted
    Essex
    British7387900001
    KINSEY, David William
    7 Nares Close
    Old Hall
    WA5 5QT Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    7 Nares Close
    Old Hall
    WA5 5QT Warrington
    Cheshire
    British16572780001
    MCGORRIGAN, John
    16 Reedfield
    Bamber Bridge
    PR5 8HT Preston
    Lancashire
    Amministratore
    16 Reedfield
    Bamber Bridge
    PR5 8HT Preston
    Lancashire
    British17615910001
    MOORE, David Donald
    67 Vincent Close
    Old Hall
    WA5 5TB Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    67 Vincent Close
    Old Hall
    WA5 5TB Warrington
    Cheshire
    British47469350001
    RATCLIFFE, David Morley
    3 Woodberry Avenue
    North Harrow
    HA2 6AU Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    3 Woodberry Avenue
    North Harrow
    HA2 6AU Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish15520590001
    ROGERS, David
    Rose Cottage
    Church Eaton
    ST20 0AX Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    Rose Cottage
    Church Eaton
    ST20 0AX Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish34813700001
    RYECROFT, Gary Andrew
    81 Low Ash Drive
    BD18 1JQ Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    81 Low Ash Drive
    BD18 1JQ Shipley
    West Yorkshire
    British62623380001
    STADELMANN, Werner, Dr
    Solar Strasse 7
    Schindellegi
    Ch 8834
    Switzerland
    Amministratore
    Solar Strasse 7
    Schindellegi
    Ch 8834
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss65301010001
    SWALLOW, Jake Brangwyn Sheridan
    Brickhill House
    North Oakley
    RG26 5TT Tadley
    Hampshire
    Amministratore
    Brickhill House
    North Oakley
    RG26 5TT Tadley
    Hampshire
    EnglandBritish1483180001
    WHITTLES, Peter Thomas
    58 Woodlands Drive
    Thelwall
    WA4 2JL Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    58 Woodlands Drive
    Thelwall
    WA4 2JL Warrington
    Cheshire
    British53512100001

    VEGA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture between the chargor kaba holdings ag as the parent and the security agent
    Creato il 09 apr 2001
    Consegnato il 20 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities due owing or incurred to the secured parties (or any of them) (as defined) by the obligors (as defined) under the finance documents (or any of them) (as defined) on any account whatsoever pursuant to any of the finance documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag Zurich as Security Agent and Trustee for Itself and the Othersecured Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 20 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 lug 1999
    Consegnato il 16 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 apr 1999
    Consegnato il 13 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £25,500.00 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/Hold premises known as land/blds at leacroft rd,birchwood,warrington WA3 6PJ.
    Persone aventi diritto
    • Concord PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee
    Creato il 06 gen 1992
    Consegnato il 17 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time standing to the credit of the companys account with the bank of whatever nature and in whatever currency and lien on all securities and any other property of the company held by the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 gen 1992
    Consegnato il 17 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 giu 1991
    Consegnato il 12 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 (ref 449) for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0