BABCOCK TRANSMISSION LIMITED

BABCOCK TRANSMISSION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBABCOCK TRANSMISSION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01624747
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?

    • Altre attività di ingegneria (71129) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PETERHOUSE11 LIMITED24 feb 200624 feb 2006
    GORSELINE LIMITED21 gen 199121 gen 1991
    GREENBANK GORSELINE LIMITED08 dic 198708 dic 1987
    GORSELINE LIMITED25 mar 198225 mar 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 18 dic 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas James William Borrett il 11 gen 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas James William Borrett il 13 dic 2016

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Iain Stuart Urquhart il 23 ago 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 16 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 giu 2016

    Stato del capitale al 16 giu 2016

    • Capitale: GBP 851,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 22 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 lug 2015

    Stato del capitale al 27 lug 2015

    • Capitale: GBP 851,000
    SH01

    Nomina di Mr Nicholas James William Borrett come amministratore in data 16 giu 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Lloyd Rogers come amministratore in data 16 giu 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Iain Stuart Urquhart come amministratore in data 16 giu 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Franco Martinelli come amministratore in data 16 giu 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    4 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BABCOCK CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Segretario
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3133134
    173822100001
    BORRETT, Nicholas James William
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Company Secretary And General Counsel171010990002
    URQUHART, Iain Stuart
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United KingdomBritishDirector104722420003
    BILLIALD, Stanley Alan Royall
    Hyde Cottage
    Hyde Lane Churt
    GU10 2LP Farnham
    Surrey
    Segretario
    Hyde Cottage
    Hyde Lane Churt
    GU10 2LP Farnham
    Surrey
    Other35839210001
    COLBECK, Christopher John Ashton
    241 Wellsway
    BA2 4RZ Bath
    Avon
    Segretario
    241 Wellsway
    BA2 4RZ Bath
    Avon
    British8297180001
    DODSON, Mark Warwick
    Yandale Carrhouse Road
    Belton
    DN9 1PG Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Yandale Carrhouse Road
    Belton
    DN9 1PG Doncaster
    South Yorkshire
    BritishCompany Accountant54927320001
    PALMER, Peter Edward
    Hill Top Farm
    Asenby
    YO7 3QN Thirsk
    North Yorkshire
    Segretario
    Hill Top Farm
    Asenby
    YO7 3QN Thirsk
    North Yorkshire
    British21105820001
    PAYNE, Eunice Ivy
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    Babcock International Group Plc
    England
    England
    Segretario
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    Babcock International Group Plc
    England
    England
    171356310001
    TELLER, Valerie Francine Anne
    Pinemartin Close
    NW2 6YY London
    17 Badger Court
    Segretario
    Pinemartin Close
    NW2 6YY London
    17 Badger Court
    British139336240001
    WOOLLHEAD, John Andrew
    23 Ruxley Ridge
    Claygate
    KT10 0HZ Esher
    Surrey
    Segretario
    23 Ruxley Ridge
    Claygate
    KT10 0HZ Esher
    Surrey
    BritishCompany Secretary13072060002
    BEST, David Martin
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector47892490001
    BRAMWELL, David Matthew
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector4250980001
    CAMPBELL, Edward
    Trouville Pontefract Road
    Hemsworth
    WF9 5LW Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Trouville Pontefract Road
    Hemsworth
    WF9 5LW Pontefract
    West Yorkshire
    BritishCompany Director2609820001
    COLBECK, Christopher John Ashton
    241 Wellsway
    BA2 4RZ Bath
    Avon
    Amministratore
    241 Wellsway
    BA2 4RZ Bath
    Avon
    BritishCompany Director8297180001
    CRAIGHILL, Martin Arthur
    Fern Cottage
    Carr House Road Belton
    DN9 1PG Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fern Cottage
    Carr House Road Belton
    DN9 1PG Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishDrawing Office Manager33311140002
    DUNN, Steven John
    Dunolme 31 Poppyfields Way
    Branton
    DN3 3UA Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Dunolme 31 Poppyfields Way
    Branton
    DN3 3UA Doncaster
    South Yorkshire
    BritishContracts Manager74788740001
    ELLIS, Dean Roger
    6 Cookridge Drive
    Hatfield
    DN7 6JE Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    6 Cookridge Drive
    Hatfield
    DN7 6JE Doncaster
    South Yorkshire
    BritishSystems Manager32313120001
    FAWCETT, Wayne
    17 Broughton Avenue
    DN5 9QS Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    17 Broughton Avenue
    DN5 9QS Doncaster
    South Yorkshire
    BritishManager52314410001
    JACKSON, David James
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector62867720010
    JANICKI, Antony Michael Peter
    17 Deanhead Drive
    Owlthorpe
    S20 6SF Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    17 Deanhead Drive
    Owlthorpe
    S20 6SF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishManager191037310001
    MARTINELLI, Franco
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    C/O Babcock International Group Plc
    United Kingdom
    Amministratore
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    C/O Babcock International Group Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant85507440001
    PALMER, Peter Edward
    Hill Top Farm
    Asenby
    YO7 3QN Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    Hill Top Farm
    Asenby
    YO7 3QN Thirsk
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector21105820001
    QUIRK, Bernard
    23 Richmond Way
    Garforth
    LS25 1HT Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    23 Richmond Way
    Garforth
    LS25 1HT Leeds
    West Yorkshire
    BritishTechnical Manager32313140001
    RAVEN, Simon Lee
    6 Cookridge Drive
    DN7 6JE Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    6 Cookridge Drive
    DN7 6JE Doncaster
    South Yorkshire
    BritishOperations Manager74788710001
    ROBERTSON, Alan Robert
    Foss Dyke Farm
    Red House Lane Moor Monkton
    Y026 8JG York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Foss Dyke Farm
    Red House Lane Moor Monkton
    Y026 8JG York
    North Yorkshire
    BritishChief Executive63758950006
    ROBINSON, Colin Sidney
    The Manor
    Bradninch
    EX5 4NW Exeter
    Devon
    Amministratore
    The Manor
    Bradninch
    EX5 4NW Exeter
    Devon
    BritishCompany Director8297200001
    ROGERS, Peter Lloyd
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    C/O Babcock International Group Plc
    United Kingdom
    Amministratore
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    C/O Babcock International Group Plc
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive49805580003
    SWANN, William Alan
    Dunley Lodge
    RG25 1DH Odiham
    Hampshire
    Amministratore
    Dunley Lodge
    RG25 1DH Odiham
    Hampshire
    BritishDirector22997210001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3111794
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BABCOCK TRANSMISSION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 11 dic 1998
    Consegnato il 12 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as 16 high street hatfield DN7 6RY title number SYK324416. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 dic 1998
    Consegnato il 11 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 nov 1997
    Consegnato il 20 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 29 ago 1997
    Consegnato il 30 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £17,786.25 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Frist fixed charge over survey station comprising geometer 610 with keypad tripod serial number 10746 2XGROUND micro system serial no MC4562 microcorr 4 dual radio correlator microcorr 4 single radion correlator serial no MC4473E.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 30 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 dic 1995
    Consegnato il 12 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture
    Creato il 02 dic 1994
    Consegnato il 17 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee of even date
    Brevi particolari
    Including 16 high street hatfield doncaster. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Ventures Investments Limited
    Transazioni
    • 17 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture
    Creato il 02 dic 1994
    Consegnato il 17 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee of even date
    Brevi particolari
    Including the properties located at 16 high street hatfield doncaster t/n 324416. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Nominees Limited
    Transazioni
    • 17 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 feb 1993
    Consegnato il 19 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    16 high street hatfield doncaster south yorkshire and/or the proceeds of sale thereof title no: SYK324416. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 feb 1993
    Consegnato il 19 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 feb 1993
    Consegnato il 12 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (For full details see form 395 tc ref: M412C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Nominees Limited
    Transazioni
    • 12 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 feb 1993
    Consegnato il 12 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (For full details see form 395 tc ref: M411C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Limited
    Transazioni
    • 12 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 giu 1992
    Consegnato il 30 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being 16 high street hatfield doncaster south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 feb 1992
    Consegnato il 11 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 lug 1985
    Consegnato il 05 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0