BABCOCK TRANSMISSION LIMITED
Panoramica
Nome della società | BABCOCK TRANSMISSION LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01624747 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?
- Altre attività di ingegneria (71129) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 33 Wigmore Street W1U 1QX London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PETERHOUSE11 LIMITED | 24 feb 2006 | 24 feb 2006 |
GORSELINE LIMITED | 21 gen 1991 | 21 gen 1991 |
GREENBANK GORSELINE LIMITED | 08 dic 1987 | 08 dic 1987 |
GORSELINE LIMITED | 25 mar 1982 | 25 mar 1982 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 18 dic 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas James William Borrett il 11 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas James William Borrett il 13 dic 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Iain Stuart Urquhart il 23 ago 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 lug 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Nicholas James William Borrett come amministratore in data 16 giu 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Lloyd Rogers come amministratore in data 16 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Iain Stuart Urquhart come amministratore in data 16 giu 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Franco Martinelli come amministratore in data 16 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABCOCK CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Segretario | Wigmore Street W1U 1QX London 33 United Kingdom |
| 173822100001 | ||||||||||
BORRETT, Nicholas James William | Amministratore | Wigmore Street W1U 1QX London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Group Company Secretary And General Counsel | 171010990002 | ||||||||
URQUHART, Iain Stuart | Amministratore | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | United Kingdom | British | Director | 104722420003 | ||||||||
BILLIALD, Stanley Alan Royall | Segretario | Hyde Cottage Hyde Lane Churt GU10 2LP Farnham Surrey | Other | 35839210001 | ||||||||||
COLBECK, Christopher John Ashton | Segretario | 241 Wellsway BA2 4RZ Bath Avon | British | 8297180001 | ||||||||||
DODSON, Mark Warwick | Segretario | Yandale Carrhouse Road Belton DN9 1PG Doncaster South Yorkshire | British | Company Accountant | 54927320001 | |||||||||
PALMER, Peter Edward | Segretario | Hill Top Farm Asenby YO7 3QN Thirsk North Yorkshire | British | 21105820001 | ||||||||||
PAYNE, Eunice Ivy | Segretario | 33 Wigmore Street W1U 1QX London Babcock International Group Plc England England | 171356310001 | |||||||||||
TELLER, Valerie Francine Anne | Segretario | Pinemartin Close NW2 6YY London 17 Badger Court | British | 139336240001 | ||||||||||
WOOLLHEAD, John Andrew | Segretario | 23 Ruxley Ridge Claygate KT10 0HZ Esher Surrey | British | Company Secretary | 13072060002 | |||||||||
BEST, David Martin | Amministratore | 34 Vicarage Meadows WF14 9JL Mirfield West Yorkshire | England | British | Director | 47892490001 | ||||||||
BRAMWELL, David Matthew | Amministratore | Woodlands 2a Woodland Rise WF2 9DL Wakefield West Yorkshire | England | British | Director | 4250980001 | ||||||||
CAMPBELL, Edward | Amministratore | Trouville Pontefract Road Hemsworth WF9 5LW Pontefract West Yorkshire | British | Company Director | 2609820001 | |||||||||
COLBECK, Christopher John Ashton | Amministratore | 241 Wellsway BA2 4RZ Bath Avon | British | Company Director | 8297180001 | |||||||||
CRAIGHILL, Martin Arthur | Amministratore | Fern Cottage Carr House Road Belton DN9 1PG Doncaster South Yorkshire | England | British | Drawing Office Manager | 33311140002 | ||||||||
DUNN, Steven John | Amministratore | Dunolme 31 Poppyfields Way Branton DN3 3UA Doncaster South Yorkshire | British | Contracts Manager | 74788740001 | |||||||||
ELLIS, Dean Roger | Amministratore | 6 Cookridge Drive Hatfield DN7 6JE Doncaster South Yorkshire | British | Systems Manager | 32313120001 | |||||||||
FAWCETT, Wayne | Amministratore | 17 Broughton Avenue DN5 9QS Doncaster South Yorkshire | British | Manager | 52314410001 | |||||||||
JACKSON, David James | Amministratore | 10 Stone Rings Close HG2 9HZ Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 62867720010 | ||||||||
JANICKI, Antony Michael Peter | Amministratore | 17 Deanhead Drive Owlthorpe S20 6SF Sheffield South Yorkshire | England | British | Manager | 191037310001 | ||||||||
MARTINELLI, Franco | Amministratore | 33 Wigmore Street W1U 1QX London C/O Babcock International Group Plc United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 85507440001 | ||||||||
PALMER, Peter Edward | Amministratore | Hill Top Farm Asenby YO7 3QN Thirsk North Yorkshire | England | British | Director | 21105820001 | ||||||||
QUIRK, Bernard | Amministratore | 23 Richmond Way Garforth LS25 1HT Leeds West Yorkshire | British | Technical Manager | 32313140001 | |||||||||
RAVEN, Simon Lee | Amministratore | 6 Cookridge Drive DN7 6JE Doncaster South Yorkshire | British | Operations Manager | 74788710001 | |||||||||
ROBERTSON, Alan Robert | Amministratore | Foss Dyke Farm Red House Lane Moor Monkton Y026 8JG York North Yorkshire | British | Chief Executive | 63758950006 | |||||||||
ROBINSON, Colin Sidney | Amministratore | The Manor Bradninch EX5 4NW Exeter Devon | British | Company Director | 8297200001 | |||||||||
ROGERS, Peter Lloyd | Amministratore | 33 Wigmore Street W1U 1QX London C/O Babcock International Group Plc United Kingdom | England | British | Chief Executive | 49805580003 | ||||||||
SWANN, William Alan | Amministratore | Dunley Lodge RG25 1DH Odiham Hampshire | British | Director | 22997210001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BABCOCK TRANSMISSION LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterhouse6 (Ietg) Limited | 06 apr 2016 | Wigmore Street W1U 1QX London 33 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
BABCOCK TRANSMISSION LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 11 dic 1998 Consegnato il 12 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The property known as 16 high street hatfield DN7 6RY title number SYK324416. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 11 dic 1998 Consegnato il 11 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 nov 1997 Consegnato il 20 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed charge | Creato il 29 ago 1997 Consegnato il 30 ago 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £17,786.25 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Frist fixed charge over survey station comprising geometer 610 with keypad tripod serial number 10746 2XGROUND micro system serial no MC4562 microcorr 4 dual radio correlator microcorr 4 single radion correlator serial no MC4473E. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 04 dic 1995 Consegnato il 12 dic 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of debenture | Creato il 02 dic 1994 Consegnato il 17 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee of even date | |
Brevi particolari Including 16 high street hatfield doncaster. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of debenture | Creato il 02 dic 1994 Consegnato il 17 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee of even date | |
Brevi particolari Including the properties located at 16 high street hatfield doncaster t/n 324416. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 05 feb 1993 Consegnato il 19 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 16 high street hatfield doncaster south yorkshire and/or the proceeds of sale thereof title no: SYK324416. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 05 feb 1993 Consegnato il 19 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 05 feb 1993 Consegnato il 12 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (For full details see form 395 tc ref: M412C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 05 feb 1993 Consegnato il 12 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (For full details see form 395 tc ref: M411C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 giu 1992 Consegnato il 30 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a or being 16 high street hatfield doncaster south yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 05 feb 1992 Consegnato il 11 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (See 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 24 lug 1985 Consegnato il 05 ago 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0