COMTEC COMPUTER TRAINING LTD

COMTEC COMPUTER TRAINING LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOMTEC COMPUTER TRAINING LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01625176
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COMTEC COMPUTER TRAINING LTD?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova COMTEC COMPUTER TRAINING LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Dawson House
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COMTEC COMPUTER TRAINING LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COMTEC COMPUTER CAREERS LIMITED 29 mar 198229 mar 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di COMTEC COMPUTER TRAINING LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per COMTEC COMPUTER TRAINING LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Bath Place Rivington Street London EC2A 3DR a Dawson House 5 Jewry Street London EC3N 2EX in data 15 apr 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 set 2015

    Stato del capitale al 22 set 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Nomina di Mr Roger Harold Antony come amministratore in data 30 giu 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Roger Harold Antony come segretario in data 30 giu 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Alastair John Lomond Woolley come segretario in data 30 giu 2015

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Alastair John Lomond Woolley come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 11 Golden Square London W1F 9JB England a 2 Bath Place Rivington Street London EC2A 3DR in data 09 dic 2014

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Wimbledon Bridge House 1 Hartfield Road C/O Parity Group Plc First Floor, 1 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3RU a 11 Golden Square London W1F 9JB in data 25 set 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 set 2014

    Stato del capitale al 01 set 2014

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 set 2013

    Stato del capitale al 16 set 2013

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Alastair John Lomond Woolley come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Ian Ketchin come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di COMTEC COMPUTER TRAINING LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ANTONY, Roger Harold
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    Segretario
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    199050880001
    ANTONY, Roger Harold
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    Amministratore
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    EnglandBritish199013040001
    CAUDLE, Charles Hugh
    2 Sandall Road
    W5 1JD London
    Segretario
    2 Sandall Road
    W5 1JD London
    British6363270001
    CONNER, Eileen
    1 Kipling Drive
    SW19 1TJ Wimbledon
    Segretario
    1 Kipling Drive
    SW19 1TJ Wimbledon
    British89546940001
    KETCHIN, Ian Malcolm
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    Segretario
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    British93777900002
    LEYSHON, Alison Jane
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    Segretario
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    British65584930003
    NOLAN, Cheryl
    97 Bailey Bridge Road
    CM7 5TS Braintree
    Essex
    Segretario
    97 Bailey Bridge Road
    CM7 5TS Braintree
    Essex
    British104488100003
    WOOLLEY, Alastair John Lomond
    Bath Place
    Rivington Street
    EC2A 3DR London
    2
    England
    Segretario
    Bath Place
    Rivington Street
    EC2A 3DR London
    2
    England
    159199300001
    CAUDLE, Charles Hugh
    2 Sandall Road
    W5 1JD London
    Amministratore
    2 Sandall Road
    W5 1JD London
    British6363270001
    CAUDLE, Valda Constance Rose
    27 Braund Avenue
    UB6 9JG Greenford
    Middlesex
    Amministratore
    27 Braund Avenue
    UB6 9JG Greenford
    Middlesex
    British16497490001
    COWLES, Victor Philip Pomeroy
    Private Bag 112
    1685 Midrand
    Gayteng
    South Africa
    Amministratore
    Private Bag 112
    1685 Midrand
    Gayteng
    South Africa
    South African62221140001
    HOPKINS, Anthony
    74 Brompton Park Crescent
    SW6 1SP London
    Amministratore
    74 Brompton Park Crescent
    SW6 1SP London
    British69724110002
    HUGHES, John Llewellyn Mostyn
    Albion Riverside
    8 Hester Road
    SW11 4AR London
    C77
    Amministratore
    Albion Riverside
    8 Hester Road
    SW11 4AR London
    C77
    UkBritish104248860001
    JENNINGS, Keith Murray
    25 Jacaranda House
    Woburn Hill Park
    KT15 2NZ Addlestone
    Surrey
    Amministratore
    25 Jacaranda House
    Woburn Hill Park
    KT15 2NZ Addlestone
    Surrey
    British76560510001
    JOUBERT, Pierre
    4a Waterfall Road
    21293 Westcliff
    Gauteng
    South Africa
    Amministratore
    4a Waterfall Road
    21293 Westcliff
    Gauteng
    South Africa
    South African62221180001
    KETCHIN, Ian Malcolm
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    Amministratore
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    EnglandBritish93777900002
    LEYSHON, Alison Jane
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    Amministratore
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    British65584930003
    MCLEOD, Bruce Robert
    1/118 Muswell Hill Road
    N10 3JD London
    Amministratore
    1/118 Muswell Hill Road
    N10 3JD London
    New Zealander62567030003
    MILLER, Ian Kenneth
    4234 Lomo Alto Court
    Dallas
    Tx75219
    Usa
    Amministratore
    4234 Lomo Alto Court
    Dallas
    Tx75219
    Usa
    United KingdomScottish89546660001
    O'DRISCOLL, Ian
    Two Goods Farm
    Moorside
    DT10 1HQ Marnhull
    Dorset
    Amministratore
    Two Goods Farm
    Moorside
    DT10 1HQ Marnhull
    Dorset
    British68202110001
    WELCH, Alwyn Frank
    Coniston Farnham Lane
    GU27 1EZ Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Coniston Farnham Lane
    GU27 1EZ Haslemere
    Surrey
    EnglandBritish56811010001
    WOOLLEY, Alastair John Lomond
    Bath Place
    Rivington Street
    EC2A 3DR London
    2
    England
    Amministratore
    Bath Place
    Rivington Street
    EC2A 3DR London
    2
    England
    United KingdomBritish89506550002

    Chi sono le persone con controllo significativo di COMTEC COMPUTER TRAINING LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    06 apr 2016
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies House Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2377956
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    COMTEC COMPUTER TRAINING LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 8TH july 1999 and
    Creato il 18 mar 2003
    Consegnato il 26 mar 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 8TH july 1999
    Creato il 19 giu 2002
    Consegnato il 25 giu 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 17 giu 1994
    Consegnato il 22 giu 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 36/44 tabernacle street l/b of islington t/n LN192154 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 giu 1994
    Consegnato il 13 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 giu 1994
    Consegnato il 13 giu 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 6 bow street birmingham and land k/a 7-12 bow street birmingham t/n's WM498476 and WM440124 and/or the proceeeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental legal charge
    Creato il 01 ago 1991
    Consegnato il 20 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a part of 9 cavendish square, london W1 as described in a lease dated 1/8/91.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC.
    Transazioni
    • 20 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 05 mar 1991
    Consegnato il 07 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & florating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 02 ago 1989
    Consegnato il 07 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the motwad limitied to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    L/H property k/a 33 queen ann street london and l/h k/a 9 cavendish square london W11 together in all cuses with all buildings and fixtures and stockeing trade, work-in-progress. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 mag 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 19 set 1983
    Consegnato il 21 set 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1983Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 03 ago 1983
    Consegnato il 09 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1983Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0