SSEJ LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSSEJ LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01625376
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SSEJ LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova SSEJ LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6 Coronet Way
    Centenary Park Eccles
    M50 1RE Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SSEJ LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MONITOR ENVIRONMENTAL CONSULTANTS LIMITED19 dic 199619 dic 1996
    CLAYTON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS LIMITED01 gen 199101 gen 1991
    CLAYTON BOSTOCK HILL & RIGBY LIMITED13 apr 198813 apr 1988
    BOSTOCK HILL & RIGBY LIMITED20 ago 198220 ago 1982
    DRUMCARD LIMITED29 mar 198229 mar 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di SSEJ LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per SSEJ LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    2 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    2 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    2 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    2 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    5 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    12 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Deliberazione elettiva

    ELRES

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Deliberazione elettiva

    ELRES

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Deliberazione elettiva

    ELRES

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di SSEJ LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURNETT, Aileen Ethra Murray
    Petersmuir Road
    East Saltoun
    EH34 5EB Edinburgh
    Farragon
    East Lothian
    Segretario
    Petersmuir Road
    East Saltoun
    EH34 5EB Edinburgh
    Farragon
    East Lothian
    British135320140001
    WILLIAMS, James Scott
    The Grange Meadow Lane
    Woodhouses
    DE13 8NP Yoxall
    Staffordshire
    Amministratore
    The Grange Meadow Lane
    Woodhouses
    DE13 8NP Yoxall
    Staffordshire
    United KingdomBritish5664100007
    CUMMINGS, John Alan
    The Rosary
    Long Marston
    CV37 8RG Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Rosary
    Long Marston
    CV37 8RG Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British80054340001
    CUNLIFFE, Peter Robin
    23 Arley Road
    B91 1NJ Solihull
    West Midlands
    Segretario
    23 Arley Road
    B91 1NJ Solihull
    West Midlands
    British15717470002
    GRIME, John Roland
    Cerne Abbas 247 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 3DP Stockport
    Cheshire
    Segretario
    Cerne Abbas 247 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 3DP Stockport
    Cheshire
    British39112420001
    SMITH, Michael Alan
    68 Bridgewater Road
    Northchurch
    HP4 1LB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    68 Bridgewater Road
    Northchurch
    HP4 1LB Berkhamsted
    Hertfordshire
    British56298410001
    WILLIAMS, James Scott
    The Grange Meadow Lane
    Woodhouses
    DE13 8NP Yoxall
    Staffordshire
    Segretario
    The Grange Meadow Lane
    Woodhouses
    DE13 8NP Yoxall
    Staffordshire
    British5664100007
    CARGILL, James Donald
    76 Burntwood Road
    Hammerwich
    WS7 0JW Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    76 Burntwood Road
    Hammerwich
    WS7 0JW Walsall
    West Midlands
    British7411100001
    COGGAN, Colin Edgar
    8 Ollison Drive
    Streetly
    B74 3DZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    8 Ollison Drive
    Streetly
    B74 3DZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British33798290002
    CUMMINGS, John Alan
    The Rosary
    Long Marston
    CV37 8RG Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    The Rosary
    Long Marston
    CV37 8RG Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish80054340001
    ELLIS, Anthony Clive, Dr
    Plot 26 Shannon
    Wilnecote
    B77 1NE Tamworth
    Staffs
    Amministratore
    Plot 26 Shannon
    Wilnecote
    B77 1NE Tamworth
    Staffs
    British45000440001
    GRIFFITHS, Neil Malcolm
    21 Carlton Avenue
    Streetly
    B74 3JF Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    21 Carlton Avenue
    Streetly
    B74 3JF Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish5664080001
    HARRIS, Mary Rose, Dr
    37 Rowley Bank
    ST17 9BA Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    37 Rowley Bank
    ST17 9BA Stafford
    Staffordshire
    EnglandBritish65172920001
    HICKS, Andrew James
    8 Hunters Park
    HP4 2PT Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Hunters Park
    HP4 2PT Berkhamsted
    Hertfordshire
    British33701880001
    KOWALSKI, Thomas Paul
    20555 Lincoln Hills Court
    Beverly Hills
    Michigan
    Usa
    Amministratore
    20555 Lincoln Hills Court
    Beverly Hills
    Michigan
    Usa
    American35139180001
    PATERSON, Elizabeth Ann
    8 David House 142 Court Oak Road
    B17 9AB Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    8 David House 142 Court Oak Road
    B17 9AB Birmingham
    West Midlands
    British45370530001
    PYETT, Nicholas John
    20861 Dundee Drive
    Novi
    Michan 78375
    Usa
    Amministratore
    20861 Dundee Drive
    Novi
    Michan 78375
    Usa
    Us30921690002
    SMITH, Michael Alan
    68 Bridgewater Road
    Northchurch
    HP4 1LB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    68 Bridgewater Road
    Northchurch
    HP4 1LB Berkhamsted
    Hertfordshire
    British56298410001
    STEVENS, Robert Alan
    4 Aragon Drive
    CV34 6LR Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    4 Aragon Drive
    CV34 6LR Warwick
    Warwickshire
    British53641540001
    THOMAS, William Morgan
    3 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    3 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish7411110001
    UHLER, Robert George
    4550 Ponte Verda Drive
    FOREIGN Marietta
    Ga 30067
    Usa
    Amministratore
    4550 Ponte Verda Drive
    FOREIGN Marietta
    Ga 30067
    Usa
    American13528640001

    SSEJ LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 11 ago 1995
    Consegnato il 16 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 feb 1995
    Consegnato il 21 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date and all moneys due or to become due from clayton environmental consultants inc under the terms of a loan and security agreement (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Greyhound Guaranty PLC and/or Finova Capital Corporation
    Transazioni
    • 21 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of confirmation
    Creato il 03 giu 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 4TH june 1993 guaranteeing the obligations of clayton environmental consultants inc. Under a loan and security agreement dated 4TH june 1993 and all other monies secured by the debenture dated 4TH june 1993
    Brevi particolari
    All that property as charged by the debenture as set out in form 395 dated 15TH june 1993 (registered) being:-. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lasalle Business Credit Inc.
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 giu 1993
    Consegnato il 15 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stanchart Business Credit, Inc
    Transazioni
    • 15 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 giu 1993
    Consegnato il 15 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 15 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 08 lug 1982
    Consegnato il 12 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0