BUPA GATWICK PARK PROPERTIES LIMITED

BUPA GATWICK PARK PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBUPA GATWICK PARK PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01628155
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BUPA GATWICK PARK PROPERTIES LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova BUPA GATWICK PARK PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BUPA GATWICK PARK PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GATWICK PARK PROPERTIES LIMITED 19 ago 198219 ago 1982
    TENMIME LIMITED08 apr 198208 apr 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di BUPA GATWICK PARK PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per BUPA GATWICK PARK PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Nomina di Steven Michael Los come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Fraser Gregory come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 25 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 giu 2010

    Stato del capitale al 21 giu 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Fraser David Gregory il 13 mag 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Tetley Beazley il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mahboob Ali Merchant il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Fraser David Gregory il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    12 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 07/01/2009
    RES13

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di BUPA GATWICK PARK PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Segretario
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    107319700001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    LOS, Steven Michael
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish116895800001
    MERCHANT, Mahboob Ali
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish56732410001
    ABRAHAM, Richard John
    Well Cottage
    Eggington
    LU7 9PD North Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Segretario
    Well Cottage
    Eggington
    LU7 9PD North Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British21672630003
    KEE, Fergus Alexander
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    Segretario
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    Irish26911740008
    SANDERS, Julian Philip
    38 Darrick Wood Road
    BR6 8AW Orpington
    Kent
    Segretario
    38 Darrick Wood Road
    BR6 8AW Orpington
    Kent
    British6658160003
    ABRAHAM, Richard John
    Well Cottage
    Eggington
    LU7 9PD North Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Amministratore
    Well Cottage
    Eggington
    LU7 9PD North Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British21672630003
    BAILEY, Alan Richard, Doctor
    26 Regency House
    Osnaburgh Street
    NW1 3NB London
    Amministratore
    26 Regency House
    Osnaburgh Street
    NW1 3NB London
    British10735020001
    BARKER, James
    Hillside Lye Green
    TN6 1UU Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    Hillside Lye Green
    TN6 1UU Crowborough
    East Sussex
    British18292290001
    BIDDLESTONE, Keith
    9 Aldenham Road
    WD7 8AU Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Aldenham Road
    WD7 8AU Radlett
    Hertfordshire
    British68242230001
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DONALD, Alan Charles
    13 Craven Gardens
    Wimbledon
    SW19 8LU London
    Amministratore
    13 Craven Gardens
    Wimbledon
    SW19 8LU London
    British58742090001
    DUGDALE, Michael Ian
    29 Magnolia Dene
    HP15 7QE Hazlemere
    Buckinghamshire
    Amministratore
    29 Magnolia Dene
    HP15 7QE Hazlemere
    Buckinghamshire
    British79570840001
    ELLEN, Susan Caroline
    47 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 2DN Richmond
    Surrey
    Amministratore
    47 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 2DN Richmond
    Surrey
    EnglandBritish51168990001
    ELLERBY, Mark
    82 Nelson Road
    N8 9RT London
    Amministratore
    82 Nelson Road
    N8 9RT London
    British40582650002
    GREGORY, Fraser David
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish107664270003
    HOLDEN, Dean Allan
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    British32671980002
    KEE, Fergus Alexander
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    Amministratore
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    United KingdomIrish26911740008
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    KING, Raymond
    Westlands House
    Cowfold Road West Grinstead
    RH13 8LZ Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Westlands House
    Cowfold Road West Grinstead
    RH13 8LZ Horsham
    West Sussex
    British56146040001
    LEA, Edward William
    81 Castle Road
    AL1 5DQ St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    81 Castle Road
    AL1 5DQ St. Albans
    Hertfordshire
    British28018450003
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001

    BUPA GATWICK PARK PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 28 ago 1985
    Consegnato il 28 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or midland montagu leasing limited and/or forward leasing (broad street) on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All the undertaking and property present and future, including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Montagu Equipment Finance (UK) Limited.
    Transazioni
    • 28 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 28 ago 1985
    Consegnato il 28 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or midland montagu leasing limited and/or forward leasing (braod street) limited
    Brevi particolari
    All l/hold property registered under title nubmers sy 514932 and sy 520622 see mortgage doc M32 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Montagu Equipment Finance (UK) Limited.
    Transazioni
    • 28 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1983
    Consegnato il 07 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First legal charge over l/hold property to the north of povey cross road, horley, gatwick.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Deed of charge
    Creato il 30 giu 1983
    Consegnato il 06 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further securing the monies due under the terms of a debenture dtd 01/10/82
    Brevi particolari
    Second legal charge over l/h property to the north of povey cross rd horley gatwick sussex.
    Persone aventi diritto
    • Bupa International Limited
    Transazioni
    • 06 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Deed of charge
    Creato il 30 giu 1983
    Consegnato il 06 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further securing the monies due under. The terms of a debenture dated 1ST oct 1982
    Brevi particolari
    Second legal charge over l/hold property to the north of povey cross road. Horley, gatwick, sussex.
    Persone aventi diritto
    • Y. J. Lovell (Holdings) PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Deed of cahrge
    Creato il 30 giu 1983
    Consegnato il 06 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further securing the monies due under. The terms of a debenture dated 1ST oct 1982
    Brevi particolari
    Second legal charge over l/hold property to the north of povey cross road. Horley, gatwick, sussex.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 06 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Deed of charge
    Creato il 30 giu 1983
    Consegnato il 06 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further securing the monies due under the terms of a debenture dated 1ST oct 1982
    Brevi particolari
    Second legal charge over l/hold property to the north of povey cross road. Horley, gatwick, sussex.
    Persone aventi diritto
    • Loomclear LTD.
    Transazioni
    • 06 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Deed of charge
    Creato il 30 giu 1983
    Consegnato il 06 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further securing the monies due under the terms of a debenture dated 1ST oct 1982
    Brevi particolari
    Second legal charge over l/hold property to the north of povey cross, horley, gatwick, sussex.
    Persone aventi diritto
    • Caledonian Aviation Investments Limited
    Transazioni
    • 06 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 ott 1982
    Consegnato il 08 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all monies due or to become due to the bank from gatwick park hospital limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Leasehold property consisting of the land and buildings at the rear of post house hotel, horley known or to be known as gatwick park hospital, horley, surrey.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 01 ott 1982
    Consegnato il 08 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 01 ott 1982
    Consegnato il 08 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company gatwick park hospital LTD to the chargee under the terms of a facility letter dated 29 sept. 1982 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    Second legal charge over l/h property at the rear of the post house hotel, povey cross, surrey known or to be known as gatwick park hospital second floating charge on the (see doc M23). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Caledonian Airways (Investments) Limited
    Transazioni
    • 08 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 01 ott 1982
    Consegnato il 08 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company gatwick park hospital LTD to the chargee under the terms of a facility letter dated 29 sept. 1982 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Second legal charge over l/h property at the rear of the post house hotel, povey cross, surrey known or to be known as gatwick park hospital second floating charge on the (see doc M22 for further details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Bupa Investments Limited
    Transazioni
    • 08 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 01 ott 1982
    Consegnato il 08 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company gatwick park hospital LTD. To the chargee under the terms of a facility letter dated 29 sept. 1982 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    Second legal charge over l/h property at thr rear of the post house hotel, povey cross, surrey, known or to be known as gatwick park hospital second floating charge the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. (See doc M21 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Loomclear Limited
    Transazioni
    • 08 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 01 ott 1982
    Consegnato il 08 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company gatwick park hospital LTD. To the chargee under the terms of a facility letter dated 29 sept. 1982 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Second legal charge over l/h property at the rear of the post house hotel, povey cross, surrey, known or to be known as gatwick park hospital. Second floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital (see doc M20 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Y. J. Lovell (Holdings) PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 01 ott 1982
    Consegnato il 08 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company gatwick park hospital limited to the chargee under the terms of a facility letter dated 29 sept. 1982 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    Second legal charge over l/h property at the rear of the post house hotel povey cross, surrey known or to be known as gatwick park hospital. Second floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital (see doc M19 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited.
    Transazioni
    • 08 ott 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0