NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD

NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01629783
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD?

    • Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni

    Dove si trova NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    10 Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THAMES VALE DEVELOPMENTS LIMITED19 apr 198219 apr 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kelly John Speller il 01 apr 2016

    2 pagineCH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 10 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mar 2016

    Stato del capitale al 09 mar 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kelly John Speller il 01 ago 2015

    2 pagineCH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 31 mar 2016

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Jeremy Lobatto il 01 dic 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Geoffrey King il 01 dic 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas James Philip Bilsland il 01 dic 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Susan Elizabeth Jacquest il 01 dic 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Nicholas James Philip Bilsland il 01 dic 2015

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Regius Court Church Road Penn High Wycombe Buckinghamshire HP10 8RL a 10 Penn Road Beaconsfield Buckinghamshire HP9 2LH in data 27 lug 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2014

    9 pagineAA

    legacy

    31 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kelly John Speller il 29 giu 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Jeremy Lobatto il 29 giu 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Geoffrey King il 29 giu 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 10 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 feb 2015

    Stato del capitale al 17 feb 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2013

    10 pagineAA

    legacy

    34 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Chi sono gli amministratori di NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BILSLAND, Nicholas James Philip
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    Segretario
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    British66511970002
    BILSLAND, Nicholas James Philip
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish66511970002
    JACQUEST, Susan Elizabeth
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish79924010004
    KING, Nicholas Geoffrey
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish96115160006
    LOBATTO, Paul Jeremy
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish78687810003
    SPELLER, Kelly John
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish73635390003
    BOUWMAN, Maria Wolmet
    Brooklyn House
    Curridge
    RG16 9DZ Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Brooklyn House
    Curridge
    RG16 9DZ Newbury
    Berkshire
    British33955300001
    CALDER, Paul Donald
    The Sydings
    Speen
    RG14 1RZ Newbury
    5
    Berkshire
    Segretario
    The Sydings
    Speen
    RG14 1RZ Newbury
    5
    Berkshire
    British5213990001
    KING, Nicholas Geoffrey
    Michaelmas House
    9 Dower Close Knotty Green
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    Michaelmas House
    9 Dower Close Knotty Green
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British96115160002
    MERRY, Peter
    82 Kings Ride
    Penn
    HP10 8BP High Wycombe
    Buckinghamshire
    Segretario
    82 Kings Ride
    Penn
    HP10 8BP High Wycombe
    Buckinghamshire
    British100620530001
    SMITHSON, Justine Helen
    19 Crown Cottage
    Cadley
    SN8 4NE Marlborough
    Wiltshire
    Segretario
    19 Crown Cottage
    Cadley
    SN8 4NE Marlborough
    Wiltshire
    British44758470001
    VARLEY, Gary David
    68 Sumatra Road
    West Hampstead
    NW6 1PR London
    Segretario
    68 Sumatra Road
    West Hampstead
    NW6 1PR London
    British92647180001
    CALDER, Paul Donald
    The Sydings
    Speen
    RG14 1RZ Newbury
    5
    Berkshire
    Amministratore
    The Sydings
    Speen
    RG14 1RZ Newbury
    5
    Berkshire
    EnglandBritish5213990001
    EASTHAM, Graeme Richard
    23 Trevelyan Place
    St Stephens Hill
    AL1 2DT St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    23 Trevelyan Place
    St Stephens Hill
    AL1 2DT St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish92379890001
    FAIRHURST, James Seton
    Shawdene House
    Shawdene
    RG16 9AJ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Shawdene House
    Shawdene
    RG16 9AJ Newbury
    Berkshire
    British4303100001
    KING, Jane Carol
    Hughenden Chase
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hughenden Chase
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    British75532110001
    MERRY, Peter
    82 Kings Ride
    Penn
    HP10 8BP High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    82 Kings Ride
    Penn
    HP10 8BP High Wycombe
    Buckinghamshire
    British100620530001
    MORAN, James Anthony
    101 Gregories Road
    HP9 1HZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    101 Gregories Road
    HP9 1HZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British80790130001
    POTTER, David John
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    UkBritish135413030001
    SIDLEY, Paul
    44 Micawber Avenue
    UB8 3NZ Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    44 Micawber Avenue
    UB8 3NZ Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritish100624730001
    VARLEY, Gary David
    68 Sumatra Road
    West Hampstead
    NW6 1PR London
    Amministratore
    68 Sumatra Road
    West Hampstead
    NW6 1PR London
    British92647180001
    NILPAD LIMITED
    The Quadrangle Enbourne Court
    Enbourne Road
    RG14 6AL Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Quadrangle Enbourne Court
    Enbourne Road
    RG14 6AL Newbury
    Berkshire
    42762730001

    NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 05 feb 2009
    Consegnato il 12 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from playdri products limited and/or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land at thurston granray, station hill, thurston, bury st edmonds, suffolk t/no's SK180539, SK200526 and SK222270.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge on deposit account
    Creato il 09 ott 2003
    Consegnato il 11 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums held to the credit of the company by the chargee at the date of the charge if any, the debts respectively represented by all other sums which shall in future from time to time be standing to the credit of the company with the chargee,.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 11 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 2003
    Consegnato il 08 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Firstly by way of fixed charge over land at rear of 52 54 and 56 chestnut lane amersham buckinghamshire. Secondly by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time placed on or used in or about the above mentioned property.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 08 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 14 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    60 gore road burnham berks t/no: BM245980. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 14 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 set 2002
    Consegnato il 13 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a rose cottage, 58 chestnut lane, amersham, buckinghamshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 13 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 dic 2001
    Consegnato il 14 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Lulworth house ellesmere road weybridge surrey. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 14 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Secured debenture
    Creato il 04 dic 2001
    Consegnato il 14 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 14 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 2001
    Consegnato il 24 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land adoining 21 elm gardens claygate surrey.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 apr 2000
    Consegnato il 21 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    16 18 20 bridge st leatherhead t/nos: SY336363 SY446734 SY357147 SY485260 SY550483 (part) and SY494073 (part). By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 21 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1999
    Consegnato il 17 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at st philip,cheam common road,cheam common,worcester park,sutton,london borough of sutton.t/no sgl 608163.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1999
    Consegnato il 17 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at the site of the former church of st philip cheam common,lindsay road,worcester park,london borough of sutton.t/no SGL608161.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 mag 1999
    Consegnato il 26 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 ago 1997
    Consegnato il 28 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First the f/h and l/h property of the company wherever situate both present and future including but not limited to the specifically charged property being all that f/h land k/a 288 main road walters ash high wycombe and all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings from time to time on or in any such property and all rents and other income derived from any such property.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 28 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 1997
    Consegnato il 07 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all that f/h land situate at and k/a part of wattlefield speen lane newbury berkshire comprising part of the land under t/nos.BK223074, BK325460 and BK204608 .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 07 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 apr 1997
    Consegnato il 26 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land situate at and k/a land lying to the south west of newbold road speen t/no.BK340422.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 26 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 apr 1997
    Consegnato il 12 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H risboro garage wycombe road princes risborough bucks and the assigns of goodwill to the bank. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Secured debenture
    Creato il 15 lug 1996
    Consegnato il 18 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating security. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 18 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 lug 1996
    Consegnato il 18 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land comprising battle cottage speen lane speen newbury berks and adjoining land t/nos.BK280739 and BK245434. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 18 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 lug 1996
    Consegnato il 18 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land comprising larch close speen newbury berks t/nos.BK115012 BK260781 BK228292 and BK113862. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 18 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 lug 1996
    Consegnato il 18 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land comprising 20 station road thatcham newbury berks t/no.BK274330. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 18 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 gen 1994
    Consegnato il 03 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a or being 2 larch close station road berks speen newbury berks t/n BK317735 and by way of assignment the goodwill of the business carried on at the mortgaged property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 gen 1994
    Consegnato il 03 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a or being 1 larch close station road speen newbury berks BK317735 and by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on at the mortgaged property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 mag 1993
    Consegnato il 28 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being 28 amberley close newbury berks and the right of all rentals payable. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement
    Creato il 17 feb 1993
    Consegnato il 03 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made the deposit means the debt or debts owing to the company by the bank or other party see c/h microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 10 dic 1992
    Consegnato il 15 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All plant machinery chattels and other equipment set out on the schedule to form 395 see form 395 M13L for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0