PROPHETS GARAGE LIMITED

PROPHETS GARAGE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROPHETS GARAGE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01630936
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROPHETS GARAGE LIMITED?

    • Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova PROPHETS GARAGE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROPHETS GARAGE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JAUNTHURST LIMITED23 apr 198223 apr 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROPHETS GARAGE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per PROPHETS GARAGE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    8 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Penman Way, Grove Park Leicester Leicestershire LE19 1st a No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP in data 08 ott 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 set 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Cessazione della carica di Gerard Edward Nieuwenhuys come amministratore in data 07 set 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 06 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 ago 2015

    Stato del capitale al 10 ago 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 ago 2014

    Stato del capitale al 13 ago 2014

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 ago 2013

    Stato del capitale al 07 ago 2013

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Adam Collinson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Geoffrey Page-Morris come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jeremy Mallett come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Kurnick come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Laurence Vaughan come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Cessazione della carica di David Kevin Jones come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di PROPHETS GARAGE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLLINSON, Adam
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    148165930001
    COLLINSON, Adam
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish136375910001
    CARPENTER, Mark Gwilym
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    British105829630002
    JONES, David Kevin
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    157722590001
    MITCHELL, Alister David
    5 Sherborne Stables
    Sherborne
    GL54 3DW Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    5 Sherborne Stables
    Sherborne
    GL54 3DW Cheltenham
    Gloucestershire
    British98692580001
    MORRIS, Mark Christopher
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    Segretario
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    British147628740001
    BEAVAN, Catherine Ann Nora
    Old Worcesters
    Holton
    OX33 1QF Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Old Worcesters
    Holton
    OX33 1QF Oxford
    Oxfordshire
    British65753600001
    BROWN, Hamish Wilson
    Luffield Abbey Farm
    Silverstone
    NN12 8TN Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    Luffield Abbey Farm
    Silverstone
    NN12 8TN Towcester
    Northamptonshire
    British66223810001
    BUCKNALL, Michael Brian
    25 Knowlewood Road
    Dorridge
    B93 8JS Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    25 Knowlewood Road
    Dorridge
    B93 8JS Solihull
    West Midlands
    British19823630001
    CARPENTER, Mark Gwilym
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish105829630002
    CLEAVLEY, Derek Peter
    6 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    6 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    British35017660001
    COLVILL, Martin Arthur
    Herons Brook
    Wonersh Park
    GU5 0QP Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Herons Brook
    Wonersh Park
    GU5 0QP Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish32907920001
    DARNBROUGH, Peter Howard
    Lark House
    Clapton On The Hill
    GL54 2LG Bourton On The Water
    Cheltenham Gloucestershire
    Amministratore
    Lark House
    Clapton On The Hill
    GL54 2LG Bourton On The Water
    Cheltenham Gloucestershire
    British35819630002
    FITZPATRICK, John
    Hackwood Cottage Broomfield Park
    Sunningdale
    SL5 0JS Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Hackwood Cottage Broomfield Park
    Sunningdale
    SL5 0JS Ascot
    Berkshire
    British65537530001
    GIBSON, Alan James
    Chapel Farmhouse
    OX18 2RY Grafton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Chapel Farmhouse
    OX18 2RY Grafton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish77962110001
    GRAHAM, Leslie Stuart
    Rosemount
    Sheppenhall Lane Aston
    CW5 8DE Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    Rosemount
    Sheppenhall Lane Aston
    CW5 8DE Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish117016340001
    HEELEY, Michael David
    The Little Moss Chelford Road
    SK9 7TJ Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    The Little Moss Chelford Road
    SK9 7TJ Alderley Edge
    Cheshire
    British49280980001
    KURNICK, Robert Harold
    670 Pleasant
    Birmingham
    Michigan 48009
    Usa
    Amministratore
    670 Pleasant
    Birmingham
    Michigan 48009
    Usa
    United StatesAmerican82981540007
    MALLETT, Jeremy Richard
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish71752820001
    MARTIN, David
    21 Ottery
    Hockley
    B77 5QH Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    21 Ottery
    Hockley
    B77 5QH Tamworth
    Staffordshire
    British64952880001
    MORRIS, Mark Christopher
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    Amministratore
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    EnglandBritish147628740001
    NIEUWENHUYS, Gerard Edward
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish66435290003
    PAGE-MORRIS, Geoffrey Giovanni
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish105444550002
    ROHAN, Denys Claude Reynolds
    Directors Cottage
    Silverstone Circuit Dadford Road
    NN12 8TN Silverstone
    Northamptonshire
    Amministratore
    Directors Cottage
    Silverstone Circuit Dadford Road
    NN12 8TN Silverstone
    Northamptonshire
    British38307860001
    SILMAN, Roger Sidney
    Farmoor Farmhouse
    Oakes Lane
    OX2 9NS Farmoor
    Oxfordshire
    Amministratore
    Farmoor Farmhouse
    Oakes Lane
    OX2 9NS Farmoor
    Oxfordshire
    British17772940003
    VAUGHAN, Laurence Edward William
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandEnglish40326440010
    WALKINSHAW, Thomas Dobbie Thomson
    Chalford Grange
    Old Chalford
    OX7 5QW Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Chalford Grange
    Old Chalford
    OX7 5QW Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish5016680004

    PROPHETS GARAGE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 31 ago 1999
    Consegnato il 03 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 lug 1993
    Consegnato il 21 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 21 set 1992
    Consegnato il 23 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's stock of new and used motor vehices and all the company's right title and interest therein all moneys payable under insurances all goods (see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Bmw Finance (GB) Limited
    Transazioni
    • 23 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 08 mar 1988
    Consegnato il 09 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First all the chargor's present and future stock of used motor vehicles whatsoever all moneys payable under any insurances in respect of motor vehicles, all debts, all proceeds of sale. (Please see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 09 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 gen 1988
    Consegnato il 25 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All monies owing to the co. By the bmw (GB) LTD. In respect of refunds paid by on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis. (See 395).
    Persone aventi diritto
    • Bmw Finance (GB) LTD.
    Transazioni
    • 25 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 29 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 apr 1985
    Consegnato il 22 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All monies owing to prophets garage limited by bmw (GB) limited in respect of refunds paid by the company to bmw (GB) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis please see doc M20.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 22 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 04 gen 1984
    Consegnato il 05 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital (see doc M19).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 06 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PROPHETS GARAGE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 set 2015Inizio della liquidazione
    16 nov 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0