LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01637008 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Newbury House Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Wiltshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CONSTANCE CARROLL HOLDINGS LIMITED | 28 giu 1985 | 28 giu 1985 |
CONSTANCE CARROLL COSMETICS LIMITED | 20 mag 1982 | 20 mag 1982 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Stato del capitale al 22 ago 2019
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Graham Murray Lynch Staunton il 22 ott 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lynne Margaret Lovell come amministratore in data 16 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Susan Angela Lynch-Staunton il 05 set 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Susan Angela Clayton-Smith il 27 lug 2017 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Lynne Margaret Lovell come amministratore in data 01 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una società di medie dimensioni redatto al 31 mar 2015 | 13 pagine | AA | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Alan Thompson come amministratore in data 24 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed constance carroll holdings LIMITED\certificate issued on 26/11/14 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNCH STAUNTON, Graham Murray | Amministratore | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 77490420006 | ||||
LYNCH-STAUNTON, Susan Angela | Amministratore | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire United Kingdom | England | British | Uk Sales Director | 165079930008 | ||||
MUSHET, Norman Buchanan | Segretario | 5 Howgill Close Ledsham Park CH66 4JH Little Sutton Cheshire | British | 105077220001 | ||||||
RING, Leo Joseph | Segretario | 3 Fairways IRISH Rathfarnham Dublin 14 Ireland | Irish | Co Secretary | 97021090001 | |||||
RING, Leo Joseph | Segretario | 3 Fairways IRISH Rathfarnham Dublin 14 Ireland | Irish | Co Secretary | 97021090001 | |||||
ROBERTS, Timothy Edward | Segretario | 19 Grammar School Road WA13 0BQ Lymm Cheshire | British | 14876480002 | ||||||
ALLEN, William | Amministratore | 6 Broughton Close Parr Woods Grappenhall Heyes WA4 3DR Warrington Cheshire | British | Sales Director | 110828410001 | |||||
BYRNE, Bernard Michael | Amministratore | 31 Lavarna Road Terenure IRISH Dublin 6w Ireland | Irish | Finance Director | 60629740001 | |||||
CARPENTER, Brian William | Amministratore | Willan House Highland Road, Badgers Mount TN14 7BA Sevenoaks Kent | England | British | Sales Director | 14876490002 | ||||
HAYES, Richard George | Amministratore | Truddor Grange Newtownmountkennedy Co Wicklow IRISH Ireland | Ireland | Irish | Company Director | 168730590001 | ||||
HICKIE, Gerard | Amministratore | Higher House Farm Castle Mill Lane WA15 0RA Ashley Cheshire | Irish | Managing Director | 85735370004 | |||||
HUGHES, Loraine | Amministratore | Walsham Gardens WA9 5UT St. Helens 38 Merseyside | England | British | Finance Director | 138239430001 | ||||
LOVELL, Lynne Margaret | Amministratore | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire | England | British | Finance And Operations Director | 251923560001 | ||||
MARSH, Stephen Beverley | Amministratore | Home Farm Liverpool Road Ashton In Makerfield WN4 9LX Wigan Lancashire | British | Company Director | 36100180002 | |||||
MORAN, Patrick Joseph | Amministratore | The Highlands Scholarstown Road Rathfarnham Dublin 16 IRISH Ireland | Ireland | Irish | Company Director | 59274790001 | ||||
MURPHY, Jim Michael | Amministratore | 36 Ulverton Road Dalkey IRISH Dublin Ireland | Irish | Company Director | 96999840001 | |||||
MUSHET, Norman Buchanan | Amministratore | 5 Howgill Close Ledsham Park CH66 4JH Little Sutton Cheshire | British | Accountant | 105077220001 | |||||
O'BRIEN, Paul | Amministratore | 3 Fox Lodge Road Fox Lodge Woods IRISH Ratoath Ireland | Ireland | Irish | Director | 96999430001 | ||||
OTLEY, Richard Reverdy | Amministratore | 4 Osborne Way HP23 6EN Wiggington Hertfordshire | United Kingdom | British | Investment Analyst | 127085630001 | ||||
POPHAM, Neil Rowland | Amministratore | Whitehouse Farm Berden CM23 1AE Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 48644450001 | ||||
ROBERTS, Timothy Edward | Amministratore | 19 Grammar School Road WA13 0BQ Lymm Cheshire | British | Finance Director | 14876480002 | |||||
SOROKIN, Alexander | Amministratore | 10 Sterling Street SW7 1HN London | American | Corporate Financier | 111747170001 | |||||
THOMPSON, John Alan | Amministratore | Grimrod Place East Gillibrands WN8 9UU Skelmersdale 22 Lancashire United Kingdom | England | British | Supply Chain Director | 60966890001 | ||||
WILKINSON, Alan Geoffrey | Amministratore | 1 Sunningdale Gardens Freshfield Road L37 3RL Formby Liverpool Merseyside | British | Company Director | 14876510002 | |||||
WILKINSON, Geoffrey Harold | Amministratore | Dalton House Higher Lane Dalton WN8 7RP Wigan Lancashire | British | Company Director | 14876520001 | |||||
WILKINSON, Peter Alan | Amministratore | Uplands Higher Lane, Dalton WN8 7TW Wigan Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 87473650001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivalis Holdings Limited | 06 apr 2016 | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Creato il 28 mar 2006 Consegnato il 11 apr 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over property and assets including goodwill bookdebts uncalled plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 09 giu 2004 Consegnato il 28 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed charge | Creato il 15 ott 1986 Consegnato il 21 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £26,780 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Brevi particolari One magic mini 100 d/e twin station extrusion blow moulding machine serial number 5686. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 ago 1985 Consegnato il 05 set 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures & fittings fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0