LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED

LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01637008
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Newbury House Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Wiltshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CONSTANCE CARROLL HOLDINGS LIMITED28 giu 198528 giu 1985
    CONSTANCE CARROLL COSMETICS LIMITED20 mag 198220 mag 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 22 ago 2019

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Graham Murray Lynch Staunton il 22 ott 2018

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Lynne Margaret Lovell come amministratore in data 16 feb 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Susan Angela Lynch-Staunton il 05 set 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Susan Angela Clayton-Smith il 27 lug 2017

    3 pagineCH01

    Nomina di Mrs Lynne Margaret Lovell come amministratore in data 01 apr 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio per una società di medie dimensioni redatto al 31 mar 2015

    13 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 15 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 dic 2015

    Stato del capitale al 15 dic 2015

    • Capitale: GBP 1,594,593
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di John Alan Thompson come amministratore in data 24 set 2015

    1 pagineTM01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed constance carroll holdings LIMITED\certificate issued on 26/11/14
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name26 nov 2014

    Avviso di cambio di nome"

    CONNOT

    Chi sono gli amministratori di LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LYNCH STAUNTON, Graham Murray
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director77490420006
    LYNCH-STAUNTON, Susan Angela
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritishUk Sales Director165079930008
    MUSHET, Norman Buchanan
    5 Howgill Close
    Ledsham Park
    CH66 4JH Little Sutton
    Cheshire
    Segretario
    5 Howgill Close
    Ledsham Park
    CH66 4JH Little Sutton
    Cheshire
    British105077220001
    RING, Leo Joseph
    3 Fairways
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    Segretario
    3 Fairways
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    IrishCo Secretary97021090001
    RING, Leo Joseph
    3 Fairways
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    Segretario
    3 Fairways
    IRISH Rathfarnham
    Dublin 14
    Ireland
    IrishCo Secretary97021090001
    ROBERTS, Timothy Edward
    19 Grammar School Road
    WA13 0BQ Lymm
    Cheshire
    Segretario
    19 Grammar School Road
    WA13 0BQ Lymm
    Cheshire
    British14876480002
    ALLEN, William
    6 Broughton Close
    Parr Woods Grappenhall Heyes
    WA4 3DR Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    6 Broughton Close
    Parr Woods Grappenhall Heyes
    WA4 3DR Warrington
    Cheshire
    BritishSales Director110828410001
    BYRNE, Bernard Michael
    31 Lavarna Road
    Terenure
    IRISH Dublin 6w
    Ireland
    Amministratore
    31 Lavarna Road
    Terenure
    IRISH Dublin 6w
    Ireland
    IrishFinance Director60629740001
    CARPENTER, Brian William
    Willan House
    Highland Road, Badgers Mount
    TN14 7BA Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Willan House
    Highland Road, Badgers Mount
    TN14 7BA Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishSales Director14876490002
    HAYES, Richard George
    Truddor Grange Newtownmountkennedy
    Co Wicklow
    IRISH Ireland
    Amministratore
    Truddor Grange Newtownmountkennedy
    Co Wicklow
    IRISH Ireland
    IrelandIrishCompany Director168730590001
    HICKIE, Gerard
    Higher House Farm
    Castle Mill Lane
    WA15 0RA Ashley
    Cheshire
    Amministratore
    Higher House Farm
    Castle Mill Lane
    WA15 0RA Ashley
    Cheshire
    IrishManaging Director85735370004
    HUGHES, Loraine
    Walsham Gardens
    WA9 5UT St. Helens
    38
    Merseyside
    Amministratore
    Walsham Gardens
    WA9 5UT St. Helens
    38
    Merseyside
    EnglandBritishFinance Director138239430001
    LOVELL, Lynne Margaret
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    Amministratore
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    EnglandBritishFinance And Operations Director251923560001
    MARSH, Stephen Beverley
    Home Farm Liverpool Road
    Ashton In Makerfield
    WN4 9LX Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    Home Farm Liverpool Road
    Ashton In Makerfield
    WN4 9LX Wigan
    Lancashire
    BritishCompany Director36100180002
    MORAN, Patrick Joseph
    The Highlands Scholarstown Road
    Rathfarnham Dublin 16
    IRISH Ireland
    Amministratore
    The Highlands Scholarstown Road
    Rathfarnham Dublin 16
    IRISH Ireland
    IrelandIrishCompany Director59274790001
    MURPHY, Jim Michael
    36 Ulverton Road
    Dalkey
    IRISH Dublin
    Ireland
    Amministratore
    36 Ulverton Road
    Dalkey
    IRISH Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director96999840001
    MUSHET, Norman Buchanan
    5 Howgill Close
    Ledsham Park
    CH66 4JH Little Sutton
    Cheshire
    Amministratore
    5 Howgill Close
    Ledsham Park
    CH66 4JH Little Sutton
    Cheshire
    BritishAccountant105077220001
    O'BRIEN, Paul
    3 Fox Lodge Road
    Fox Lodge Woods
    IRISH Ratoath
    Ireland
    Amministratore
    3 Fox Lodge Road
    Fox Lodge Woods
    IRISH Ratoath
    Ireland
    IrelandIrishDirector96999430001
    OTLEY, Richard Reverdy
    4 Osborne Way
    HP23 6EN Wiggington
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Osborne Way
    HP23 6EN Wiggington
    Hertfordshire
    United KingdomBritishInvestment Analyst127085630001
    POPHAM, Neil Rowland
    Whitehouse Farm
    Berden
    CM23 1AE Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Whitehouse Farm
    Berden
    CM23 1AE Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director48644450001
    ROBERTS, Timothy Edward
    19 Grammar School Road
    WA13 0BQ Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    19 Grammar School Road
    WA13 0BQ Lymm
    Cheshire
    BritishFinance Director14876480002
    SOROKIN, Alexander
    10 Sterling Street
    SW7 1HN London
    Amministratore
    10 Sterling Street
    SW7 1HN London
    AmericanCorporate Financier111747170001
    THOMPSON, John Alan
    Grimrod Place
    East Gillibrands
    WN8 9UU Skelmersdale
    22
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Grimrod Place
    East Gillibrands
    WN8 9UU Skelmersdale
    22
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishSupply Chain Director60966890001
    WILKINSON, Alan Geoffrey
    1 Sunningdale Gardens
    Freshfield Road
    L37 3RL Formby Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    1 Sunningdale Gardens
    Freshfield Road
    L37 3RL Formby Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Director14876510002
    WILKINSON, Geoffrey Harold
    Dalton House Higher Lane
    Dalton
    WN8 7RP Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    Dalton House Higher Lane
    Dalton
    WN8 7RP Wigan
    Lancashire
    BritishCompany Director14876520001
    WILKINSON, Peter Alan
    Uplands
    Higher Lane, Dalton
    WN8 7TW Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    Uplands
    Higher Lane, Dalton
    WN8 7TW Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director87473650001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Aintree Avenue
    White Horse Business Park
    BA14 0XB Trowbridge
    Newbury House
    Wiltshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06571625
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 28 mar 2006
    Consegnato il 11 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over property and assets including goodwill bookdebts uncalled plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent and Trustee for the Secured Parties (Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 09 giu 2004
    Consegnato il 28 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 28 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge
    Creato il 15 ott 1986
    Consegnato il 21 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £26,780 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    One magic mini 100 d/e twin station extrusion blow moulding machine serial number 5686.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 21 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 30 ago 1985
    Consegnato il 05 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC.
    Transazioni
    • 05 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 27 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0