STUDIO EDGE LIMITED

STUDIO EDGE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTUDIO EDGE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01637408
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STUDIO EDGE LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova STUDIO EDGE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Elma House
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STUDIO EDGE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JEWELLERY INCENTIVES LIMITED14 set 198214 set 1982
    STIMPLORD LIMITED21 mag 198221 mag 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di STUDIO EDGE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per STUDIO EDGE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Mr March Birchall come amministratore in data 24 dic 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Simon Lazenby come segretario in data 24 dic 2011

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 4100 Park Approach Thorpe Park Leeds West Yorkshire LS15 8GB United Kingdom in data 25 nov 2011

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2011

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Beachell come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    pagineMG01

    legacy

    10 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mar 2011

    Stato del capitale al 24 mar 2011

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Cessazione della carica di Peter Mcdermott come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas Hamley come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2010

    4 pagineAA

    Nomina di Mr. Simon Lazenby come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr. Simon Lazenby come segretario

    1 pagineAP03

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Peter John Mcdermott il 29 mar 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Nicholas Peter Hamley il 29 mar 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Peter Beachell il 29 mar 2010

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Peter Rosenberg House 11/15 Wilmington Grove Leeds West Yorkshire LS7 2BQ in data 08 mar 2010

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2009

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di STUDIO EDGE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BIRCHALL, Mark Jason
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector70139540002
    LAZENBY, Simon
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector138472720001
    CHAPMAN, David Philip
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    Segretario
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    BritishAccountant138964960001
    LAZENBY, Simon, Mr.
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Beaconsfield Close
    AL10 8YG Hatfield
    Elma House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    155156530001
    SUTCLIFFE, John Trevor
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    Segretario
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    British81186640001
    WALKER, Phillip Andrew
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    Segretario
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    BritishAccountant190689780001
    BEACHELL, Peter
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant138141080002
    CHAPMAN, David Philip
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    Amministratore
    Hollinhall
    Trawden
    BB8 8PT Colne
    Gilford Clough Farm
    Lancashire
    BritishAccountant138964960001
    HAMLEY, Nicholas Peter, Mr.
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector126433050001
    LEVER, Michael Neville
    Heatheroyd
    Wigton Lane
    LS17 8SA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Heatheroyd
    Wigton Lane
    LS17 8SA Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director12573190001
    MCDERMOTT, Peter John
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Park Approach
    Thorpe Park
    LS15 8GB Leeds
    4100
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector113076530001
    ROSENBERG, Anthony Peter
    Four Winds The Mount
    Alwoodley
    LS17 Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Four Winds The Mount
    Alwoodley
    LS17 Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director10176590001
    STEVENSON, Paul
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director113293590001
    SUTCLIFFE, John Trevor
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    40 Bankfield Grange
    Greetland
    HX4 8LJ Halifax
    West Yorkshire
    BritishCompany Director81186640001
    WALKER, Phillip Andrew
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    Higher Asker Hill
    Grindleton
    BB7 4QT Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritishAccountant190689780001

    STUDIO EDGE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 mag 2011
    Consegnato il 06 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Moorgarth Property Investments Limited (Moorgarth)
    Transazioni
    • 06 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 mar 2009
    Consegnato il 21 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Michael Neville Lever
    Transazioni
    • 21 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 16 giu 2006
    Consegnato il 23 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a peter rosenberg house 11-15 wilmington grove leeds and all other interests in any f/h or l/h property all fixtures and fittings and fixed plant and machinery its goodwill and its uncalled capital its book debts by way of floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 23 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 mag 2004
    Consegnato il 26 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0