ANGLO UNITED PROPERTIES LIMITED

ANGLO UNITED PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàANGLO UNITED PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01637966
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ANGLO UNITED PROPERTIES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ANGLO UNITED PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ANGLO UNITED PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ANGLO UNITED PROPERTIES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ANGLO UNITED PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    3 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2014

    Stato del capitale al 05 nov 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 18 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Amanda Jane Phoenix come amministratore in data 07 ago 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2013

    Stato del capitale al 05 nov 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    13 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    13 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Arnold Veerman il 16 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Amanda Jane Phoenix il 16 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher John Phoenix il 16 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Robert Arnold Veerman il 16 nov 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Arnold Veerman il 05 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Amanda Jane Phoenix il 05 nov 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ANGLO UNITED PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VEERMAN, Robert Arnold
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    Dutch144829040001
    PHOENIX, Christopher John
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishManaging Director16220320001
    VEERMAN, Robert Arnold
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandDutchAccountant144829040001
    VEASEY, John Robert
    57 Busheywood Road
    Dore
    S17 3QA Sheffield
    Segretario
    57 Busheywood Road
    Dore
    S17 3QA Sheffield
    British1134670001
    WALLACE, George Roger
    Ballochmyle
    Welbeck Road Bolsover
    S44 6DH Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    Ballochmyle
    Welbeck Road Bolsover
    S44 6DH Chesterfield
    Derbyshire
    BritishDirector139570001
    COTTAM, Harold, Managing Director
    Pentwyn Farm
    Dorstone
    HR3 6AD Hereford
    Amministratore
    Pentwyn Farm
    Dorstone
    HR3 6AD Hereford
    United KingdomBritishDirector32116700002
    GAINHAM, John Henry
    32 Drayton Gardens
    SW10 9SA London
    Amministratore
    32 Drayton Gardens
    SW10 9SA London
    BritishDirector565790004
    KNIGHTLEY, Anthony Maurice
    67 Moorland View Road
    S40 3DD Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    67 Moorland View Road
    S40 3DD Chesterfield
    Derbyshire
    BritishAccountant32382190001
    MCERLAIN, David Patrick
    Longstone Hall
    Great Longstone
    DE45 1TZ Bakewell
    Derbyshire
    Amministratore
    Longstone Hall
    Great Longstone
    DE45 1TZ Bakewell
    Derbyshire
    BritishDirector780940004
    MUIRHEAD, Hugh Spencer
    Hill Top Farm Heathcote
    SK17 0AY Hartington
    Derbyshire
    Amministratore
    Hill Top Farm Heathcote
    SK17 0AY Hartington
    Derbyshire
    BritishCompany Secretary49836570001
    PHOENIX, Amanda Jane
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Capstone House Prospect Park
    Dunston Way Dunston Road
    S41 9RD Chesterfield
    Derbyshire
    United KingdomBritishLawyer111217890001
    WALLACE, George Roger
    Ballochmyle
    Welbeck Road Bolsover
    S44 6DH Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Ballochmyle
    Welbeck Road Bolsover
    S44 6DH Chesterfield
    Derbyshire
    BritishDirector139570001

    ANGLO UNITED PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 07 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 05 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at high street tunstall stoke on trent t/no's SF181082, SF170513. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation of standard security
    Creato il 26 mar 1993
    Consegnato il 14 apr 1993
    In corso
    Importo garantito
    For varying the terms of a standard security dated 16/08/89
    Brevi particolari
    22 john street helensburgh title no DMB27652.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Trustee for the Lenders
    Transazioni
    • 14 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of variation of standard security
    Creato il 26 mar 1993
    Consegnato il 14 apr 1993
    In corso
    Importo garantito
    For varying the terms of a standard security
    Brevi particolari
    Subjects on the north west side of caledonia street clydebank title no DMB32931.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Trustee for the Lenders
    Transazioni
    • 14 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental debenture
    Creato il 04 mar 1993
    Consegnato il 12 mar 1993
    In corso
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as trustee for the lenders,the agent or the lenders (all as defined) on any account whatsoever under the terms of the guarantee,the debenture and any of the other loan documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed charge the proceeds of sale of all or any part of the real property all the intellectual property plant & machinery licences plant machinery and equipment shares and other securities.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Trustee
    Transazioni
    • 12 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security
    Creato il 31 ago 1989
    Consegnato il 14 set 1989
    In corso
    Importo garantito
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 31-8-89 and created by anglo united properties limited for securing all monies due or to become due from the company to the chargee in its capacity as trustee for the lenders under the facility agreements was registered pursuant to chapter 1 part xii of the companies act 1985 on the 14-9-89
    Brevi particolari
    Area of ground lying to the west of the A823 public road leading from dunfermline to rumbling bridge situated in the parish and regality of dunfermline and former county of fife and now in the dunfermline district of fife region (for full details see doc M2).
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Transazioni
    • 14 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 30 ago 1989
    Consegnato il 14 set 1989
    In corso
    Importo garantito
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 30-8-89 and created by anglo united properties limited for securing. All monies due or to become due from the company to the chargee in its capacity as trustee for the lenders under the facility agreements was registered pursuant to chapter 1 part xii of the companies act 1985 on the 14-9-89.
    Brevi particolari
    All and whole the shop premises with ground pertaining thereto k/a and forming no. 22 john street, helensburgh. Title no. Dmb 27652 (for full details refer to doc 395 ref M4).
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Transazioni
    • 14 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 30 ago 1989
    Consegnato il 14 set 1989
    In corso
    Importo garantito
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 30-8-89 and created by anglo united properties limited for securing all monies due or to become due from the company to the chargee in its capacity as trustee for the lenders under the facility agreements was registered pursuant to chapter 1 part xii of the companies act 1985 on the 14-9-89
    Brevi particolari
    All and whole the plot or area of ground situated on the north side of caledonia street, clydebank. Title no. Dmb 32931. (for full details refer no doc M3).
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Transazioni
    • 14 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 14 ago 1989
    Consegnato il 24 ago 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in its capacity as trustee for the lenders. Under the terms of a guarantee of evendate & the debenture & any other loan documents
    Brevi particolari
    All stocks & shares. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 24 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 24 mar 1988
    Consegnato il 07 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 22 mar 1988
    Consegnato il 22 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Approx. 10 acres at land on the north side of station road, stanley, derbyshire title no dy 75479.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1988
    Consegnato il 22 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and office premises at broombank road, sheepbridge chesterfield, derbyshire title no dy 98861.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1988
    Consegnato il 22 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and premises at high street, clay cross, derbyshire title no dy 152335.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1988
    Consegnato il 22 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    17.35 acres of land situate at high street, tunstall, stoke on trent, staffordshire title no sf 181082.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1988
    Consegnato il 22 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    6.78 acres of land lying to the east side of high street, newfield pottery, tunstall, stoke on trent, staffordshire title no sf 170513.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 gen 1986
    Consegnato il 06 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The hurst site, brierley hill, dudley west midlands title no: wm 231749.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 gen 1986
    Consegnato il 06 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at peartree lane, dudley, west midlands title no: wm 349649.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 gen 1986
    Consegnato il 04 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or coal contractors limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0