DEAN & DYBALL MARINE LIMITED

DEAN & DYBALL MARINE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDEAN & DYBALL MARINE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01641006
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DEAN & DYBALL MARINE LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova DEAN & DYBALL MARINE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tower Bridge House
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DEAN & DYBALL MARINE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DEAN AND DYBALL SHIPPING LIMITED05 nov 198205 nov 1982
    FOLBROWN LIMITED03 giu 198203 giu 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di DEAN & DYBALL MARINE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per DEAN & DYBALL MARINE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Endeavour House Crow Arch Lane Ringwood Hampshire BH24 1PN in data 14 giu 2011

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 mag 2011

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 11 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 apr 2011

    Stato del capitale al 27 apr 2011

    • Capitale: GBP 4,000
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Richard Johnson il 28 mar 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Murray John Easton come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Crawford come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Emma Campbell come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Philip Morris come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Philip Hugh Morris il 11 apr 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di DEAN & DYBALL MARINE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAMPBELL, Emma
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Segretario
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    155195410001
    EASTON, Murray John
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Amministratore
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    EnglandBritishDirector62486170001
    JOHNSON, Mark Richard
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Amministratore
    St. Katharines Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomBritishDirector61083530002
    FLINT, Henry Lawrence
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    BritishDirector78490580001
    FLINT, Henry Lawrence
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    BritishFinance Director78490580001
    MACINTOSH, Kenneth
    Woodpecker Cottage Keysworth
    BH20 7BH Wareham
    Dorset
    Segretario
    Woodpecker Cottage Keysworth
    BH20 7BH Wareham
    Dorset
    British9297490001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Shore Road
    PO18 8HZ Bosham
    Cob Cottage
    West Sussex
    Segretario
    Shore Road
    PO18 8HZ Bosham
    Cob Cottage
    West Sussex
    British34131020003
    MORRIS, Philip Hugh
    Crow Arch Lane
    BH24 1PN Ringwood
    Endeavour House
    Hampshire
    Segretario
    Crow Arch Lane
    BH24 1PN Ringwood
    Endeavour House
    Hampshire
    British9233330003
    BEACH, Philip Graham
    Cobblestones Ducky Lane
    Landrake
    PL12 5DL Saltash
    Cornwall
    Amministratore
    Cobblestones Ducky Lane
    Landrake
    PL12 5DL Saltash
    Cornwall
    BritishDirector9432480001
    CRAWFORD, Andrew
    Hawkswood 28 Branksome Hill Road
    BH4 9LD Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    Hawkswood 28 Branksome Hill Road
    BH4 9LD Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritishDirector17276890001
    DYBALL, Adrian Stuart Brennan
    4 Cornwall Road
    TW1 3LS Twickenham
    London
    Amministratore
    4 Cornwall Road
    TW1 3LS Twickenham
    London
    BritishCompany Director58499000002
    DYBALL, Peter Brennan
    West Park Farm
    Colehill
    BH16 6BS Lytchett Matravers
    Dorset
    Amministratore
    West Park Farm
    Colehill
    BH16 6BS Lytchett Matravers
    Dorset
    BritishDirector9289300001
    FLINT, Henry Lawrence
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Orchard End House
    Orchard End Bulford
    SP4 9EA Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritishFinance Director78490580001
    GUSH, William James
    56 Neal Road
    West Kingsdown
    TN15 6DG Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    56 Neal Road
    West Kingsdown
    TN15 6DG Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishDirector51427940001
    HIRST, Martin Beverley Bodenham
    Treview
    Windfield Drive Winchester Hill
    SO41 0RA Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    Treview
    Windfield Drive Winchester Hill
    SO41 0RA Romsey
    Hampshire
    EnglandBritishDirector9289310002
    MCNAUGHTON, Andrew James
    8 Sparrow Way
    RH15 9UL Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    8 Sparrow Way
    RH15 9UL Burgess Hill
    West Sussex
    BritishCivil Engineer101231740001
    O KANE, Roger Casimir Bradley
    4 Ameysford Road
    Ferndown
    BH22 9QA Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    4 Ameysford Road
    Ferndown
    BH22 9QA Wimborne
    Dorset
    BritishCompany Director74572290001
    PEASLAND, Michael John
    48 Bathgate Road
    Wimbledon
    SW19 5PJ London
    Amministratore
    48 Bathgate Road
    Wimbledon
    SW19 5PJ London
    United KingdomBritishDirector714450006
    WHEELER, Brian Arthur
    Ludwell House Ludwell Lane
    Waltham Chase
    SO32 2NP Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Ludwell House Ludwell Lane
    Waltham Chase
    SO32 2NP Southampton
    Hampshire
    BritishDirector2810790001
    WHITE, Brian Alexander
    57 Carrington Lane
    Milford On Sea
    SO41 0RA Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    57 Carrington Lane
    Milford On Sea
    SO41 0RA Lymington
    Hampshire
    BritishDirector9432490001

    DEAN & DYBALL MARINE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set-off agreement dated 23 january 2002 and
    Creato il 16 dic 2008
    Consegnato il 24 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 23/01/2002
    Creato il 20 set 2005
    Consegnato il 22 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present and future account of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of ship
    Creato il 31 mar 1994
    Consegnato il 14 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Brevi particolari
    64 shares in the registered ship k/a witton ii registered at the port of liverpool with official number 704461 together with her boats and appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 14 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 31 mar 1994
    Consegnato il 07 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £350,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The british ship named whitten ii registered at the port of liverpool official number 704461.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 07 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 26 nov 1993
    Consegnato il 15 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Brevi particolari
    Sixty four sixty fourth shares of and in the ship "rock supplies barge no.1" Registered at the port of hull official number 720323 year number 15 in 1992.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 26 nov 1993
    Consegnato il 15 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All insurances and earnings of rock supplies barge no.1 Registered at hull official no.720323.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 27 nov 1992
    Consegnato il 02 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 04 nov 1986
    Consegnato il 19 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current.
    Brevi particolari
    1968, motor tanker, single screw "reedness" official no 712255. formerly named "kyndill ii".
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 10 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Acknowledgement of terms.
    Creato il 29 set 1986
    Consegnato il 08 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pound and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge dated 29 sept. 1986.
    Brevi particolari
    1968 motor tanker, single screw "kyndill ii".
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 10 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 15 gen 1985
    Consegnato il 24 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current
    Brevi particolari
    Motor vessel named. "James royel" official number 334743.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 24 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    Deed of covenant
    Creato il 18 mar 1983
    Consegnato il 24 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further securing sterling pound 272800 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents.
    Brevi particolari
    The ship,the earnings of the ship and requisition compensation as defined in the deed of covenant.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 mar 1983
    Consegnato il 24 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a financial agreement and a deed of covenant both dated 18TH march 1983
    Brevi particolari
    64/64TH shares in the M.V. "douglas mcwilliam" registered at the port of southampton under official number 700446. ("the ship").
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 30 dic 1982
    Consegnato il 31 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all buildings, trade & other fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DEAN & DYBALL MARINE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 mag 2011Inizio della liquidazione
    11 gen 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Roderick John Weston
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0