PAYCHANNEL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPAYCHANNEL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01645175
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PAYCHANNEL LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova PAYCHANNEL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Challenge House
    International Drive
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PAYCHANNEL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRANSACSYS APPLICATIONS LTD23 mag 200323 mag 2003
    G2 LIMITED.20 set 200220 set 2002
    TRANSACSYS APPLICATIONS LIMITED 09 apr 200109 apr 2001
    GIROVEND SYSTEMS LIMITED21 ott 199721 ott 1997
    GIROVEND CASHLESS SYSTEMS (UK) LIMITED23 ago 198223 ago 1982
    COLAW ONE LIMITED21 giu 198221 giu 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di PAYCHANNEL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per PAYCHANNEL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mar 2010

    Stato del capitale al 18 mar 2010

    • Capitale: GBP 103
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    12 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    14 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    14 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 30 set 2005

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed transacsys applications LTD\certificate issued on 31/07/06
    2 pagineCERTNM

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di PAYCHANNEL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THORINGTON-JONES, Gary, Mr.
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    Segretario
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    British85541780001
    CLARKSON, James Robert
    9 Westwood Close
    The Briars
    WR9 0BD Droitwich Spa
    Worcestershire
    Amministratore
    9 Westwood Close
    The Briars
    WR9 0BD Droitwich Spa
    Worcestershire
    United KingdomBritish72610550001
    THORINGTON-JONES, Gary, Mr.
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    EnglandBritish85541780001
    WHITELOCK, Noel Keith
    154 Cheltenham Road
    WR11 2LW Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    154 Cheltenham Road
    WR11 2LW Evesham
    Worcestershire
    United KingdomBritish14940620001
    ALLEN, Matthew Charles
    75 Park Road
    W4 3EY London
    Segretario
    75 Park Road
    W4 3EY London
    British37599910001
    BAILEY, John
    Stockton Grange The Village
    Stockton On The Forest
    YO3 9UW York
    North Yorkshire
    Segretario
    Stockton Grange The Village
    Stockton On The Forest
    YO3 9UW York
    North Yorkshire
    British41823950002
    BANYARD, Alec William James
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    Segretario
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    British32189370001
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    Segretario
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    British49907850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Segretario
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Segretario
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Segretario
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    British116252510001
    PECK, Martin David
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    Segretario
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    British78149370002
    WELCH, David Michael Geoffrey
    Inigo House
    29 Bedford Street
    WC2E 9ED London
    Segretario
    Inigo House
    29 Bedford Street
    WC2E 9ED London
    British43153490002
    CLAIR, Peter
    4 White Hermitage
    Church Road Old Windsor
    SL4 2JX Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    4 White Hermitage
    Church Road Old Windsor
    SL4 2JX Windsor
    Berkshire
    British47537030003
    CLARK, Ronald Thomson
    Gill House
    Runsell Green, Danbury
    CM3 4QZ Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Gill House
    Runsell Green, Danbury
    CM3 4QZ Chelmsford
    Essex
    British69705410001
    DRUDY, Carmel Ann
    15 Cinnamon Row
    Battersea
    SW11 3TW London
    Amministratore
    15 Cinnamon Row
    Battersea
    SW11 3TW London
    British40928410001
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    Amministratore
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    EnglandBritish49907850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    GREHS, Barbara
    14 Overy House
    Webber Row
    SE1 8QX London
    Amministratore
    14 Overy House
    Webber Row
    SE1 8QX London
    British42212470001
    HARRIS, Glyn
    Ty Gwyn
    Boverton Road
    CF61 1YA Llantwit Major
    South Glam
    Amministratore
    Ty Gwyn
    Boverton Road
    CF61 1YA Llantwit Major
    South Glam
    British8555610001
    KOBEISSI, Mario
    67 Boardwalk Place
    E14 5SE London
    Amministratore
    67 Boardwalk Place
    E14 5SE London
    British92156280001
    LAING, Andrew Murray
    14 Petley Road
    W6 9ST London
    Amministratore
    14 Petley Road
    W6 9ST London
    British28771390001
    LAVERACK, Harold Thomas
    68 The Holloway
    WR9 7AX Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    68 The Holloway
    WR9 7AX Droitwich
    Worcestershire
    British19389720001
    MADISON HAYNE, Hayne
    100 Scenic Highway
    46 Lookout Mountain
    Tennesse
    United States Of America
    Amministratore
    100 Scenic Highway
    46 Lookout Mountain
    Tennesse
    United States Of America
    American45373130001
    MCGRANE, Paul Steven
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    Amministratore
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    United KingdomBritish51004210002
    MCNAIR, John
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    Amministratore
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    British61297520001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Amministratore
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritish116252510001
    PECK, Martin David
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    Amministratore
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    EnglandBritish78149370002
    SCHOFIELD, Janet Elizabeth
    43 Florence Road
    Wimbledon
    SW19 8TH London
    Amministratore
    43 Florence Road
    Wimbledon
    SW19 8TH London
    British36356290002
    SMART, Richard Ernest
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    British7970090001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Amministratore
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002
    TRACE, Charles Lawrence
    Sands Lane
    Small Dole
    BN5 9YL Henfield
    Ashleigh House
    West Sussex
    Amministratore
    Sands Lane
    Small Dole
    BN5 9YL Henfield
    Ashleigh House
    West Sussex
    EnglandBritish129244340001
    WILLIAMS, Richard Idwal
    Top Flat
    68 Ladbroke Grove
    W11 2PB London
    Amministratore
    Top Flat
    68 Ladbroke Grove
    W11 2PB London
    British40830150002

    PAYCHANNEL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of life policy
    Creato il 25 feb 1997
    Consegnato il 11 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or the principal debtor (as defined) to the chargee under the terms of the deed
    Brevi particolari
    The company with full title guarantee assigned and agreed to assign to the bank:(a) the policy of assurance set out in part iv of this schedule and all moneys (including bonuses) that may become payable thereunder.(b) all sums payable to the company in connection with the policies pursuant to section 76 of the insurance companies act 1982. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 feb 1997
    Consegnato il 11 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All f/h & l/h land in england and wales including (but not limited to) the property at unit 6 (formerly unit B4) progress business centre,whittle parkway,bath road,slough.t/no.bk 266697. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 set 1996
    Consegnato il 19 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 30 nov 1990
    Consegnato il 20 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Counter-indemnity & charge
    Creato il 13 mag 1988
    Consegnato il 26 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (For full details see form 395 ref: M49). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Graig Shipping PLC
    Transazioni
    • 26 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0