BETAWELL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBETAWELL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01645720
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BETAWELL LIMITED?

    • Pub e bar (56302) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova BETAWELL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    284 Clifton Drive South
    FY8 1LH Lytham St Annes
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BETAWELL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per BETAWELL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Navigation Business Village Navigation Way Ashton on Ribble Preston Lancashire PR2 2YP United Kingdom a 284 Clifton Drive South Lytham St Annes Lancashire FY8 1LH in data 08 gen 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 21 dic 2016

    LRESSP

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2016

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 mar 2016

    Stato del capitale al 16 mar 2016

    • Capitale: GBP 720
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 016457200010, creata il 18 gen 2016

    27 pagineMR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Richard House Winckley Square Preston Lancashire, PR1 3HP a 1 Navigation Business Village Navigation Way Ashton on Ribble Preston Lancashire PR2 2YP in data 21 ott 2015

    1 pagineAD01

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 16 mar 2015

    • Capitale: GBP 667
    4 pagineSH06

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mar 2015

    Stato del capitale al 24 mar 2015

    • Capitale: GBP 720
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mar 2014

    Stato del capitale al 24 mar 2014

    • Capitale: GBP 720
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 17 apr 2013

    • Capitale: GBP 720
    4 pagineSH06

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Cessazione della carica di Geoffrey Moore come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Geoffrey Moore come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 16 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2011

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BETAWELL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RICKSON, Peter Gordon Grenville
    Treales Road
    PR4 3SQ Treales
    Nook Wood House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Treales Road
    PR4 3SQ Treales
    Nook Wood House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor28869540001
    MOORE, Geoffrey
    2 Elizabeth Close
    Staining
    FY3 0EF Blackpool
    Lancashire
    Segretario
    2 Elizabeth Close
    Staining
    FY3 0EF Blackpool
    Lancashire
    BritishCompany Administrator9039560001
    WHITLOW, Peter Robert
    82 Tinerfe Gardens
    Adeje
    Playa De Las Americas
    Tenerife
    Segretario
    82 Tinerfe Gardens
    Adeje
    Playa De Las Americas
    Tenerife
    BritishPnb Manager6396550003
    MOORE, Geoffrey
    2 Elizabeth Close
    Staining
    FY3 0EF Blackpool
    Lancashire
    Amministratore
    2 Elizabeth Close
    Staining
    FY3 0EF Blackpool
    Lancashire
    BritishCo Admin And Publican9039560001
    WHITLOW, Peter Robert
    82 Tinerfe Gardens
    Adeje
    Playa De Las Americas
    Tenerife
    Amministratore
    82 Tinerfe Gardens
    Adeje
    Playa De Las Americas
    Tenerife
    BritishPub Manager6396550003

    BETAWELL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 gen 2016
    Consegnato il 22 gen 2016
    In corso
    Breve descrizione
    11 talbot road blackpool.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Peter Gordon Grenville Rickson
    Transazioni
    • 22 gen 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 23 giu 1995
    Consegnato il 01 nov 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Rumours talbot square blackpool lancashire t/n LA688125. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 01 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 21 feb 1994
    Consegnato il 25 feb 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Creato il 19 ago 1993
    Consegnato il 01 set 1993
    In corso
    Importo garantito
    £48,041.40 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 01 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 23 nov 1992
    Consegnato il 05 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 dic 1991
    Consegnato il 17 dic 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The shuttleworth arms garstang road broughton nr preston lancs the goodwill of the business the benefit of the justices licence and all wet & dry stock. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bass Brewers LTD
    Transazioni
    • 17 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 15 ott 1991
    Consegnato il 19 ott 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (or of any ultimate holding company of the company or any subsidiary company of such holding company) to bass brewers limited (bass) or to any operating division of bass or to any subsidiary company of such holding companies.
    Brevi particolari
    (Please see M395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bass Brewers Limited
    Transazioni
    • 19 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 ott 1991
    Consegnato il 19 ott 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (or of any ultimate holding company of the company or any subsidiary company of such holding company) to bass brewers limited ("bass") or to any operating division of bass or to any ultimate holding company & bass or to any subsidiary company of such holding company on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed charge over "rumours" talbot square, blackpool. The goodwill of the business carried on at the property and the justices licence held in respect of the property. Floating charge over all the moveable plant equipment furniture and all other fittings, and all wet and dry stock.
    Persone aventi diritto
    • Bass Brewers Limited
    Transazioni
    • 19 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 26 apr 1983
    Consegnato il 14 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H licensed premises, jenkin sons buildings talbot square blackpool lancashire (see doc M15 for furthers details).
    Persone aventi diritto
    • Williams Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 27 nov 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 apr 1983
    Consegnato il 15 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 07 dic 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BETAWELL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 giu 2018Data di scioglimento
    21 dic 2016Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Philip Stephen Wallace
    Ps Wallace & Co
    284 Clifton Drive South
    FY8 1LH Lytham St Annes
    Lancashire
    Praticante
    Ps Wallace & Co
    284 Clifton Drive South
    FY8 1LH Lytham St Annes
    Lancashire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0