HELIX LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHELIX LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01653986
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HELIX LIMITED?

    • (3663) /

    Dove si trova HELIX LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O
    GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HELIX LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRITISH & INTERNATIONAL PROPRIETARIES LIMITED24 mar 198324 mar 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di HELIX LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HELIX LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HELIX LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    10 pagine4.72

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:s/s certificate of release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 apr 2015

    10 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    31 pagineLIQ MISC OC

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 feb 2015

    10 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    36 pagineLIQ MISC OC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 feb 2014

    13 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:court order to remove paul addison
    6 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 feb 2013

    12 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 lug 2012

    13 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    12 pagine2.16B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    14 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Po Box 15 Engine Lane Lye Stourbridge West Midlands DY9 7AJ* in data 02 feb 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Melvin Mcgregor come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Jeffries come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    6 pagineMG01

    Chi sono gli amministratori di HELIX LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PELL, Michael Anthony
    Newfield Place
    DY9 0FB Hagley
    7
    Worcestershire
    Segretario
    Newfield Place
    DY9 0FB Hagley
    7
    Worcestershire
    British135130680001
    LAWSON, Gordon Mark
    Lower Town Farm House Lower Town
    Claines
    WR3 7RY Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Lower Town Farm House Lower Town
    Claines
    WR3 7RY Worcester
    Worcestershire
    United KingdomBritish2265270001
    LAWSON, Peter Arthur
    Buckland Place
    Dunley
    DY13 0UG Stourport On Severn
    Worcestershire
    Amministratore
    Buckland Place
    Dunley
    DY13 0UG Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritish15228390002
    PELL, Michael Anthony
    Newfield Place
    DY9 0FB Hagley
    7
    Worcestershire
    Amministratore
    Newfield Place
    DY9 0FB Hagley
    7
    Worcestershire
    EnglandBritish135130680001
    KELLEHER, Neil Antony
    Kelleher
    25 Cloister Drive
    B62 8RA Halesowen
    West Midlands
    Segretario
    Kelleher
    25 Cloister Drive
    B62 8RA Halesowen
    West Midlands
    British48538650003
    ROBINSON, Alvin David
    120 Old Birmingham Road
    Marlbrook
    B60 1DH Bromsgrove
    Worcestershire
    Segretario
    120 Old Birmingham Road
    Marlbrook
    B60 1DH Bromsgrove
    Worcestershire
    British615540001
    AUSTIN, Robert
    9 Fanshawe Road
    OX9 3LF Thame
    Oxfordshire
    Amministratore
    9 Fanshawe Road
    OX9 3LF Thame
    Oxfordshire
    British9953130001
    BARLEY, John Wrigley
    Tower Crest The Compa
    Kinver
    DY7 6HS Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Tower Crest The Compa
    Kinver
    DY7 6HS Stourbridge
    West Midlands
    British15407500001
    BROPHY, Richard Patrick
    41 Coton Lane
    B79 8NP Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    41 Coton Lane
    B79 8NP Tamworth
    Staffordshire
    British43841080001
    BROWN, Francis William
    Cranham House
    Shenstone
    DY10 4DL Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    Cranham House
    Shenstone
    DY10 4DL Kidderminster
    Worcestershire
    United KingdomBritish20746810001
    BULL, Steven Peter James
    17 Willow Park Drive
    Bishops Cleeve
    GL52 8XD Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    17 Willow Park Drive
    Bishops Cleeve
    GL52 8XD Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish79684690001
    CHADBAND, Graham
    The Lane Farm
    Frodesley
    SY5 7QG Shrewsbury
    Salop
    Amministratore
    The Lane Farm
    Frodesley
    SY5 7QG Shrewsbury
    Salop
    British82123900001
    DIAMOND, Andrew Robert
    15 Kingsbridge Way
    NG9 3LW Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    15 Kingsbridge Way
    NG9 3LW Nottingham
    Nottinghamshire
    British79466300001
    DIXEY, Andrew Roger
    Hill House
    Bloxham
    OX15 4PH Oxon
    Amministratore
    Hill House
    Bloxham
    OX15 4PH Oxon
    EnglandBritish152068670001
    ETESON, Richard David
    8 Huntley Close
    HP13 5PQ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    8 Huntley Close
    HP13 5PQ High Wycombe
    Buckinghamshire
    British12507400002
    HUDSON, Terence Nigel
    74 Jervis Crescent
    Streetley
    B74 4PN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    74 Jervis Crescent
    Streetley
    B74 4PN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British45979350001
    JEFFRIES, Mark Stephen
    Cavalier Drive
    B63 4SQ Halesowen
    31
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Cavalier Drive
    B63 4SQ Halesowen
    31
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish131108410003
    KELLEHER, Neil Antony
    Kelleher
    25 Cloister Drive
    B62 8RA Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    Kelleher
    25 Cloister Drive
    B62 8RA Halesowen
    West Midlands
    British48538650003
    MAROOTH, James Joseph
    79 Cambridge Road
    Crosby
    L23 7TX Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    79 Cambridge Road
    Crosby
    L23 7TX Liverpool
    Merseyside
    British68827200001
    MATTHEWS, Peter Graham
    14 Chepstow Avenue
    Berkeley Beverborne
    WR4 0EF Worcester
    Amministratore
    14 Chepstow Avenue
    Berkeley Beverborne
    WR4 0EF Worcester
    British73951200001
    MCCLINTOCK, Gary Francis
    352 Hurcott Road
    DY10 2QN Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    352 Hurcott Road
    DY10 2QN Kidderminster
    Worcestershire
    British118534700001
    MCGREGOR, Melvin
    75 Feckenham Road
    Headless Cross
    B97 5AH Redditch
    Hereford And Worcester
    Amministratore
    75 Feckenham Road
    Headless Cross
    B97 5AH Redditch
    Hereford And Worcester
    United KingdomBritish32757450001
    O'QUINN, Richard Charles
    Barn House Duck End Lane
    Biddenham
    MK40 4AL Bedford
    Amministratore
    Barn House Duck End Lane
    Biddenham
    MK40 4AL Bedford
    EnglandEnglish47892720001
    PORRITT, Susan Ellen
    17 The Orchids
    Chilton
    OX11 0QP Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    17 The Orchids
    Chilton
    OX11 0QP Didcot
    Oxfordshire
    British71845950001
    ROBINSON, Alvin David
    120 Old Birmingham Road
    Marlbrook
    B60 1DH Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    120 Old Birmingham Road
    Marlbrook
    B60 1DH Bromsgrove
    Worcestershire
    EnglandBritish615540001

    HELIX LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 lug 2011
    Consegnato il 02 ago 2011
    In corso
    Importo garantito
    £250,000 due or to become due from the company to gordon mark lawson and peter arthur lawson and/or their successors (together 'lenders') under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Gordon Mark Lawson (In His Capacity as Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage debenture
    Creato il 18 gen 2010
    Consegnato il 22 gen 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Fixed and floating charge over all assets
    Creato il 02 apr 2003
    Consegnato il 10 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nmb-Heller Limited and/or Any Receiver
    Transazioni
    • 10 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge
    Creato il 30 mar 1995
    Consegnato il 31 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £96,103.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1 x tti-1290/270 ton ht series injection moulding machine serial number 9611 and 1 x tti-1410/300 ton ht series injection moulding machine serial number 10387 and 1 x SP270 ton injection moulding machine serial number G941219.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 31 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 11 lug 1994
    Consegnato il 13 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £65,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    First fixed charge over 2XATM ax-s 1000 pneumatic drive beam type robot with attachments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 13 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 18 giu 1993
    Consegnato il 21 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £125,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed charge over 3 x TT1-710 180 hi-tech-std 48MM screw voltage 415V-3PH-50HZ-injection moulding machines serial nos 8004 8003 8005 3 x TT1-1290 270 hi-tech-std 60MM screw voltage 415V-3PH-50HZ injection moulding machines-serial nos 8447 8449 and 8448.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 21 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 feb 1993
    Consegnato il 05 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (For full details refer to doc M395). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 feb 1993
    Consegnato il 27 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mag 1992
    Consegnato il 14 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage property k/a 25 dulverton road including its proceeds of sale fixed charge the benefit of all covenants and rights affecting the property.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 02 apr 1992
    Consegnato il 03 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000.00 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed charge over 1 x new automatic heat sealing wallet - model ta-hd serial no 92 021E 076.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 03 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 30 apr 1991
    Consegnato il 01 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £79,200 & all other monies due or to to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    A first charge over:- stenhoj production 200 ton L.P. press serial number 60182.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 01 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HELIX LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 gen 2012Inizio dell'amministrazione
    04 feb 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Addison
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    Praticante
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    David James Bennett
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    Praticante
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    2
    DataTipo
    16 gen 2016Data di scioglimento
    04 feb 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Addison
    Colmore Plaza Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praticante
    Colmore Plaza Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    David James Bennett
    Colmore Plaza Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praticante
    Colmore Plaza Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    David Michael Riley
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Praticante
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Trevor Patrick O'Sullivan
    Grant Thornton Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0