STOREYS INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED

STOREYS INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTOREYS INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01654315
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STOREYS INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED?

    • (2416) /

    Dove si trova STOREYS INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1st Floor
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STOREYS INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CONSTAT THIRTY NINE LIMITED27 lug 198227 lug 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di STOREYS INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2005

    Quali sono le ultime deposizioni per STOREYS INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 nov 2009

    10 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    8 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    13 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    16 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 lug 2009

    13 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 gen 2009

    9 pagine4.68

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    16 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    16 pagine2.24B

    Certificato modificato di costituzione del comitato dei creditori

    1 pagine2.26B

    Risultato della riunione dei creditori

    4 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività

    36 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    29 pagine2.17B

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    8 pagine395

    Bilancio redatto al 31 ago 2005

    20 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 ago 2004

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di STOREYS INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COX, Malcolm Peter
    58 Burnham Drive
    Whetstone
    LE8 6HY Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    58 Burnham Drive
    Whetstone
    LE8 6HY Leicester
    Leicestershire
    BritishGeneral Manager105976490001
    COX, Malcolm Peter
    58 Burnham Drive
    Whetstone
    LE8 6HY Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    58 Burnham Drive
    Whetstone
    LE8 6HY Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishGeneral Manager105976490001
    O'NEILL, Derham Charles
    17a Hugh Mews
    SW1V 1QH London
    Amministratore
    17a Hugh Mews
    SW1V 1QH London
    United KingdomBritishConsultant57161700003
    HOAD, Geoffrey Douglas
    23 North Street
    CM6 1AZ Great Dunmow
    Essex
    Segretario
    23 North Street
    CM6 1AZ Great Dunmow
    Essex
    British48622020001
    SEVERN, John Philip
    26 Henry Laver Court
    CO3 3AF Colchester
    Essex
    Segretario
    26 Henry Laver Court
    CO3 3AF Colchester
    Essex
    BritishCompany Director80671560002
    WILMAN, David John
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    British22174080001
    WILMAN, David John
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    British22174080001
    BOND, Michael Peter
    Barnrooden Farm
    Shuckburgh Road Priors Marston
    CV47 7RY Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    Barnrooden Farm
    Shuckburgh Road Priors Marston
    CV47 7RY Southam
    Warwickshire
    United KingdomBritishConsultant80816550001
    DEERING, Lorraine
    Blue Barns Cottage
    Harts Lane
    CO7 7QL Ardleigh
    Essex
    Amministratore
    Blue Barns Cottage
    Harts Lane
    CO7 7QL Ardleigh
    Essex
    BritishGroup Accountant89886380001
    EARP, John
    4 Bedford Road
    SS15 6PG Laindon
    Essex
    Amministratore
    4 Bedford Road
    SS15 6PG Laindon
    Essex
    BritishChartered Accountant67307010001
    LEES, Brian
    9b Ridge Avenue
    Marple
    SK6 7HJ Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    9b Ridge Avenue
    Marple
    SK6 7HJ Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director60016130001
    MACKINNON, Alan Robertson
    1 Gainsborough Road
    Shottery
    CV37 9FA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    1 Gainsborough Road
    Shottery
    CV37 9FA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishCompany Director75553010001
    SEVERN, John Philip
    26 Henry Laver Court
    CO3 3AF Colchester
    Essex
    Amministratore
    26 Henry Laver Court
    CO3 3AF Colchester
    Essex
    BritishCompany Director80671560002
    TAYLOR, Brian Reginald
    The Manor
    Marten
    SN8 3SJ Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    The Manor
    Marten
    SN8 3SJ Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director2197890003
    WILMAN, David John
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    15 Wentworth Close
    Hadleigh
    IP7 5SA Ipswich
    Suffolk
    BritishCompany Director22174080001
    WRIGHT, David Charles
    2 Marennes Crescent
    CO7 0RX Brightlingsea
    Essex
    Amministratore
    2 Marennes Crescent
    CO7 0RX Brightlingsea
    Essex
    British85449670001

    STOREYS INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 29 dic 2006
    Consegnato il 03 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 03 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 25 gen 2002
    Consegnato il 12 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties (or any of them) in any currency whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including land and premises at brantham,suffolk; sk 203799; property at earby,pendle,lancashire; la 863756; durbar mill,hereford rd,blackburn; la 393060; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,London as Security Trustee for Itself and Theother Finance Parties
    Transazioni
    • 12 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture of even date between troyess PLC (the parent) edlaw PLC (the company) the companies listed in the schedule 1 of the debenture (the charging companies) and the chargee
    Creato il 27 apr 2001
    Consegnato il 08 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the subordinated finance documents (as defined) on any account
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed of accession to a debenture dated 17 november 1999 as amended by a deed of amendment dated 26 january 2000 and a deed of accession and amendment dated 15 march 2000
    Creato il 17 mar 2000
    Consegnato il 05 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from the company and each of the obligors to the chargee under the finance documents (or any of them) and this debenture and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The key properties together with all buildings and fixtures (as defined). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dlj Capital Funding, Inc. as Security Agent on Behalf of Itself and Other Secured Parties
    Transazioni
    • 05 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 feb 1983
    Consegnato il 04 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. (See doc M12 for further details). Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transazioni
    • 04 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 18 feb 1983
    Consegnato il 24 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 1983Registrazione di un'ipoteca

    STOREYS INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 gen 2008Fine dell'amministrazione
    29 gen 2007Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nigel Millar
    Baker Tilly
    1st Floor
    EC4M 7AF 5 Old Bailey
    London
    Praticante
    Baker Tilly
    1st Floor
    EC4M 7AF 5 Old Bailey
    London
    Bruce Alexander Mackay
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praticante
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    2
    DataTipo
    14 feb 2010Data di scioglimento
    24 gen 2008Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Bruce Alexander Mackay
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praticante
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Nigel Millar
    Baker Tilly
    1st Floor
    EC4M 7AF 5 Old Bailey
    London
    Praticante
    Baker Tilly
    1st Floor
    EC4M 7AF 5 Old Bailey
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0