OCEAN PROPERTIES LIMITED

OCEAN PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOCEAN PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01655687
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OCEAN PROPERTIES LIMITED?

    • (4521) /
    • (7011) /
    • (9305) /

    Dove si trova OCEAN PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Annexe The Garden House
    Stelling Hall, Newton
    NE43 7UR Stocksfield
    Northumberland
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OCEAN PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ATHENAEUM DEVELOPMENTS LIMITED13 ago 198513 ago 1985
    WRIGHT & COMPANY (MANAGEMENT) LIMITED02 ago 198202 ago 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di OCEAN PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per OCEAN PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 29 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2010

    Stato del capitale al 05 mag 2010

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Pamela Wright il 29 apr 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Wallace Wright il 29 apr 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2009

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2008

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2006

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di OCEAN PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    POPE, Christopher John
    25 Morningside
    Rickleton
    NE38 9JH Washington
    Tyne & Wear
    Segretario
    25 Morningside
    Rickleton
    NE38 9JH Washington
    Tyne & Wear
    English47077290001
    WRIGHT, Elizabeth Claire
    Gardeners Cottage
    Stelling Hall, Newton
    NE43 7UR Stocksfield
    Northumberland
    Amministratore
    Gardeners Cottage
    Stelling Hall, Newton
    NE43 7UR Stocksfield
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Director71013240001
    WRIGHT, Neil Wallace
    The Garden House
    Stellinghall
    NE43 7UR Newton
    Northumberland
    Amministratore
    The Garden House
    Stellinghall
    NE43 7UR Newton
    Northumberland
    EnglandBritishCompany Director6464690003
    WRIGHT, Pamela
    The Garden House
    Stellinghall
    NE43 7UR Newton
    Northumberland
    Amministratore
    The Garden House
    Stellinghall
    NE43 7UR Newton
    Northumberland
    EnglandBritishDirector14582050003
    CRUTE, Geoffrey Taylor
    The Old Stables
    Newbus Grange Neasham
    DL2 1PE Darlington
    County Durham
    Segretario
    The Old Stables
    Newbus Grange Neasham
    DL2 1PE Darlington
    County Durham
    British37592130001
    CRUTE, Geoffrey Taylor
    The Old Stables
    Newbus Grange Neasham
    DL2 1PE Darlington
    County Durham
    Segretario
    The Old Stables
    Newbus Grange Neasham
    DL2 1PE Darlington
    County Durham
    British37592130001
    POPE, Christopher John
    25 Morningside
    Rickleton
    NE38 9JH Washington
    Tyne & Wear
    Segretario
    25 Morningside
    Rickleton
    NE38 9JH Washington
    Tyne & Wear
    English47077290001
    ARCHERS (SECRETARIAL) LIMITED
    Barton House 24 Yarm Road
    TS18 3NB Stockton On Tees
    Cleveland
    Segretario
    Barton House 24 Yarm Road
    TS18 3NB Stockton On Tees
    Cleveland
    45935490002

    OCEAN PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 25 mag 2005
    Consegnato il 27 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5 shop units on the north side of ocean road, south shields. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 27 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2005
    Consegnato il 05 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 05 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 giu 1992
    Consegnato il 17 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 apr 1988
    Consegnato il 12 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and hereditaments being:- 5 shop units on the north side of ocean road, south sheilds t/n ty 191425.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 05 set 1986
    Consegnato il 10 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 06 set 1985
    Consegnato il 16 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    South shields squash club, coston drive, south shields, county of tyne & wear. Tn ty 67536 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 16 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 lug 1985
    Consegnato il 31 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a northorn social club south sheilds and proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 16 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0