WARWICK LEASING LIMITED

WARWICK LEASING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWARWICK LEASING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01665252
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WARWICK LEASING LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova WARWICK LEASING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WARWICK LEASING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAPITAL BANK LEASING LIMITED01 set 199701 set 1997
    NWS LEASING LIMITED11 set 199211 set 1992
    DEANS COURT LEASING LIMITED21 lug 198321 lug 1983
    YAUGHTBROWN LIMITED20 set 198220 set 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di WARWICK LEASING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per WARWICK LEASING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 mar 2018

    9 pagineLIQ03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN a 1 More London Place London SE1 2AF in data 19 apr 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 mar 2017

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Colin Graham Dowsett come amministratore in data 08 mar 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Richard Owen Williams come amministratore in data 19 set 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 set 2015

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Michelle Antoinette Angela Johnson come segretario in data 23 mar 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Lloyds Secretaries Limited come segretario in data 23 mar 2016

    2 pagineAP04

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 feb 2016

    Stato del capitale al 01 feb 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2014

    18 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gerard Ashley Fox il 06 mar 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Owen Williams il 06 mar 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di WARWICK LEASING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02791894
    73512200003
    FOX, Gerard Ashley
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Amministratore
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish179100520001
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Segretario
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    JOHNSON, Michelle Antoinette Angela
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    Segretario
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    181101610001
    NIXON, Raymond
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    Segretario
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    British36433110016
    AITKEN, Joe
    19 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    19 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    British123316840001
    BARNSLEY, Lee Lawrence
    Fishermans Croft Moss Hill
    Stockton Brook
    ST9 9NW Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Fishermans Croft Moss Hill
    Stockton Brook
    ST9 9NW Stoke On Trent
    Staffordshire
    British61032150001
    BOCHENSKI, Anthony Joseph John
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    Amministratore
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    United KingdomBritish145644720001
    COOKE, Timothy John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritish120834610001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish46297770002
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    EnglandBritish152332230001
    GLASSCOE, Keith Roderick
    18 Stanmore Chase
    AL4 0EZ St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    18 Stanmore Chase
    AL4 0EZ St Albans
    Hertfordshire
    British126272230001
    GLEDHILL, Simon Christopher
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritish191439050001
    GREEN, Philip James
    Green Oaks
    Long Lane Haughton
    CW6 9RN Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Green Oaks
    Long Lane Haughton
    CW6 9RN Tarporley
    Cheshire
    British71021560002
    HALLIWELL, Christopher Roger
    3 Hough Green
    CH4 8JG Chester
    Amministratore
    3 Hough Green
    CH4 8JG Chester
    British4254150002
    HARE, Robert Brown
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    British64474720003
    ISAACS, Robin Alexander
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish115548350001
    JUKES, Anthony Wilfrid
    Potts Farm Chennell Park Lane
    TN30 6XA Tenterden
    Kent
    Amministratore
    Potts Farm Chennell Park Lane
    TN30 6XA Tenterden
    Kent
    British50640090001
    LAKIN, Helen Mary
    Gorphwysfa 6 Nant Road
    Bwlchgwyn
    LL11 5YN Wrexham
    Clwyd
    Amministratore
    Gorphwysfa 6 Nant Road
    Bwlchgwyn
    LL11 5YN Wrexham
    Clwyd
    BritainBritish41250190001
    MERCER, John Alexander
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    Amministratore
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    British4672880001
    MORRISSEY, John Michael
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    Amministratore
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    EnglandBritish94094650001
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Amministratore
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    British56296720007
    RICHARDS, Ceri
    Level 7 Bishopsgate Exchange
    155 Bishopsgate
    EC2M 3YB London
    Amministratore
    Level 7 Bishopsgate Exchange
    155 Bishopsgate
    EC2M 3YB London
    British70624480004
    SHARP, Yvonne Easton
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Midlothian
    Scotland
    Amministratore
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Midlothian
    Scotland
    United KingdomBritish126272440001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    British92235400001
    SMALLWOOD, James Douglas Mortimer
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritish110517930001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish64287260001
    VELDHUIZEN, Lambertus Hendrik
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomDutch152683120001
    WILLIAMS, Richard Owen
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Amministratore
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish164554190001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WARWICK LEASING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03283268
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WARWICK LEASING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An assignment of apmm charterer guarantee
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 02 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the assignor's right, title and interest in and to the assigned property on the terms of the assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bmi Marine Limited
    Transazioni
    • 02 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An assignment of apmm charterer guarantee
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 02 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the assignor's right, title and interest in and to the assigned property on the terms of the assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bmi Marine Limited
    Transazioni
    • 02 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of head lease agreement
    Creato il 21 lug 2004
    Consegnato il 05 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the assigned property being all rights and interests to in or connection with (a) the head lease agreement (b) each of the tax side letters. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of head lease agreement
    Creato il 21 lug 2004
    Consegnato il 05 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the assigned property being all rights and interests to in or connection with (a) the head lease agreement (b) each of the tax side letters. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of sub-charter agreement
    Creato il 21 lug 2004
    Consegnato il 30 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee all right title and interest in the assigned property relating to one 7,500 teu container ship hull no 3194, under construction at ihi marine united inc. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bmi Marine Limited
    Transazioni
    • 30 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of sub-charter agreement
    Creato il 21 lug 2004
    Consegnato il 30 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee all right title and interest in the assigned property relating to one 7,500 teu container ship hull no 3193, under construction at ihi marine united inc,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bmi Marine Limited
    Transazioni
    • 30 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Letter of charge
    Creato il 19 giu 1996
    Consegnato il 10 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of any account or accounts in the banks books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WARWICK LEASING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 mar 2017Inizio della liquidazione
    04 set 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0