DONCASTERS 1516 LIMITED

DONCASTERS 1516 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDONCASTERS 1516 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01669815
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DONCASTERS 1516 LIMITED?

    • lavorazioni meccaniche (25620) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova DONCASTERS 1516 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DONCASTERS 1516 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    F. V. C. LIMITED13 nov 199813 nov 1998
    FIRTH VICKERS FOUNDRY LIMITED29 apr 198329 apr 1983
    B & N (NO.63) LIMITED06 ott 198206 ott 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di DONCASTERS 1516 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per DONCASTERS 1516 LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al30 gen 2025

    Quali sono le ultime deposizioni per DONCASTERS 1516 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 13 mar 2025

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    That the company's entire share premium account is reduced to £0. 12/03/2025
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2025 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Stato del capitale al 05 feb 2025

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023

    1 pagineAA

    Nomina di Mr David John Egan come amministratore in data 04 lug 2024

    2 pagineAP01

    Modifica dei dettagli di Deritend International Limited come persona con controllo significativo il 15 mar 2024

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Deritend International Limited come persona con controllo significativo il 15 mar 2024

    2 paginePSC05

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    12 pagineMA

    Indirizzo della sede legale modificato da Forge Lane Killamarsh Sheffield S21 1BA England a 1 Park Row Leeds LS1 5AB in data 19 mar 2024

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Helen Barrett-Hague come segretario in data 08 mar 2024

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Helen Barrett-Hague come amministratore in data 08 mar 2024

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2024 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Repton House Bretby Business Park, Ashby Road Burton upon Trent Staffordshire DE15 0YZ England a Forge Lane Killamarsh Sheffield S21 1BA in data 20 set 2023

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    1 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DONCASTERS 1516 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EGAN, David John
    LS1 5AB Leeds
    1 Park Row
    England
    Amministratore
    LS1 5AB Leeds
    1 Park Row
    England
    United KingdomBritish324778100001
    QUINN, Michael Joseph
    LS1 5AB Leeds
    1 Park Row
    England
    Amministratore
    LS1 5AB Leeds
    1 Park Row
    England
    IrelandIrish268174890001
    BARRETT-HAGUE, Helen
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    Segretario
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    287748860001
    BROWN, Christopher John
    328 Newman Road
    S9 1LX Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    328 Newman Road
    S9 1LX Sheffield
    South Yorkshire
    British107518990001
    JACKSON, Howard Watson
    Red House Farm
    CV35 0EB Little Kineton
    Warwickshire
    Segretario
    Red House Farm
    CV35 0EB Little Kineton
    Warwickshire
    British34443700002
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Segretario
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    British141893610001
    MOLYNEUX, Ian
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    Segretario
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    British164532170001
    TILLEY, Michael John
    Silver Birches 189 Main Street
    LE67 1AH Thornton
    Leicestershire
    Segretario
    Silver Birches 189 Main Street
    LE67 1AH Thornton
    Leicestershire
    British60728390001
    ARMITAGE, Raymond
    14 Sparken Close
    S80 1BN Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    14 Sparken Close
    S80 1BN Worksop
    Nottinghamshire
    British3329300001
    ASTON, David John Spicer
    The Penthouse 20 Longdon Croft
    Copt Heath
    B93 9LJ Knowle
    Warwickshire
    Amministratore
    The Penthouse 20 Longdon Croft
    Copt Heath
    B93 9LJ Knowle
    Warwickshire
    British43094760001
    ASTON, Stephen Mark
    The Gables
    Rowley Avenue
    ST17 9AA Stafford
    Amministratore
    The Gables
    Rowley Avenue
    ST17 9AA Stafford
    United KingdomBritish287327450002
    BARRETT-HAGUE, Helen
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    Amministratore
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    EnglandBritish287804380001
    BEIGHTON, David Patrick
    11 Base Green Close
    S12 3FB Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    11 Base Green Close
    S12 3FB Sheffield
    South Yorkshire
    British48468360001
    BISSELL, David Michael
    10 Canford Crescent
    Codsall
    WV8 2AF Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    10 Canford Crescent
    Codsall
    WV8 2AF Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish1057860001
    BULL, George
    3 Murdoch Close
    Ferndale Manor
    NG22 8FE Farnsfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    3 Murdoch Close
    Ferndale Manor
    NG22 8FE Farnsfield
    Nottinghamshire
    British47402550004
    CLELAND, Robert John
    The Old Vicarage
    Pershore Road, Upton Snodsbury
    WR7 4NR Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Pershore Road, Upton Snodsbury
    WR7 4NR Worcester
    Worcestershire
    British66601290001
    DAVIS, Richard
    Holmley Bank Cottage
    Institute Terrace Billy Row
    DL15 9TB Crook
    County Durham
    Amministratore
    Holmley Bank Cottage
    Institute Terrace Billy Row
    DL15 9TB Crook
    County Durham
    British63658740001
    ELLIS, William Michael
    Manor Drive
    Worthington
    LE65 1RN Ashby-De-La-Zouch
    The Manor House
    Leicestershire
    Amministratore
    Manor Drive
    Worthington
    LE65 1RN Ashby-De-La-Zouch
    The Manor House
    Leicestershire
    United KingdomAmerican134919220003
    HARPER, Stanley Brian
    2 Jerome Way
    Burntwood
    WS7 9HS Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    2 Jerome Way
    Burntwood
    WS7 9HS Walsall
    West Midlands
    British3329270001
    HINKS, Duncan Andrew
    Millennium Court
    First Avenue
    DE14 2WH Burton-On-Trent
    Doncasters Group Limited
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Millennium Court
    First Avenue
    DE14 2WH Burton-On-Trent
    Doncasters Group Limited
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish164530200005
    HIPKINS, Graham
    Waresley Manor Cottage Manor Lane
    Waresley
    DY11 7XN Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    Waresley Manor Cottage Manor Lane
    Waresley
    DY11 7XN Kidderminster
    Worcestershire
    British61636950001
    JACKSON, Howard Watson
    Red House Farm
    CV35 0EB Little Kineton
    Warwickshire
    Amministratore
    Red House Farm
    CV35 0EB Little Kineton
    Warwickshire
    United KingdomBritish34443700002
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritish141893610001
    LEWIS, Eric James
    Rowan House
    32 Nursery Lane, Hopwas
    B78 3AS Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Rowan House
    32 Nursery Lane, Hopwas
    B78 3AS Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritish75455450001
    MARTLE, Simon David
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish151541840002
    MATHIESON, Kenneth
    17 Sandwith Road
    Todwick
    S31 0JP Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    17 Sandwith Road
    Todwick
    S31 0JP Sheffield
    South Yorkshire
    British55633200002
    MCCARTAN, John
    13 St Albans Road
    S10 4DN Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    13 St Albans Road
    S10 4DN Sheffield
    South Yorkshire
    British43354410001
    MOLYNEUX, Ian
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    United KingdomBritish75284220004
    MORGAN, Lyndon Alun
    19 Holly Grove
    Intake
    S12 2DA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    19 Holly Grove
    Intake
    S12 2DA Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish48468300001
    OXNARD, Lisa Marie
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish253562580001
    SCHURCH, Michael John
    Millennium Court
    First Avenue
    DE14 2WH Burton-On-Trent
    Doncasters Group Limited
    Staffordshire
    Amministratore
    Millennium Court
    First Avenue
    DE14 2WH Burton-On-Trent
    Doncasters Group Limited
    Staffordshire
    EnglandBritish42065200003
    TILLEY, Michael John
    Silver Birches 189 Main Street
    LE67 1AH Thornton
    Leicestershire
    Amministratore
    Silver Birches 189 Main Street
    LE67 1AH Thornton
    Leicestershire
    British60728390001
    WATERS, Henry Maxwell
    Trecot
    King Sterndale
    SK17 9SF Buxton
    Derbyshire
    Amministratore
    Trecot
    King Sterndale
    SK17 9SF Buxton
    Derbyshire
    British3329290001
    WATKINS, Richard Henry
    2 Forge Valley Way
    WV5 8JP Wombourne
    West Midlands
    Amministratore
    2 Forge Valley Way
    WV5 8JP Wombourne
    West Midlands
    EnglandBritish103768870001
    WILKINS, Ian
    13 West Bank Drive
    South Anston
    S31 7HT Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    13 West Bank Drive
    South Anston
    S31 7HT Sheffield
    South Yorkshire
    British48468390001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DONCASTERS 1516 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    LS1 5AB Leeds
    1 Park Row
    West Yorkshire
    England
    06 apr 2016
    LS1 5AB Leeds
    1 Park Row
    West Yorkshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Acts 1985 & 1989
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00450905
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per DONCASTERS 1516 LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    30 gen 201728 feb 2017La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0