WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED

WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWESTMINSTER BEAUMONT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01671730
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Suite 201 Second Floor Design Centre East
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PPP BEAUMONT PLC21 dic 198821 dic 1988
    BEAUMONT HEALTH CARE PLC27 ago 198727 ago 1987
    GLS 26 LIMITED13 ott 198213 ott 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jon Hather il 09 apr 2014

    2 pagineCH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 27 gen 2014

    • Capitale: GBP 0.25
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 21/01/2014
    RES13

    Cessazione della carica di Michael Parsons come amministratore

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 32 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 33 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jon Hather il 25 mar 2013

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    legacy

    15 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Mr Ian Portal come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jon Hather come segretario

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da * Suite 201 the Chambers Chelsea Harbour London SW10 0XF* in data 13 dic 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PORTAL, Ian
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Segretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    165754850001
    DUNCAN, David Gregor
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish97755760001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish68848420006
    BOTFIELD, Adrienne Elizabeth
    5 Camden Place
    SL8 5RW Bourne End
    Buckinghamshire
    Segretario
    5 Camden Place
    SL8 5RW Bourne End
    Buckinghamshire
    British35490330001
    CLANCY, Martin Bernard
    8 Henley Wood Road
    Earley
    RG6 7EE Reading
    Berkshire
    Segretario
    8 Henley Wood Road
    Earley
    RG6 7EE Reading
    Berkshire
    British40197260001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Segretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    LANGFORD, Jacqueline Ann
    10 Mariners Mews
    E14 3EQ London
    Segretario
    10 Mariners Mews
    E14 3EQ London
    British9517840001
    O'CONNELL, Kevin Daniel
    27 Stag Green Avenue
    AL9 5EB Hatfield
    Hertfordshire
    Segretario
    27 Stag Green Avenue
    AL9 5EB Hatfield
    Hertfordshire
    English15336730002
    PIPER, Maurice George
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    Segretario
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    British8141120001
    PURSE, Stephen John
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    Segretario
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    British58759290001
    BENN, Geoffrey Richard
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish73786580001
    CHURCHLEY, Peter Knight
    Rosevale House
    Woodside Lane
    SL4 2DW Windsor Forest
    Berkshire
    Amministratore
    Rosevale House
    Woodside Lane
    SL4 2DW Windsor Forest
    Berkshire
    EnglandBritish77173520001
    EASTERMAN, Philip Harry
    3 Oakview
    Hyde Heath
    HP6 5SE Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    3 Oakview
    Hyde Heath
    HP6 5SE Amersham
    Buckinghamshire
    British63476990001
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Amministratore
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    LORD, Peter Herent
    Holly Tree House
    39 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Holly Tree House
    39 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British2468810001
    MATTHEWS, Ian
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    Amministratore
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    United KingdomBritish143242660001
    MATTINSON, Graham Thomas
    Crantock House 6 Stratford Drive
    Wootton
    NN4 6JT Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Crantock House 6 Stratford Drive
    Wootton
    NN4 6JT Northampton
    Northamptonshire
    British76843330001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Irish116537370001
    MCNEILLY, Robert Henry, Dr
    Forge House
    Coleshill
    HP7 0LR Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Forge House
    Coleshill
    HP7 0LR Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish Northern Ireland10813190001
    MITCHELL, Nick
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    Amministratore
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    Englsih92869540001
    NOAR, Stephen John
    Hornbeams
    Swarraton
    SO24 9TQ Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    Hornbeams
    Swarraton
    SO24 9TQ Alresford
    Hampshire
    British64053050003
    PARSONS, Michael Dennis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish44895330007
    PATEL, Chaitanya Bhupendra, Dr
    The Thatched House
    Manor Way Oxshott
    KT22 0HU Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    The Thatched House
    Manor Way Oxshott
    KT22 0HU Leatherhead
    Surrey
    British63915280001
    PROBERT, David Henry
    4 Blakes Field Drive
    Barnt Green
    B45 8JT Birmingham
    Amministratore
    4 Blakes Field Drive
    Barnt Green
    B45 8JT Birmingham
    British1776640001
    PURSE, Stephen John
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    Amministratore
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    EnglandBritish58759290001
    SCOTT, Iain John Gosman
    37 Midmills Road
    IV2 3NZ Inverness
    Inverness Shire
    Amministratore
    37 Midmills Road
    IV2 3NZ Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritish40335260002
    SCOTT, Kenneth Cameron Knowles
    Weeke Hill
    TQ6 0JT Dartmouth
    Little Weeke
    Devon
    Amministratore
    Weeke Hill
    TQ6 0JT Dartmouth
    Little Weeke
    Devon
    United KingdomBritish86218520002
    STREET, Timothy William
    Flat 23 Park House
    16 Northfields
    SW18 1DD London
    Amministratore
    Flat 23 Park House
    16 Northfields
    SW18 1DD London
    Australian91455710001
    TORRANCE, David Winton Watt
    Allt A'Bruaich
    IV4 7HX Kiltarlity
    Inverness-Shire
    Amministratore
    Allt A'Bruaich
    IV4 7HX Kiltarlity
    Inverness-Shire
    UkBritish5901560006
    WEIGHT, James Dominic
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    Amministratore
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    EnglandBritish73750450005
    WILSON, Andrew Stephen
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Amministratore
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    United KingdomBritish82667700001

    WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 dic 2012
    Consegnato il 19 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited
    Transazioni
    • 19 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Amendment deed
    Creato il 27 ott 2006
    Consegnato il 08 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company as junior creditor has undertaken that if any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or any junior creditor receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities: in each case the junior creditor concerned shall hold the same upon trust for the security trustee and will promptly pay the same to the security trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Opco debenture accession deed
    Creato il 04 ago 2006
    Consegnato il 04 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each bridge obligor to the bridge finance parties or bridge overdraft banks (or any of them) and the opco secured obligations being all monies due or to become due from each opco obligor to the opco finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 04 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An intercreditor and subordination agreement
    Creato il 13 lug 2006
    Consegnato il 25 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subject to clause 10.2 if at any time prior to the discharge in full of the liabilities of the senior creditors, any lender or investor receives or recovers any payment or distribution of, or on account of or in relation to, any of the liabilities which is not permitted by clause 7 any amount by way of set-off in respect of any of the liabilities owed to them which does not give effect to a payment permitted by clause 7. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 25 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security accession deed
    Creato il 06 dic 2004
    Consegnato il 17 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charging companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of deposit account monies
    Creato il 21 nov 1988
    Consegnato il 23 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    The sum of £300,000 in an account in the name of the company an deposit with 3I group.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 23 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental legal charge
    Creato il 21 nov 1988
    Consegnato il 23 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Freehold premises situate at and k/a bushwood house 32 st. James' road edgbaston birmingham west midlands title no. Wm 410766 (not excluding the area shown in blue on plan 2 and which is currently under title no. Wm 439481).
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 23 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 15 set 1988
    Consegnato il 22 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the of the compahy, present & future. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 set 1988
    Consegnato il 22 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Herne place, london road, sunningdale, berkshire t/N. Bk 149893.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 dic 1987
    Consegnato il 16 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property k/as the stratford beaumont new street, stratford upon avon, warwickshire title no. Wk 298723 together with all buildings & fixtures & all plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Barclays De Zoete Wedd Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 dic 1987
    Consegnato il 16 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property k/as the prestbury beaumont, collar house drive, prestbury, macclesfield, cheshire. Title no. Ch 261564 together with all buildings & fixtures & all plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Barclays De Zoete Wedd Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 09 ott 1987
    Consegnato il 21 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bushwood house, 32 st james's road, edgbaston birmingham, west midlands. Title no. Wk 306637.
    Persone aventi diritto
    • Barclays De Zoete Wedd Limited
    Transazioni
    • 21 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Assignment
    Creato il 29 giu 1987
    Consegnato il 17 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from beaumont edgbaston limited to the chargee on any account whatsoever. Under the terms of a facility letter dated 10/4/87
    Brevi particolari
    All right title & interest in all sums standing to the crecdit of an account of company and beaumont edgbaston limited with barclays bank PLC designated "barclays de zoele wedd limited re:- beaumont edgbaston limited cash collataral account".
    Persone aventi diritto
    • Barclays De Zoete Wedd Limited
    Transazioni
    • 17 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental charge.
    Creato il 02 apr 1987
    Consegnato il 16 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises k/a mavon house 19/21 heatherley road camberley title no:- sy 403451 together with buildings fixtures fixed plant machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 16 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental charge.
    Creato il 02 apr 1987
    Consegnato il 16 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises k/a dane house clinic 52 dyke road avenue brighton title no:- esx 18133. together with buildings fixtures fixed plant machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 16 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental charge.
    Creato il 02 apr 1987
    Consegnato il 16 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises situate in the parishes of palgrave and wortham suffolk. Totether with all buildings fixtures plant machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 16 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental charge.
    Creato il 02 apr 1987
    Consegnato il 16 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a cromers close nursing care centre 56 kenilworth road coventry west midlands. Title no:- wm 321229. together with all buildings fixtures plant machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 16 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental charge
    Creato il 02 apr 1987
    Consegnato il 16 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge by way of legal mortgage - f/h land & premises situate at burston in the county of norfolk together with buildings & fixtures & fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Indsutry PLC.
    Transazioni
    • 16 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental charge
    Creato il 02 apr 1987
    Consegnato il 16 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge by way of legal mortgage:- f/h land and premises situate at roydon road, diss, in county of norfolk together with all buildings & fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 16 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental charge.
    Creato il 02 apr 1987
    Consegnato il 16 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge by way of legal mortgage:- f/h land and premises at ramsey in hampshire situate at the north of winchester road, A31 & to the east of braishfield road together with all buildings & fixture including fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 16 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Assignment of deposit account moneys.
    Creato il 31 dic 1986
    Consegnato il 08 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Sum of £2,500,000 deposited with investors in industry group PLC.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 08 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 01 ago 1986
    Consegnato il 19 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC.
    Transazioni
    • 19 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    Assignment of deposit account.
    Creato il 19 dic 1985
    Consegnato il 23 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed charge upon all monies presently or from time to time standing to the credit of the company's deposit account with investors in industry PLC.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 23 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 16 lug 1985
    Consegnato il 16 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property to the north east of filmer lane sevenoaks kent.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 16 lug 1985
    Consegnato il 16 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a redcourt 27 stanhope road croydon t/n:- sy 247994.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0