EX SPEREC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEX SPEREC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 01672532
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EX SPEREC?

    • (9999) /

    Dove si trova EX SPEREC?

    Indirizzo della sede legale
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EX SPEREC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EX SPEREC LIMITED23 set 200523 set 2005
    SPEREC BULLOCK LIMITED02 mar 198302 mar 1983
    BRIGHTBECK LIMITED19 ott 198219 ott 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di EX SPEREC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per EX SPEREC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Re reg res 11/05/2010
    RES13

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Re dividend of 49998 17/05/2010
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Assenso alla riregistrazione

    1 pagineFOA-RR

    Certificato di ri-registrazione da Limitato a Illimitato

    1 pagineCERT3

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    14 pagineMAR

    Riregistrazione da società a responsabilità limitata privata a società a responsabilità illimitata privata

    1 pagineRR05

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    4 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 apr 2010

    Stato del capitale al 21 mag 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di EX SPEREC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Segretario
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    CRANDON, Geoffrey Marcin Roderick
    5 Abbey Close
    RG40 1WB Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    5 Abbey Close
    RG40 1WB Wokingham
    Berkshire
    British27456720001
    FODEN, George Harrington
    The Red House
    Bearswood End
    HP9 2NR Beaconsfield
    Bucks
    Segretario
    The Red House
    Bearswood End
    HP9 2NR Beaconsfield
    Bucks
    British8636290001
    PRICE, Alan Martin Andrew
    30 Offington Gardens
    BN14 9AU Worthing
    West Sussex
    Segretario
    30 Offington Gardens
    BN14 9AU Worthing
    West Sussex
    British5634100001
    BUTCHER, Paul David Leslie
    70 High Street
    Kimpton
    SG4 8PT Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    70 High Street
    Kimpton
    SG4 8PT Hitchin
    Hertfordshire
    British5634110001
    DUNNINGHAM, Paul
    Bird In Hand Green End
    Braughing
    SG11 2PG Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Bird In Hand Green End
    Braughing
    SG11 2PG Ware
    Hertfordshire
    British34932760001
    FODEN, George Harrington
    The Red House
    Bearswood End
    HP9 2NR Beaconsfield
    Bucks
    Amministratore
    The Red House
    Bearswood End
    HP9 2NR Beaconsfield
    Bucks
    British8636290001
    STEPHENSON, Daniel Francis
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Irish71140790004
    MONTPELLIER GROUP NOMINEES LIMITED
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    41291250009

    EX SPEREC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 30 set 1992
    Consegnato il 16 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees on any account whatsoever under the termsof the master facilities agreement DATED12 february 1992 and this deed
    Brevi particolari
    See form 395 ref M118. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 23 gen 1992
    Consegnato il 03 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees as defined in the guarantee and debenture
    Brevi particolari
    See form 395 ref M181. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 24 giu 1983
    Consegnato il 29 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (1) l/h properties comprised in 20 leases of flats on the first to fourth floors of the building k/a wendover buildings, chilton street, westminster. (2) the benefit of the company in a building contract dated 20/5/83.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Company Limited
    Transazioni
    • 29 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0