ESSEX CORRUGATED CONTAINERS COMPANY LIMITED

ESSEX CORRUGATED CONTAINERS COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàESSEX CORRUGATED CONTAINERS COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01674440
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ESSEX CORRUGATED CONTAINERS COMPANY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ESSEX CORRUGATED CONTAINERS COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MSQ PARTNERS LTD
    6 York Street
    W1U 6PL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ESSEX CORRUGATED CONTAINERS COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COUTTS PACKAGING LIMITED24 dic 199724 dic 1997
    C. A. COUTTS LIMITED28 ott 198228 ott 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di ESSEX CORRUGATED CONTAINERS COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ESSEX CORRUGATED CONTAINERS COMPANY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ESSEX CORRUGATED CONTAINERS COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 mag 2014

    Stato del capitale al 15 mag 2014

    • Capitale: GBP 2,592,800
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Daniel Yardley come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Peter David Reid come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Dean Wright come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Media Square Plc 6 York Street London W1U 6PL United Kingdom* in data 22 apr 2013

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Ashish Shah come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Colin Brigden come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    2 pagineAR01

    Cessazione della carica di Bruce Winfield come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Bruce Winfield come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Dean Anthony Wright come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2010

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Colin John Brigden come segretario

    1 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Media Square Plc, Clarence Mill, Clarence Road Bollington Cheshire SK105JZ* in data 01 dic 2009

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di ESSEX CORRUGATED CONTAINERS COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHAH, Ashish
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    Segretario
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    164775600001
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    EnglandBritishGroup Ceo147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer180507300001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    Segretario
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    British7666350001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147341870001
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    BritishAccountant53461320002
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Segretario
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    ALEXANDER, Charles Stuart
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    Amministratore
    24 Waveney Close
    E1W 2JL London
    BritishFinance Director7666350001
    BELL, Patrick Charles
    Coles Barn
    Belchamp Otten
    CO10 7BG Sudbury
    Suffolk
    Amministratore
    Coles Barn
    Belchamp Otten
    CO10 7BG Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishPoint Of Sale-Sales Director71758630001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant75720570001
    CAHN, Christopher Charles
    39 Anchorage Point
    Cuba Street
    E14 8NF London
    Amministratore
    39 Anchorage Point
    Cuba Street
    E14 8NF London
    BritishSales Director85328320001
    ESSEX, Norman Arthur
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Elm Green Farm
    Danbury
    CM3 4DW Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Director7666380001
    ESSEX, Robert Thomas Tickler
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    Amministratore
    21 Rylett Road
    W12 9SS London
    EnglandBritishCompany Director7666390002
    FIX, Brian Stanley
    Tilehurst Well Lane
    Danbury
    CM3 4AB Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Tilehurst Well Lane
    Danbury
    CM3 4AB Chelmsford
    Essex
    BritishDirector2873300002
    FOWLER, Robert Edward
    42 Foord Road
    Lenham
    ME17 2QN Maidstone
    Kent
    Amministratore
    42 Foord Road
    Lenham
    ME17 2QN Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishDesign Director26408910001
    GODRIDGE, Warren Stafford
    Aurora Three South Dock Marina
    Rope Street
    SE16 1TX London
    Amministratore
    Aurora Three South Dock Marina
    Rope Street
    SE16 1TX London
    BritishProduction Director58083640001
    HAMPSON, Andrew Robert
    16 Codling Close
    E1 London
    Amministratore
    16 Codling Close
    E1 London
    BritishSales & Marketing Director64768340002
    MCLAUGHLIN, William Shaw
    50
    The Hawthorns
    RG10 9TS Charvil
    Amministratore
    50
    The Hawthorns
    RG10 9TS Charvil
    United KingdomBritishDirector123346890001
    MIDDLETON, Arthur Jeremy Barritt
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    Amministratore
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    EnglandBritishCompany Director72455560001
    SAYSELL, Richard Geoffrey
    33 Lizban Street
    SE3 8SS London
    Amministratore
    33 Lizban Street
    SE3 8SS London
    BritishCommercial Director50920320001
    SMITH, Anthony Michael
    4 Highfield
    Rowdow Lane Knatts Valley
    TN15 6XN Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    4 Highfield
    Rowdow Lane Knatts Valley
    TN15 6XN Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Director26408890002
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Amministratore
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant147948820001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    England
    EnglandBritishDirector159138180001

    ESSEX CORRUGATED CONTAINERS COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 ott 2004
    Consegnato il 22 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 10 dic 1998
    Consegnato il 18 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1 to 3 yeo street london borough of tower hamlets t/no LN39962 and the proceeds of sale thereof together with an assignment of the goodwill and connection of any business or businesses from time to time together with the full benefit of all licences including any registrations.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 giu 1993
    Consegnato il 08 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being land and buildings adjoining blewetts wharf, violet road, bromley, l/b of tower hamlets t/no. 388962 and the proceeds of sale thereof by way of assignment the goodwill and connection of the business and the full benefit of all licences held. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 apr 1988
    Consegnato il 15 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Blewetts wharf, violet road, l/b of tower hamlets t/n 461253 the proceeds of sale floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 dic 1982
    Consegnato il 15 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Caspian wharf violet road, bow, london E3 title no: ln 230188 a/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0