MURSTON PLANT LIMITED

MURSTON PLANT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMURSTON PLANT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01688195
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MURSTON PLANT LIMITED?

    • Altre attività di costruzione specializzate n.c.a. (43999) / Costruzioni

    Dove si trova MURSTON PLANT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 14 The Eurogate Business Park
    TN24 8SB Ashford
    Kent
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MURSTON PLANT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per MURSTON PLANT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 feb 2016

    Stato del capitale al 10 feb 2016

    • Capitale: GBP 105,004
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Mews Princes Parade Hythe Kent CT21 6AQ a Unit 14 the Eurogate Business Park Ashford Kent TN24 8SB in data 10 feb 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 gen 2015

    Stato del capitale al 07 gen 2015

    • Capitale: GBP 105,004
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    10 pagineAA

    Nomina di Mrs Danielle Anne Scott come segretario in data 01 ago 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Michael Zielinski come segretario in data 31 lug 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2014

    Stato del capitale al 15 apr 2014

    • Capitale: GBP 105,004
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 016881950008

    17 pagineMR01

    Nomina di Mr Andrew Michael Zielinski come segretario

    2 pagineAP03

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    10 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Darrell Marcus Healey il 11 apr 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di Declan Cogley come amministratore

    1 pagineTM01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di John Taylor come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Declan Aidan Cogley come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di MURSTON PLANT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SCOTT, Danielle Anne
    The Eurogate Business Park
    TN24 8SB Ashford
    Unit 14
    Kent
    England
    Segretario
    The Eurogate Business Park
    TN24 8SB Ashford
    Unit 14
    Kent
    England
    190261100001
    HEALEY, Darrell Marcus
    The Eurogate Business Park
    TN24 8SB Ashford
    Unit 14
    Kent
    England
    Amministratore
    The Eurogate Business Park
    TN24 8SB Ashford
    Unit 14
    Kent
    England
    EnglandBritishSurveyor57603740016
    ALLAN, Christine Joyce
    Place Farm Barn The Green
    Woodchurch
    TN26 3PF Ashford
    Kent
    Segretario
    Place Farm Barn The Green
    Woodchurch
    TN26 3PF Ashford
    Kent
    BritishCompany Secretary/Director41651210001
    FOREMAN, Terence David
    4 Old Fold
    CT5 3NL Chestfield
    Kent
    Segretario
    4 Old Fold
    CT5 3NL Chestfield
    Kent
    BritishAccountant248020990001
    MACKMAN, Michael
    Downsview Sandy Hurst Lane
    TN25 4PE Ashford
    Kent
    Segretario
    Downsview Sandy Hurst Lane
    TN25 4PE Ashford
    Kent
    British3839540001
    MANNERING, Linda Marion
    47 Bournewood
    Hamstreet
    TN26 2HL Ashford
    Kent
    Segretario
    47 Bournewood
    Hamstreet
    TN26 2HL Ashford
    Kent
    British65280390001
    TAYLOR, John
    Princes Parade
    CT21 6AQ Hythe
    The Mews
    Kent
    England
    Segretario
    Princes Parade
    CT21 6AQ Hythe
    The Mews
    Kent
    England
    162007730001
    ZIELINSKI, Andrew Michael
    Princes Parade
    CT21 6AQ Hythe
    The Mews
    Kent
    England
    Segretario
    Princes Parade
    CT21 6AQ Hythe
    The Mews
    Kent
    England
    185498300001
    ALLAN, Christine Joyce
    Place Farm Barn The Green
    Woodchurch
    TN26 3PF Ashford
    Kent
    Amministratore
    Place Farm Barn The Green
    Woodchurch
    TN26 3PF Ashford
    Kent
    BritishCompany Secretary/Director41651210001
    ALLAN, Roy James
    Place Farm Barn
    The Green Woodchurch
    TN26 3PF Ashford
    Kent
    Amministratore
    Place Farm Barn
    The Green Woodchurch
    TN26 3PF Ashford
    Kent
    BritishCompany Director16839670002
    ALLAN, Stuart James
    8 Lucilla Avenue
    Clarendon Heights
    TN23 3PS Ashford
    Kent
    Amministratore
    8 Lucilla Avenue
    Clarendon Heights
    TN23 3PS Ashford
    Kent
    BritishManager82368180001
    AUSTIN, Barry Keith
    34 Roseleigh Road
    ME10 1RS Sittingbourne
    Kent
    Amministratore
    34 Roseleigh Road
    ME10 1RS Sittingbourne
    Kent
    BritishPlant Contractor3839550001
    AUSTIN, Pauline Joyce Carol
    34 Roseleigh Road
    ME10 1RS Sittingbourne
    Kent
    Amministratore
    34 Roseleigh Road
    ME10 1RS Sittingbourne
    Kent
    BritishPlant Contractor3839560001
    BEER, Barbara
    Rebar The Street
    Bossingham Stelling Minnis
    CT4 6DY Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Rebar The Street
    Bossingham Stelling Minnis
    CT4 6DY Canterbury
    Kent
    BritishPlant Contractor3839570001
    BEER, Leslie Rex
    Rebar The Street
    Bossingham Stelling Minnis
    CT4 6DY Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Rebar The Street
    Bossingham Stelling Minnis
    CT4 6DY Canterbury
    Kent
    BritishPlant Contractor3839580001
    COGLEY, Declan Aidan
    Princes Parade
    CT21 6AQ Hythe
    The Mews
    Kent
    England
    Amministratore
    Princes Parade
    CT21 6AQ Hythe
    The Mews
    Kent
    England
    EnglandEnglishDirector80639400001
    FOREMAN, Terence David
    4 Old Fold
    CT5 3NL Chestfield
    Kent
    Amministratore
    4 Old Fold
    CT5 3NL Chestfield
    Kent
    EnglandBritishAccountant248020990001
    MACKMAN, Doreen Ann
    Downsview Sandy Hurst Lane
    TN25 4PE Ashford
    Kent
    Amministratore
    Downsview Sandy Hurst Lane
    TN25 4PE Ashford
    Kent
    BritishPlant Contractor3839590001
    MACKMAN, Michael
    16 Hoads Wood Gardens
    Sandyhurst Lane
    TN25 4QB Ashford
    Kent
    Amministratore
    16 Hoads Wood Gardens
    Sandyhurst Lane
    TN25 4QB Ashford
    Kent
    United KingdomBritishPlant Hire Expert3839540002
    MACKMAN, Michael
    16 Hoads Wood Gardens
    Sandyhurst Lane
    TN25 4QB Ashford
    Kent
    Amministratore
    16 Hoads Wood Gardens
    Sandyhurst Lane
    TN25 4QB Ashford
    Kent
    United KingdomBritishPlant Contractor3839540002

    MURSTON PLANT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 mar 2014
    Consegnato il 04 mar 2014
    In corso
    Breve descrizione
    (I) all freehold and leasehold land and buildings of the company both present and future including the land and buildings specified in section 2 of the schedule and all trade fixtures and fittings and all fixed plant and machinery from time to time in or on any such land and buildings;. (Ii) all patents, patent applications, trade marks, trade names, registered designs, copyrights, knowhow, and other intellectual property rights and all licences and ancillary rights and benefits (including royalties fees and other income deriving from the same ) now owned or at any time hereafter to be owned by the company. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Nucleus Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 04 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 09 mag 2005
    Consegnato il 20 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 1995
    Consegnato il 26 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £133,349 together with all other monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of an agreement of even date
    Brevi particolari
    All those items of plant vehicles and tools specifically referred to in the charge and all items of plant vehicles and tools from time to time coming into the absolute ownership of the company which are not subject to the provision of any hire purchase agreement.
    Persone aventi diritto
    • Mr & Mrs M Mackman Mr and Mrs B K Austin and Mr and Mrs R L Beer
    Transazioni
    • 26 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 09 ago 1993
    Consegnato il 20 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £26,566.70
    Brevi particolari
    All sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 20 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 gen 1992
    Consegnato il 22 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 19 ago 1991
    Consegnato il 31 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £29098.96 due from the company to the chargee under the terms of the agreement.
    Brevi particolari
    All its right, title & interest in & to all sums payable under the insurance.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited.
    Transazioni
    • 31 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 11 giu 1991
    Consegnato il 20 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 20 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 mag 1991
    Consegnato il 31 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the south west side of whitfield road ashford kent, t/n:- k 689506, and the proceeds of sale by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 20 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0