SSE UTILITY SERVICES LIMITED

SSE UTILITY SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSSE UTILITY SERVICES LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01689416
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SSE UTILITY SERVICES LIMITED?

    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni

    Dove si trova SSE UTILITY SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No.1 Forbury Place
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SSE UTILITY SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SSE UTILITY SERVICES PLC08 feb 200208 feb 2002
    M.P. BURKE PLC29 dic 198229 dic 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di SSE UTILITY SERVICES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2014
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2014
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SSE UTILITY SERVICES LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 ago 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 ago 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SSE UTILITY SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per SSE UTILITY SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Nathan Sanders come amministratore in data 11 apr 2025

    2 pagineAP01

    Nomina di Nathan Sanders come segretario in data 11 apr 2025

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Mohammed Shehzad Khalid come segretario in data 11 apr 2025

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Mohammed Shehzad Khalid come amministratore in data 11 apr 2025

    1 pagineTM01

    Ripristino per ordine del tribunale

    2 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr Mohammed Shehzad Khalid come segretario in data 29 mar 2021

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Brian Dominic Sharma come segretario in data 29 mar 2021

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Brian Dominic Sharma come amministratore in data 29 mar 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stuart John Hogarth come amministratore in data 29 mar 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Rodney Alexander Grubb come amministratore in data 29 mar 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mohammed Shehzad Khalid come amministratore in data 28 mar 2021

    2 pagineAP01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del segretario cambiati per Brian Dominic Sharma il 02 ott 2017

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Brian Dominic Sharma il 02 ott 2017

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Sse Contracting Group Limited come persona con controllo significativo il 02 ott 2017

    2 paginePSC05

    Notifica di Sse Contracting Group Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Modifica dei dettagli di una persona con controllo significativo

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Stuart John Hogarth il 02 ott 2017

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 55 Vastern Road Reading Berkshire RG1 8BU a No.1 Forbury Place 43 Forbury Road Reading RG1 3JH in data 02 ott 2017

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Christopher Michael Hillman come amministratore in data 01 ott 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark William Mathieson come amministratore in data 12 dic 2014

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SSE UTILITY SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANDERS, Nathan
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    Segretario
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    335365360001
    SANDERS, Nathan
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    Amministratore
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    EnglandBritish335365880001
    DONNELLY, Lawrence John Vincent
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Segretario
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    British62794440002
    HOLLINGSHEAD, Stephan
    Wales Hall Farm
    Church Street, Wales
    S26 5LQ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Wales Hall Farm
    Church Street, Wales
    S26 5LQ Sheffield
    South Yorkshire
    British69060440001
    KHALID, Mohammed Shehzad
    Queen Anne Dr
    EH28 8PL Newbridge
    Unit 4
    United Kingdom
    Segretario
    Queen Anne Dr
    EH28 8PL Newbridge
    Unit 4
    United Kingdom
    283009090001
    MURPHY, Neil Francis
    Gransden 60a Cutbush Lane
    Shinfield
    RG2 9AG Reading
    Berkshire
    Segretario
    Gransden 60a Cutbush Lane
    Shinfield
    RG2 9AG Reading
    Berkshire
    British65704970001
    SHARMA, Brian Dominic
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    Segretario
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    180723120001
    TANNER, Elizabeth Anne
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    United Kingdom
    164973530001
    TAYLOR, Kent, Mr.
    Bawtry Road
    Bessacarr
    DN4 7BT Doncaster
    Rybeck House, 154
    South Yorkshire
    Segretario
    Bawtry Road
    Bessacarr
    DN4 7BT Doncaster
    Rybeck House, 154
    South Yorkshire
    British4434070003
    BURKE, Martyn Patrick
    Hickleton House Manor Farm
    Barnburgh
    DN5 7EH Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Hickleton House Manor Farm
    Barnburgh
    DN5 7EH Doncaster
    South Yorkshire
    British3856640001
    BURKE, Nora Helen
    Hickleton House Manor Farm
    Barnburgh
    DN5 7EH Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Hickleton House Manor Farm
    Barnburgh
    DN5 7EH Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish16568100001
    CASLEY, Henry Roberts
    Dogmore Cottage
    Stoke Row
    RG9 5PD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Dogmore Cottage
    Stoke Row
    RG9 5PD Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritish21786610001
    CHILDS, Brian
    41 Markbrook Drive
    High Green
    S30 4FP Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    41 Markbrook Drive
    High Green
    S30 4FP Sheffield
    South Yorkshire
    British31807140001
    COYNE, John Francis
    23 Maple Road
    DL10 4BW Richmond
    North Yorkshire
    Amministratore
    23 Maple Road
    DL10 4BW Richmond
    North Yorkshire
    EnglandBritish7383400002
    CULBERT, Paul
    55 Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    Berkshire
    Amministratore
    55 Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    Berkshire
    British85030070002
    DALE, Peter Ernest
    5 Glencarse Home Farm Cottages
    Glencarse
    PH2 7LF Perth
    Perthshire
    Amministratore
    5 Glencarse Home Farm Cottages
    Glencarse
    PH2 7LF Perth
    Perthshire
    British106575450001
    DONNELLY, Lawrence John Vincent
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Amministratore
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    ScotlandBritish62794440002
    DUNLOP, John Michael
    The Old Manse 22 Chestnut Avenue
    LS22 6SE Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Manse 22 Chestnut Avenue
    LS22 6SE Wetherby
    West Yorkshire
    British55845230001
    FORBES, James Alexander
    Rydale Lodge
    1a Racecourse View
    KA7 2TS Ayr
    Ayrshire
    Amministratore
    Rydale Lodge
    1a Racecourse View
    KA7 2TS Ayr
    Ayrshire
    British141444100001
    GAUNTLETT, David Michael
    1 Poplar Close
    Baughurst
    RG26 5LH Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    1 Poplar Close
    Baughurst
    RG26 5LH Basingstoke
    Hampshire
    British55769350001
    GRAY, David Mclaren
    Dykeneuk
    Butterstone
    PH8 0HA Dunkeld
    Perthshire
    Amministratore
    Dykeneuk
    Butterstone
    PH8 0HA Dunkeld
    Perthshire
    ScotlandBritish140884530001
    GRUBB, Rodney Alexander
    Peasiehill Road
    Elliot Industrial Estate
    DD11 2NJ Arbroath
    Sse Depot
    Angus
    Amministratore
    Peasiehill Road
    Elliot Industrial Estate
    DD11 2NJ Arbroath
    Sse Depot
    Angus
    United KingdomBritish150322280001
    HART, James, Doctor
    Skerrols East Road
    St Georges Hill
    KT13 0LF Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Skerrols East Road
    St Georges Hill
    KT13 0LF Weybridge
    Surrey
    British10014240003
    HILLMAN, Christopher Michael
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    Ireland
    Amministratore
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    Ireland
    EnglandBritish17572470002
    HOGARTH, Stuart John
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    Amministratore
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish150321920001
    HOOD, Colin William
    1 Wharfe Lane
    RG9 2LL Henley
    Amministratore
    1 Wharfe Lane
    RG9 2LL Henley
    British80184130001
    KHALID, Mohammed Shehzad
    Queen Anne Drive
    EH28 8PL Newbridge
    Unit 4
    Amministratore
    Queen Anne Drive
    EH28 8PL Newbridge
    Unit 4
    United KingdomBritish282645380001
    MARCHANT, Ian Derek
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish29951280003
    MATHIESON, Mark William
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    Ireland
    Amministratore
    Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    55
    Berkshire
    Ireland
    United KingdomBritish102328560002
    MOREA, John Victor
    RG5
    Amministratore
    RG5
    United KingdomBritish161089110001
    MURRAY, Alan George
    6 Field Way
    BH21 3XH Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    6 Field Way
    BH21 3XH Wimborne
    Dorset
    United KingdomBritish86906500001
    POLLARD, Charles Nicholas
    4 Newton Avenue
    TN10 4RP Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    4 Newton Avenue
    TN10 4RP Tonbridge
    Kent
    British58299880001
    POLLARD, Stephen Godfrey
    41 Common Close
    Horsell
    GU21 4DB Woking
    Surrey
    Amministratore
    41 Common Close
    Horsell
    GU21 4DB Woking
    Surrey
    British32781400001
    ROPER, Peter John
    4 Rances Lane
    RG40 2LH Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    4 Rances Lane
    RG40 2LH Wokingham
    Berkshire
    British63451780001
    SHARMA, Brian Dominic
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    Amministratore
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    United Kingdom
    EnglandBritish180444150001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SSE UTILITY SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    England
    06 apr 2016
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No.1 Forbury Place
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02471438
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SSE UTILITY SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 15 feb 1988
    Consegnato il 01 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east side of of dunn st newcastle upon tyne.
    Persone aventi diritto
    • T S B England & Wales PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 feb 1988
    Consegnato il 01 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land forming part of former property repair depot bowburn county durham.
    Persone aventi diritto
    • Tsb England & Wales PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 30 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Secured debenture
    Creato il 12 set 1986
    Consegnato il 24 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £215,000 and all other monies due or to become due from the company t o the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including motor cars, goodwill,office equipment uncalled capita l plant & machinery intellectual property & other rights.
    Persone aventi diritto
    • British Coal Enterprise Limited.
    Transazioni
    • 24 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 03 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture and guarantee
    Creato il 19 apr 1984
    Consegnato il 03 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Trustees Savings Bank England and Wales
    Transazioni
    • 03 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 29 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 ago 1983
    Consegnato il 02 set 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company devoguild limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1983Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0