SSE UTILITY SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SSE UTILITY SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01689416 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SSE UTILITY SERVICES LIMITED?
- Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
Dove si trova SSE UTILITY SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | No.1 Forbury Place 43 Forbury Road RG1 3JH Reading United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SSE UTILITY SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SSE UTILITY SERVICES PLC | 08 feb 2002 | 08 feb 2002 |
| M.P. BURKE PLC | 29 dic 1982 | 29 dic 1982 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SSE UTILITY SERVICES LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2014 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2014 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2013 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SSE UTILITY SERVICES LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 01 ago 2016 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 15 ago 2016 |
| Scaduto | Sì |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SSE UTILITY SERVICES LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per SSE UTILITY SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nomina di Nathan Sanders come amministratore in data 11 apr 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Nathan Sanders come segretario in data 11 apr 2025 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Mohammed Shehzad Khalid come segretario in data 11 apr 2025 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Mohammed Shehzad Khalid come amministratore in data 11 apr 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Ripristino per ordine del tribunale | 2 pagine | AC92 | ||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Nomina di Mr Mohammed Shehzad Khalid come segretario in data 29 mar 2021 | 3 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Brian Dominic Sharma come segretario in data 29 mar 2021 | 2 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Brian Dominic Sharma come amministratore in data 29 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Stuart John Hogarth come amministratore in data 29 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Rodney Alexander Grubb come amministratore in data 29 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Mohammed Shehzad Khalid come amministratore in data 28 mar 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Ripristino per ordine del tribunale | 3 pagine | AC92 | ||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Dettagli del segretario cambiati per Brian Dominic Sharma il 02 ott 2017 | 1 pagine | CH03 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Brian Dominic Sharma il 02 ott 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Modifica dei dettagli di Sse Contracting Group Limited come persona con controllo significativo il 02 ott 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||
Notifica di Sse Contracting Group Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||
Modifica dei dettagli di una persona con controllo significativo | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Stuart John Hogarth il 02 ott 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 55 Vastern Road Reading Berkshire RG1 8BU a No.1 Forbury Place 43 Forbury Road Reading RG1 3JH in data 02 ott 2017 | 1 pagine | AD01 | ||
Cessazione della carica di Christopher Michael Hillman come amministratore in data 01 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Mark William Mathieson come amministratore in data 12 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di SSE UTILITY SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDERS, Nathan | Segretario | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | 335365360001 | |||||||
| SANDERS, Nathan | Amministratore | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | England | British | 335365880001 | |||||
| DONNELLY, Lawrence John Vincent | Segretario | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | 62794440002 | ||||||
| HOLLINGSHEAD, Stephan | Segretario | Wales Hall Farm Church Street, Wales S26 5LQ Sheffield South Yorkshire | British | 69060440001 | ||||||
| KHALID, Mohammed Shehzad | Segretario | Queen Anne Dr EH28 8PL Newbridge Unit 4 United Kingdom | 283009090001 | |||||||
| MURPHY, Neil Francis | Segretario | Gransden 60a Cutbush Lane Shinfield RG2 9AG Reading Berkshire | British | 65704970001 | ||||||
| SHARMA, Brian Dominic | Segretario | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | 180723120001 | |||||||
| TANNER, Elizabeth Anne | Segretario | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | 164973530001 | |||||||
| TAYLOR, Kent, Mr. | Segretario | Bawtry Road Bessacarr DN4 7BT Doncaster Rybeck House, 154 South Yorkshire | British | 4434070003 | ||||||
| BURKE, Martyn Patrick | Amministratore | Hickleton House Manor Farm Barnburgh DN5 7EH Doncaster South Yorkshire | British | 3856640001 | ||||||
| BURKE, Nora Helen | Amministratore | Hickleton House Manor Farm Barnburgh DN5 7EH Doncaster South Yorkshire | England | British | 16568100001 | |||||
| CASLEY, Henry Roberts | Amministratore | Dogmore Cottage Stoke Row RG9 5PD Henley On Thames Oxfordshire | England | British | 21786610001 | |||||
| CHILDS, Brian | Amministratore | 41 Markbrook Drive High Green S30 4FP Sheffield South Yorkshire | British | 31807140001 | ||||||
| COYNE, John Francis | Amministratore | 23 Maple Road DL10 4BW Richmond North Yorkshire | England | British | 7383400002 | |||||
| CULBERT, Paul | Amministratore | 55 Vastern Road RG1 8BU Reading Berkshire | British | 85030070002 | ||||||
| DALE, Peter Ernest | Amministratore | 5 Glencarse Home Farm Cottages Glencarse PH2 7LF Perth Perthshire | British | 106575450001 | ||||||
| DONNELLY, Lawrence John Vincent | Amministratore | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | Scotland | British | 62794440002 | |||||
| DUNLOP, John Michael | Amministratore | The Old Manse 22 Chestnut Avenue LS22 6SE Wetherby West Yorkshire | British | 55845230001 | ||||||
| FORBES, James Alexander | Amministratore | Rydale Lodge 1a Racecourse View KA7 2TS Ayr Ayrshire | British | 141444100001 | ||||||
| GAUNTLETT, David Michael | Amministratore | 1 Poplar Close Baughurst RG26 5LH Basingstoke Hampshire | British | 55769350001 | ||||||
| GRAY, David Mclaren | Amministratore | Dykeneuk Butterstone PH8 0HA Dunkeld Perthshire | Scotland | British | 140884530001 | |||||
| GRUBB, Rodney Alexander | Amministratore | Peasiehill Road Elliot Industrial Estate DD11 2NJ Arbroath Sse Depot Angus | United Kingdom | British | 150322280001 | |||||
| HART, James, Doctor | Amministratore | Skerrols East Road St Georges Hill KT13 0LF Weybridge Surrey | British | 10014240003 | ||||||
| HILLMAN, Christopher Michael | Amministratore | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire Ireland | England | British | 17572470002 | |||||
| HOGARTH, Stuart John | Amministratore | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | United Kingdom | British | 150321920001 | |||||
| HOOD, Colin William | Amministratore | 1 Wharfe Lane RG9 2LL Henley | British | 80184130001 | ||||||
| KHALID, Mohammed Shehzad | Amministratore | Queen Anne Drive EH28 8PL Newbridge Unit 4 | United Kingdom | British | 282645380001 | |||||
| MARCHANT, Ian Derek | Amministratore | 45 Craigcrook Road EH4 3PH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 29951280003 | |||||
| MATHIESON, Mark William | Amministratore | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire Ireland | United Kingdom | British | 102328560002 | |||||
| MOREA, John Victor | Amministratore | RG5 | United Kingdom | British | 161089110001 | |||||
| MURRAY, Alan George | Amministratore | 6 Field Way BH21 3XH Wimborne Dorset | United Kingdom | British | 86906500001 | |||||
| POLLARD, Charles Nicholas | Amministratore | 4 Newton Avenue TN10 4RP Tonbridge Kent | British | 58299880001 | ||||||
| POLLARD, Stephen Godfrey | Amministratore | 41 Common Close Horsell GU21 4DB Woking Surrey | British | 32781400001 | ||||||
| ROPER, Peter John | Amministratore | 4 Rances Lane RG40 2LH Wokingham Berkshire | British | 63451780001 | ||||||
| SHARMA, Brian Dominic | Amministratore | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | England | British | 180444150001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SSE UTILITY SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sse Contracting Group Limited | 06 apr 2016 | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SSE UTILITY SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 15 feb 1988 Consegnato il 01 mar 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the east side of of dunn st newcastle upon tyne. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 15 feb 1988 Consegnato il 01 mar 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land forming part of former property repair depot bowburn county durham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Secured debenture | Creato il 12 set 1986 Consegnato il 24 set 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £215,000 and all other monies due or to become due from the company t o the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including motor cars, goodwill,office equipment uncalled capita l plant & machinery intellectual property & other rights. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture and guarantee | Creato il 19 apr 1984 Consegnato il 03 mag 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 25 ago 1983 Consegnato il 02 set 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company devoguild limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0