JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01689995 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| JAGUAR COMMUNICATIONS PLC | 24 apr 2008 | 24 apr 2008 |
| EASYBROOK LIMITED | 07 gen 1983 | 07 gen 1983 |
Quali sono gli ultimi bilanci di JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 30 nov 2017
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2017 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 224 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ott 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Vodafone Corporate Secretaries Limited come amministratore in data 31 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited come amministratore in data 31 mag 2017 | 2 pagine | AP02 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN | 1 pagine | AD04 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Vodafone Corporate Secretaries Limited come segretario in data 31 mag 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Matthew Egan come amministratore in data 31 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited come segretario in data 31 mag 2017 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 11 mag 2016
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Steven David Showell come amministratore in data 04 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Segretario | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 232519770001 | ||||||||||
| EGAN, Matthew | Amministratore | Oxford Street Ramsbury SN8 2PS Marlborough 35 United Kingdom | United Kingdom | British | 232755050001 | |||||||||
| SMITH, Neil Colin | Amministratore | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 204358750001 | |||||||||
| VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Amministratore | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 232519770001 | ||||||||||
| BOLTON, Jonathan Mark | Segretario | 22 Winchester Drive HA5 1DB Pinner Middlesex | British | 15931960005 | ||||||||||
| BOLTON, Jonathan Mark | Segretario | 22 Winchester Drive HA5 1DB Pinner Middlesex | British | 15931960005 | ||||||||||
| CLAYDON, Kenneth Keith | Segretario | 1 Parr House 12 Beaulieu Avenue E16 1TS London | British | 60709330001 | ||||||||||
| DAVIDSON, Lorraine | Segretario | 18b Denver Road N16 5JH London | British | 103543780001 | ||||||||||
| DROLET, Robert | Segretario | 30 Lincoln Avenue Wimbledon SW19 5JT London | Canadian | 48244660002 | ||||||||||
| HANSCOMB, Heledd Mair | Segretario | 63 Casewick Road SE27 0TB London | British | 66806360001 | ||||||||||
| HANSCOMB, Heledd Mair | Segretario | 63 Casewick Road SE27 0TB London | British | 66806360001 | ||||||||||
| MOORE, Paul Anthony | Segretario | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | 152569550001 | |||||||||||
| RUSSELL, Gary Peter | Segretario | 9 Pirton Close AL4 9YJ St Albans Hertfordshire | British | 44428050001 | ||||||||||
| STOCKMAN, Richard Graham | Segretario | 3 Albert Street AL1 1RT St Albans Hertfordshire | British | 7490950001 | ||||||||||
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Segretario | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
| BEVERIDGE, Robert James | Amministratore | 81 Kidmore Road Caversham RG4 7NQ Reading | United Kingdom | British | 62452090001 | |||||||||
| CLARKE, Gregory Allison | Amministratore | Pinehurst Friary Road SL5 9HD Ascot Berkshire | British | 143319900001 | ||||||||||
| CLAYDON, Kenneth Keith | Amministratore | 1 Parr House 12 Beaulieu Avenue E16 1TS London | British | 60709330001 | ||||||||||
| COLEBROOK, Richard John | Amministratore | 30 Prospect Lane AL5 2PL Harpenden Hertfordshire | England | United Kingdom | 2606430002 | |||||||||
| COOPER, Nicholas Ian | Amministratore | 26 Red Lion Square WC1R 4HQ London 3rd Floor | Uk | British | 122128470002 | |||||||||
| DAVIS, Philip Stephen James | Amministratore | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135958960001 | |||||||||
| DROLET, Robert | Amministratore | 30 Lincoln Avenue Wimbledon SW19 5JT London | Canadian | 48244660002 | ||||||||||
| FITZ, Joseph Daniel | Amministratore | 35 Aria House 5-15 Newton Street Covent Garden WC2B 5EN London | British | 70579740002 | ||||||||||
| GARARD, Andrew Sheldon | Amministratore | Waldegrave House 293 Waldegrave Road TW1 4SU Twickenham Middlesex | British | 69630190003 | ||||||||||
| GIBSON, Ian Jeffrey | Amministratore | Stanmore House 3 Silverdale Road RH15 0ED Burgess Hill West Sussex | England | British | 78528840005 | |||||||||
| HEWITT, Martin Robert | Amministratore | 46 Milliners Court Lattimore Road AL1 3XT St. Albans Hertfordshire | British | 2606450004 | ||||||||||
| HOGGARTH, Royston | Amministratore | The Barley House Hawks Meadow Snowford Hall Farm CV33 9ES Hunningham Warwickshire | England | British | 67927330001 | |||||||||
| JAMES, Kevin | Amministratore | 6 Maxwell Close WD3 2BR Rickmansworth Hertfordshire | British | 55357740001 | ||||||||||
| JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Amministratore | 25 Chiswick Quay W4 3UR London | England | British | 108268030003 | |||||||||
| KINCH, Alan Royston | Amministratore | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | English | 163334420001 | |||||||||
| LERWILL, Robert Earl | Amministratore | Water Street WC2R 3LA London 1 | British | 51239200003 | ||||||||||
| MOLYNEUX, Mary Bridget | Amministratore | 33 Saint Jamess Gardens W11 4RF London | Australian | 63615470001 | ||||||||||
| NORTON, Graham Howard | Amministratore | Storrs Hill Cottage White Rose Lane GU22 7LB Woking Surrey | British | 91014890001 | ||||||||||
| PHILLIP, Kerry | Amministratore | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 185033430001 | |||||||||
| QUINN, Peter Herbert | Amministratore | Dog House HP5 1UQ Latimer Buckinghamshire | British | 663570001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable & Wireless U.K. | 06 apr 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 29 apr 2002 Consegnato il 07 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the tenant (as defined therein) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The interest in the account a seperate designated interest bearing deposit account where the deposited sum of £211,712 is placed together with all monies including interest and other accruals standing to the credit of the said account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creato il 01 mar 1996 Consegnato il 11 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over all the deposits together with all interest in account no 60082953. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 08 feb 1993 Consegnato il 11 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £19,839.47 | |
Brevi particolari All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 13 feb 1991 Consegnato il 02 feb 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £19290.36 | |
Brevi particolari All the company's right title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance particulars of which are set out on form M395 reference M338 c. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattles mortgage | Creato il 04 giu 1990 Consegnato il 06 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari One used jaguar 'e' type coupe. Registeration no jag 164L, chassis no. 1551428BW. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 17 gen 1986 Consegnato il 29 gen 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (See doc M17). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 27 giu 1985 Consegnato il 04 lug 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges ovr the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts a legal mortgage over l/h property k/a the limies, 32/34 upper marlborough road, st albans, hertfordshire and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0