JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED

JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01689995
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JAGUAR COMMUNICATIONS PLC24 apr 200824 apr 2008
    EASYBROOK LIMITED07 gen 198307 gen 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 nov 2017

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 14/11/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2017

    16 pagineAA

    legacy

    224 paginePARENT_ACC

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ott 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Cessazione della carica di Vodafone Corporate Secretaries Limited come amministratore in data 31 mag 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited come amministratore in data 31 mag 2017

    2 pagineAP02

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN

    1 pagineAD04

    Cessazione della carica di Vodafone Corporate Secretaries Limited come segretario in data 31 mag 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Matthew Egan come amministratore in data 31 mag 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited come segretario in data 31 mag 2017

    2 pagineAP04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 11 mag 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 22/04/2016
    RES13

    Cessazione della carica di Steven David Showell come amministratore in data 04 gen 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2303594
    232519770001
    EGAN, Matthew
    Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    35
    United Kingdom
    Amministratore
    Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    35
    United Kingdom
    United KingdomBritish232755050001
    SMITH, Neil Colin
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish204358750001
    VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2303594
    232519770001
    BOLTON, Jonathan Mark
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    Segretario
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    British15931960005
    BOLTON, Jonathan Mark
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    Segretario
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    British15931960005
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Segretario
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    DAVIDSON, Lorraine
    18b Denver Road
    N16 5JH London
    Segretario
    18b Denver Road
    N16 5JH London
    British103543780001
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Segretario
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Segretario
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Segretario
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    MOORE, Paul Anthony
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    152569550001
    RUSSELL, Gary Peter
    9 Pirton Close
    AL4 9YJ St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    9 Pirton Close
    AL4 9YJ St Albans
    Hertfordshire
    British44428050001
    STOCKMAN, Richard Graham
    3 Albert Street
    AL1 1RT St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Albert Street
    AL1 1RT St Albans
    Hertfordshire
    British7490950001
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2357692
    75473330004
    BEVERIDGE, Robert James
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    Amministratore
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    United KingdomBritish62452090001
    CLARKE, Gregory Allison
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    British143319900001
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Amministratore
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    COLEBROOK, Richard John
    30 Prospect Lane
    AL5 2PL Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    30 Prospect Lane
    AL5 2PL Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandUnited Kingdom2606430002
    COOPER, Nicholas Ian
    26 Red Lion Square
    WC1R 4HQ London
    3rd Floor
    Amministratore
    26 Red Lion Square
    WC1R 4HQ London
    3rd Floor
    UkBritish122128470002
    DAVIS, Philip Stephen James
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135958960001
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Amministratore
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    FITZ, Joseph Daniel
    35 Aria House
    5-15 Newton Street Covent Garden
    WC2B 5EN London
    Amministratore
    35 Aria House
    5-15 Newton Street Covent Garden
    WC2B 5EN London
    British70579740002
    GARARD, Andrew Sheldon
    Waldegrave House
    293 Waldegrave Road
    TW1 4SU Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    Waldegrave House
    293 Waldegrave Road
    TW1 4SU Twickenham
    Middlesex
    British69630190003
    GIBSON, Ian Jeffrey
    Stanmore House
    3 Silverdale Road
    RH15 0ED Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    Stanmore House
    3 Silverdale Road
    RH15 0ED Burgess Hill
    West Sussex
    EnglandBritish78528840005
    HEWITT, Martin Robert
    46 Milliners Court
    Lattimore Road
    AL1 3XT St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    46 Milliners Court
    Lattimore Road
    AL1 3XT St. Albans
    Hertfordshire
    British2606450004
    HOGGARTH, Royston
    The Barley House
    Hawks Meadow Snowford Hall Farm
    CV33 9ES Hunningham
    Warwickshire
    Amministratore
    The Barley House
    Hawks Meadow Snowford Hall Farm
    CV33 9ES Hunningham
    Warwickshire
    EnglandBritish67927330001
    JAMES, Kevin
    6 Maxwell Close
    WD3 2BR Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Maxwell Close
    WD3 2BR Rickmansworth
    Hertfordshire
    British55357740001
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Amministratore
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritish108268030003
    KINCH, Alan Royston
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomEnglish163334420001
    LERWILL, Robert Earl
    Water Street
    WC2R 3LA London
    1
    Amministratore
    Water Street
    WC2R 3LA London
    1
    British51239200003
    MOLYNEUX, Mary Bridget
    33 Saint Jamess Gardens
    W11 4RF London
    Amministratore
    33 Saint Jamess Gardens
    W11 4RF London
    Australian63615470001
    NORTON, Graham Howard
    Storrs Hill Cottage
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Surrey
    Amministratore
    Storrs Hill Cottage
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Surrey
    British91014890001
    PHILLIP, Kerry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish185033430001
    QUINN, Peter Herbert
    Dog House
    HP5 1UQ Latimer
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Dog House
    HP5 1UQ Latimer
    Buckinghamshire
    British663570001

    Chi sono le persone con controllo significativo di JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaUnlimited With Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1541957
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 29 apr 2002
    Consegnato il 07 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the tenant (as defined therein) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The interest in the account a seperate designated interest bearing deposit account where the deposited sum of £211,712 is placed together with all monies including interest and other accruals standing to the credit of the said account.
    Persone aventi diritto
    • Euroinvest Estates Limited
    Transazioni
    • 07 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 01 mar 1996
    Consegnato il 11 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all the deposits together with all interest in account no 60082953. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Credit agreement
    Creato il 08 feb 1993
    Consegnato il 11 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £19,839.47
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 11 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 13 feb 1991
    Consegnato il 02 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £19290.36
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance particulars of which are set out on form M395 reference M338 c.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 02 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattles mortgage
    Creato il 04 giu 1990
    Consegnato il 06 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One used jaguar 'e' type coupe. Registeration no jag 164L, chassis no. 1551428BW.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 06 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 gen 1986
    Consegnato il 29 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc M17). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 27 giu 1985
    Consegnato il 04 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges ovr the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts a legal mortgage over l/h property k/a the limies, 32/34 upper marlborough road, st albans, hertfordshire and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0