SHO123 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHO123 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01692741
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHO123 LIMITED?

    • Produzione di tessuti per la casa (13921) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova SHO123 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    20 Jewry Street
    SO23 8RZ Winchester
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SHO123 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SNUG COMPANY LIMITED04 apr 199104 apr 1991
    GUARDIAN TEXTILES LIMITED24 ago 198324 ago 1983
    BACKSPRING LIMITED20 gen 198320 gen 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHO123 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SHO123 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SHO123 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di David Alistair Horner come amministratore in data 01 apr 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    32 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 dic 2014

    Stato del capitale al 22 dic 2014

    • Capitale: GBP 750,060
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    37 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 gen 2014

    Stato del capitale al 03 gen 2014

    • Capitale: GBP 750,060
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2012 al 31 mar 2013

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Varie

    Sect 519
    1 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Nomina di Mr David Christopher Harbord come amministratore

    3 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Stonegate House Stoneygate Lane Felling Gateshead Tyne and Wear NE10 0HJ* in data 17 ago 2012

    1 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    4 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG04

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed snug company LIMITED\certificate issued on 10/07/12
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name10 lug 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 05 lug 2012

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    31 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Alistair Horner il 22 nov 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robin Thistlethwayte il 22 nov 2011

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di SHO123 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARBORD, David Christopher
    Jewry Street
    SO23 8RZ Winchester
    20
    Hampshire
    Amministratore
    Jewry Street
    SO23 8RZ Winchester
    20
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant165861260001
    THISTLETHWAYTE, Mark Edward
    Jewry Street
    SO23 8RZ Winchester
    20
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Jewry Street
    SO23 8RZ Winchester
    20
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector107579860001
    THISTLETHWAYTE, Robin
    Jewry Street
    SO23 8RZ Winchester
    20
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Jewry Street
    SO23 8RZ Winchester
    20
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector146309400001
    HANCOCK, Peter
    Heathfield Rise
    Rishworth
    HX6 4RS Sowerby Bridge
    24
    West Yorkshire
    Segretario
    Heathfield Rise
    Rishworth
    HX6 4RS Sowerby Bridge
    24
    West Yorkshire
    BritishManager104728630002
    JOHNSON, Steven
    The Boundary House Paddock Close
    Shiney Row
    DH4 4AR Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Segretario
    The Boundary House Paddock Close
    Shiney Row
    DH4 4AR Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    British19909850005
    STEPHENSON, Catherine Jane
    Stoneygate Lane
    Felling
    NE10 0HJ Gateshead
    Stonegate House
    Tyne And Wear
    Segretario
    Stoneygate Lane
    Felling
    NE10 0HJ Gateshead
    Stonegate House
    Tyne And Wear
    146252590001
    THORNE, John Trevor
    4 Dalmahoy
    Usworth
    NE37 1SF Washington
    Tyne & Wear
    Segretario
    4 Dalmahoy
    Usworth
    NE37 1SF Washington
    Tyne & Wear
    British21668260001
    WHITE, Kenneth
    Wilton Gardens South
    NE35 9HG Boldon Colliery
    39
    Tyne And Wear
    Segretario
    Wilton Gardens South
    NE35 9HG Boldon Colliery
    39
    Tyne And Wear
    BritishDirector131360010001
    HANCOCK, Peter
    Stoneygate Lane
    Felling
    NE10 0HJ Gateshead
    Stonegate House
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Stoneygate Lane
    Felling
    NE10 0HJ Gateshead
    Stonegate House
    Tyne And Wear
    Great BritainBritishManager104728630003
    HORNER, David Alistair
    Jewry Street
    SO23 8RZ Winchester
    20
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Jewry Street
    SO23 8RZ Winchester
    20
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector79690220002
    JOHNSON, Steven
    The Boundary House Paddock Close
    Shiney Row
    DH4 4AR Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    The Boundary House Paddock Close
    Shiney Row
    DH4 4AR Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    BritishDirector19909850005
    JOHNSON, Susan
    13 Bywell Road
    Cleadon
    SR6 7QT Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    13 Bywell Road
    Cleadon
    SR6 7QT Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishProperty Developer20466080001
    NUSENBAUM, Geraldine Linda Ashley
    Springfield House Oakfield Road
    Gosforth
    NE3 4HS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Springfield House Oakfield Road
    Gosforth
    NE3 4HS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishDirector125518880001
    NUSENBAUM, Vyvyan Justin
    Springfield House Oakfield Road
    Gosforth
    NE3 4HS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Springfield House Oakfield Road
    Gosforth
    NE3 4HS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishConsultant31350830001

    SHO123 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 25 lug 2011
    Consegnato il 05 ago 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Full title guarantee charged with all rights to the deposit to the bank see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 12 lug 2011
    Consegnato il 20 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bibby Financial Services Limited
    Transazioni
    • 20 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 lug 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Legal mortgage
    Creato il 12 lug 2011
    Consegnato il 19 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property k/a stoneygate house stoneygate lane gateshead tyne & wear t/nos. TY126370 TY217666 TY296279 and all estates or interests in the property including all rents whether present or future arising out of any leases or tenancies of all or any part of the property and all income see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Buckland Development Limited
    Transazioni
    • 19 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 lug 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Debenture
    Creato il 01 giu 2011
    Consegnato il 11 giu 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Portchester Equity Limited
    Transazioni
    • 11 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 lug 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Debenture
    Creato il 22 ott 2009
    Consegnato il 23 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 23 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 04 set 2009
    Consegnato il 08 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stoneygate house, stoneygate lane, gateshead, tyne & wear t/no TY126370, TY217666 and TY296279 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 04 dic 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Kinna long side & cross side sewing machine serial no 1030,. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Chattel mortgage
    Creato il 09 nov 2007
    Consegnato il 21 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    £155000.00 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    New kinna long side & cross side sewing machine s/n 1031 chassis/tin no T310178 date of manufacture 2007.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 21 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Charge of deposit
    Creato il 02 mar 2000
    Consegnato il 04 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £500,000 credited to account 91015171.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 16 dic 1993
    Consegnato il 24 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 feb 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0