FARR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFARR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01696784
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FARR LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova FARR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FARR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FARR PLC21 feb 200121 feb 2001
    FARR INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS LIMITED29 dic 200029 dic 2000
    FMW INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS LIMITED02 ago 199002 ago 1990
    FARR INSURANCE MANAGEMENT (HOUSING ASSOCIATIONS) LIMITED04 lug 198604 lug 1986
    ARENALAND LIMITED03 feb 198303 feb 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di FARR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per FARR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 giu 2013

    3 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Third Floor, Sunley House Bedford Park Croydon CR0 2AP in data 07 gen 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 20 dic 2012

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 gen 2013

    Stato del capitale al 02 gen 2013

    • Capitale: GBP 500,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2011 al 30 dic 2011

    3 pagineAA01

    Cessazione della carica di David Martin Oliver come amministratore in data 15 giu 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Ronald Sutherland il 21 nov 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di Ian Ronald Sutherland come amministratore in data 01 ott 2011

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Jenkinson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Timothy Jenkinson il 07 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Christina Hong Ye il 07 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di FARR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    YE, Christina Hong
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Segretario
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    British133681410001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    Sunley House
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Sunley House
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish189660790001
    BELLIS, Juliet Mary Susan
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    Segretario
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    British69991160002
    DAVIS, Nigel Peter
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    British93673010001
    DAVIS, Paul Malcolm
    70 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    70 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    British30526830001
    HOUSTON, John Terence
    5 Bramalea Close
    Highgate
    N6 4QD London
    Segretario
    5 Bramalea Close
    Highgate
    N6 4QD London
    British4286480003
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Segretario
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    SHAIL, Richard
    Drumochter Station Road
    Wickham Bishops
    CM8 3JL Witham
    Essex
    Segretario
    Drumochter Station Road
    Wickham Bishops
    CM8 3JL Witham
    Essex
    British2807160001
    ANDERSON, Susan
    6 Scraley Road
    Heybridge
    CM9 4BL Maldon
    Essex
    Amministratore
    6 Scraley Road
    Heybridge
    CM9 4BL Maldon
    Essex
    British59061920001
    BARNES, Ortho Thomas David
    Cresta
    Beech Hill
    GU35 8BD Headley Down
    Hampshire
    Amministratore
    Cresta
    Beech Hill
    GU35 8BD Headley Down
    Hampshire
    British37613450001
    BELLWIN, Irwin Norman, Lord
    Woodside Lodge
    Ling Lane Scarcroft
    LS14 3HX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodside Lodge
    Ling Lane Scarcroft
    LS14 3HX Leeds
    West Yorkshire
    British15771280001
    BLANC, Peter William
    Portals 1a Halstead Road
    CO3 5AB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Portals 1a Halstead Road
    CO3 5AB Colchester
    Essex
    British56337490001
    BRINDLEY, Steven John
    56 Elmstead Lane
    BR7 5EL Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    56 Elmstead Lane
    BR7 5EL Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish71800210002
    CUMMINGS, Lucy
    13 Plympton Street
    NW8 8AB London
    Amministratore
    13 Plympton Street
    NW8 8AB London
    British80559730001
    DAVIS, Nigel Peter
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish93673010002
    DAVIS, Nigel Peter
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    British93673010001
    DAVIS, Paul Malcolm
    70 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    70 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    British30526830001
    EVANS, Mark Conrath
    29 Port Hill
    SG14 1QP Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    29 Port Hill
    SG14 1QP Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritish160409520001
    FARR, Kevin Maurice
    Priors Hall
    Stebbing
    CM6 3SW Dunmow
    Essex
    Amministratore
    Priors Hall
    Stebbing
    CM6 3SW Dunmow
    Essex
    EnglandBritish8497140001
    GOODING, Jonathan Michael
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    Amministratore
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    United KingdomBritish16684130002
    GRAVATT, Paul
    50 Wood Dale
    Great Baddow
    CM2 8EZ Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    50 Wood Dale
    Great Baddow
    CM2 8EZ Chelmsford
    Essex
    British59063500001
    HALSTEAD, Andrew John
    Hillside
    Hoseley Lane Marford
    LL12 8YE Wrexham
    Amministratore
    Hillside
    Hoseley Lane Marford
    LL12 8YE Wrexham
    United KingdomBritish92617680001
    HOUSTON, John Terence
    5 Bramalea Close
    Highgate
    N6 4QD London
    Amministratore
    5 Bramalea Close
    Highgate
    N6 4QD London
    British4286480003
    JENKINSON, Andrew Timothy
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    Amministratore
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish74069620002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    Amministratore
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    United KingdomBritish137285750001
    LESLIE, Mark Stuart Michael
    83 Long Ridings Avenue
    Hutton
    CM13 1EF Brentwood
    Essex
    Amministratore
    83 Long Ridings Avenue
    Hutton
    CM13 1EF Brentwood
    Essex
    British4274460001
    MACMAHON, Dominic John
    23 Godfreys Mews
    CM2 0XF Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    23 Godfreys Mews
    CM2 0XF Chelmsford
    Essex
    British63438840001
    MURPHY, Vincent Edward
    Custersons
    Ford End
    CB11 4PU Clavering
    Essex
    Amministratore
    Custersons
    Ford End
    CB11 4PU Clavering
    Essex
    British31521320003
    NUTTING, Peter Robert
    North Breache Manor
    GU6 7SN Ewhurst
    Surrey
    Amministratore
    North Breache Manor
    GU6 7SN Ewhurst
    Surrey
    British173130001
    OLIVER, David Martin
    13 Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    13 Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish115764650001
    PEARSON, Michael
    97 Garrick Close
    SW18 1JH London
    Amministratore
    97 Garrick Close
    SW18 1JH London
    British67026480002
    PLUMB, Robert Henry Charles
    Uplands Cottage
    Whitchurch On Thames
    RG8 7HH Reading
    Amministratore
    Uplands Cottage
    Whitchurch On Thames
    RG8 7HH Reading
    EnglandBritish20686100001
    REYNOLDS, Mary Annette
    The Old Barn
    Stowe Farm Langtoft
    PE6 9SF Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Old Barn
    Stowe Farm Langtoft
    PE6 9SF Peterborough
    Cambridgeshire
    British109768260001
    SCOTT, Andrew Gordon
    Laurels
    5 Harrow Gardens
    BR6 9WD Orpington
    Kent
    Amministratore
    Laurels
    5 Harrow Gardens
    BR6 9WD Orpington
    Kent
    British33300430001
    SHAIL, Richard
    Drumochter Station Road
    Wickham Bishops
    CM8 3JL Witham
    Essex
    Amministratore
    Drumochter Station Road
    Wickham Bishops
    CM8 3JL Witham
    Essex
    EnglandBritish2807160001

    FARR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental charge
    Creato il 02 gen 2008
    Consegnato il 08 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Farr house, railway street, chelmsford t/no. EX718036.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (Formerly Known as the Governor and Company of the Bank of Scotland)(the Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group debenture
    Creato il 26 lug 2006
    Consegnato il 03 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 nov 2004
    Consegnato il 24 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 mar 2002
    Consegnato il 14 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC, as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession and amendment to the composite guarantee and debenture dated 9TH november 1999 (the deed)
    Creato il 06 apr 2001
    Consegnato il 21 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 nov 1998
    Consegnato il 04 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 giu 1994
    Consegnato il 17 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 15TH june 1994
    Brevi particolari
    £6,000 with all interest.
    Persone aventi diritto
    • Mepc PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 31 gen 1994
    Consegnato il 04 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 mar 1991
    Consegnato il 05 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over book debts
    Creato il 13 feb 1990
    Consegnato il 22 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific charge over the herefit of all book and other debts now or from time to time. (See 395 for details).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FARR LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 set 2013Data di scioglimento
    20 dic 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0