FARR LIMITED
Panoramica
| Nome della società | FARR LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01696784 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FARR LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova FARR LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di FARR LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FARR PLC | 21 feb 2001 | 21 feb 2001 |
| FARR INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS LIMITED | 29 dic 2000 | 29 dic 2000 |
| FMW INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS LIMITED | 02 ago 1990 | 02 ago 1990 |
| FARR INSURANCE MANAGEMENT (HOUSING ASSOCIATIONS) LIMITED | 04 lug 1986 | 04 lug 1986 |
| ARENALAND LIMITED | 03 feb 1983 | 03 feb 1983 |
Quali sono gli ultimi bilanci di FARR LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per FARR LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 giu 2013 | 3 pagine | 4.68 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 3 pagine | 4.71 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Third Floor, Sunley House Bedford Park Croydon CR0 2AP in data 07 gen 2013 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2011 al 30 dic 2011 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Martin Oliver come amministratore in data 15 giu 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ian Ronald Sutherland il 21 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Ian Ronald Sutherland come amministratore in data 01 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Jenkinson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2008 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Andrew Timothy Jenkinson il 07 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Christina Hong Ye il 07 ott 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FARR LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE, Christina Hong | Segretario | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | British | 133681410001 | ||||||
| SUTHERLAND, Ian Ronald | Amministratore | Sunley House Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 189660790001 | |||||
| BELLIS, Juliet Mary Susan | Segretario | 4 Grange Hill SE25 6SX London | British | 69991160002 | ||||||
| DAVIS, Nigel Peter | Segretario | 66 Redway Drive TW2 7NW Twickenham Middlesex | British | 93673010001 | ||||||
| DAVIS, Paul Malcolm | Segretario | 70 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | British | 30526830001 | ||||||
| HOUSTON, John Terence | Segretario | 5 Bramalea Close Highgate N6 4QD London | British | 4286480003 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Segretario | 25 Thirlmere Road Muswell Hill N10 2DL London | British | 11498320001 | ||||||
| SHAIL, Richard | Segretario | Drumochter Station Road Wickham Bishops CM8 3JL Witham Essex | British | 2807160001 | ||||||
| ANDERSON, Susan | Amministratore | 6 Scraley Road Heybridge CM9 4BL Maldon Essex | British | 59061920001 | ||||||
| BARNES, Ortho Thomas David | Amministratore | Cresta Beech Hill GU35 8BD Headley Down Hampshire | British | 37613450001 | ||||||
| BELLWIN, Irwin Norman, Lord | Amministratore | Woodside Lodge Ling Lane Scarcroft LS14 3HX Leeds West Yorkshire | British | 15771280001 | ||||||
| BLANC, Peter William | Amministratore | Portals 1a Halstead Road CO3 5AB Colchester Essex | British | 56337490001 | ||||||
| BRINDLEY, Steven John | Amministratore | 56 Elmstead Lane BR7 5EL Chislehurst Kent | England | British | 71800210002 | |||||
| CUMMINGS, Lucy | Amministratore | 13 Plympton Street NW8 8AB London | British | 80559730001 | ||||||
| DAVIS, Nigel Peter | Amministratore | 6 Boundary Park KT13 9RR Weybridge Surrey | England | British | 93673010002 | |||||
| DAVIS, Nigel Peter | Amministratore | 66 Redway Drive TW2 7NW Twickenham Middlesex | British | 93673010001 | ||||||
| DAVIS, Paul Malcolm | Amministratore | 70 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | British | 30526830001 | ||||||
| EVANS, Mark Conrath | Amministratore | 29 Port Hill SG14 1QP Hertford Hertfordshire | England | British | 160409520001 | |||||
| FARR, Kevin Maurice | Amministratore | Priors Hall Stebbing CM6 3SW Dunmow Essex | England | British | 8497140001 | |||||
| GOODING, Jonathan Michael | Amministratore | 13 Albany Street NW1 4DX London | United Kingdom | British | 16684130002 | |||||
| GRAVATT, Paul | Amministratore | 50 Wood Dale Great Baddow CM2 8EZ Chelmsford Essex | British | 59063500001 | ||||||
| HALSTEAD, Andrew John | Amministratore | Hillside Hoseley Lane Marford LL12 8YE Wrexham | United Kingdom | British | 92617680001 | |||||
| HOUSTON, John Terence | Amministratore | 5 Bramalea Close Highgate N6 4QD London | British | 4286480003 | ||||||
| JENKINSON, Andrew Timothy | Amministratore | Bedford Park CR0 2AP Croydon Third Floor Sunley House United Kingdom | United Kingdom | British | 74069620002 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Amministratore | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LESLIE, Mark Stuart Michael | Amministratore | 83 Long Ridings Avenue Hutton CM13 1EF Brentwood Essex | British | 4274460001 | ||||||
| MACMAHON, Dominic John | Amministratore | 23 Godfreys Mews CM2 0XF Chelmsford Essex | British | 63438840001 | ||||||
| MURPHY, Vincent Edward | Amministratore | Custersons Ford End CB11 4PU Clavering Essex | British | 31521320003 | ||||||
| NUTTING, Peter Robert | Amministratore | North Breache Manor GU6 7SN Ewhurst Surrey | British | 173130001 | ||||||
| OLIVER, David Martin | Amministratore | 13 Kirklee Circus G12 0TW Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 115764650001 | |||||
| PEARSON, Michael | Amministratore | 97 Garrick Close SW18 1JH London | British | 67026480002 | ||||||
| PLUMB, Robert Henry Charles | Amministratore | Uplands Cottage Whitchurch On Thames RG8 7HH Reading | England | British | 20686100001 | |||||
| REYNOLDS, Mary Annette | Amministratore | The Old Barn Stowe Farm Langtoft PE6 9SF Peterborough Cambridgeshire | British | 109768260001 | ||||||
| SCOTT, Andrew Gordon | Amministratore | Laurels 5 Harrow Gardens BR6 9WD Orpington Kent | British | 33300430001 | ||||||
| SHAIL, Richard | Amministratore | Drumochter Station Road Wickham Bishops CM8 3JL Witham Essex | England | British | 2807160001 |
FARR LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental charge | Creato il 02 gen 2008 Consegnato il 08 gen 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Farr house, railway street, chelmsford t/no. EX718036. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Group debenture | Creato il 26 lug 2006 Consegnato il 03 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 nov 2004 Consegnato il 24 nov 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 06 mar 2002 Consegnato il 14 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession and amendment to the composite guarantee and debenture dated 9TH november 1999 (the deed) | Creato il 06 apr 2001 Consegnato il 21 apr 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 24 nov 1998 Consegnato il 04 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 15 giu 1994 Consegnato il 17 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 15TH june 1994 | |
Brevi particolari £6,000 with all interest. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 31 gen 1994 Consegnato il 04 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 27 mar 1991 Consegnato il 05 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over book debts | Creato il 13 feb 1990 Consegnato il 22 feb 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific charge over the herefit of all book and other debts now or from time to time. (See 395 for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
FARR LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0