HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED

HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01697114
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HIGHWAY VEHICLE LEASING (1996) LIMITED24 gen 199724 gen 1997
    HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED 30 ago 199430 ago 1994
    HIGHWAY FINANCE HOLDINGS PLC02 ago 198302 ago 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    Cessazione della carica di Christopher Sutton come amministratore in data 11 ago 2015

    2 pagineTM01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom a 25 Gresham Street London EC2V 7HN

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 25 Gresham Street London EC2V 7HN a 1 More London Place London SE1 2AF in data 21 gen 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 dic 2014

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Bilancio annuale redatto al 26 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 ott 2014

    Stato del capitale al 29 ott 2014

    • Capitale: GBP 1,287,742
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Sutton il 28 feb 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 26 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 ott 2013

    Stato del capitale al 29 ott 2013

    • Capitale: GBP 1,287,742
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Claude Kwasi Sarfo-Agyare il 24 gen 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 26 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Martin Staples come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Claude Kwasi Sarfo-Agyare come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Nomina di Lloyds Secretaries Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Bilancio annuale redatto al 26 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Timothy Blackwell come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Christopher Sutton come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02791894
    73512200003
    SARFO-AGYARE, Claude Kwasi
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    United KingdomBritish170061790001
    HOPKINS, Stephen John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    149222580001
    MACLEOD, Donald Miller
    37 Kenningknowes Road
    FK7 9JF Stirling
    Stirlingshire
    Segretario
    37 Kenningknowes Road
    FK7 9JF Stirling
    Stirlingshire
    British319620001
    SAUNDERS, Deborah Ann
    25 Gresham Street
    EC2V 7HN London
    Segretario
    25 Gresham Street
    EC2V 7HN London
    Other38589290002
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    Segretario
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    61749570003
    ANDERSON, David Gordon
    16 The Ness
    FK14 7EB Dollar
    Clackmannanshire
    Amministratore
    16 The Ness
    FK14 7EB Dollar
    Clackmannanshire
    British177360001
    BLACKWELL, Timothy Mark
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    Amministratore
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    EnglandBritish124967310001
    BOON, Dennis Antony
    5 Knights Way
    Stoneywood
    FK6 5HG Denny
    Stirlingshire
    Amministratore
    5 Knights Way
    Stoneywood
    FK6 5HG Denny
    Stirlingshire
    British20616040001
    CUMMING, Robert George
    The Granary West Moss-Side
    Thornhill
    FK8 3QJ Stirling
    Amministratore
    The Granary West Moss-Side
    Thornhill
    FK8 3QJ Stirling
    British41709670002
    DAVIES, John Lewis
    68 The Plain
    CM16 6TW Epping
    Essex
    Amministratore
    68 The Plain
    CM16 6TW Epping
    Essex
    British51486560001
    DUNN, Alastair Andrew
    Braishfield Manor
    Braishfield
    SO51 0PS Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    Braishfield Manor
    Braishfield
    SO51 0PS Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritish178790002
    FINCHAM, Nigel
    The Shambles 34 Treves Close
    Winchmore Hill
    N21 1TT London
    Amministratore
    The Shambles 34 Treves Close
    Winchmore Hill
    N21 1TT London
    British69282810001
    GRAHAM, Roderick Neil
    5 Loneacre
    Chertsey Road
    GU20 6JH Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    5 Loneacre
    Chertsey Road
    GU20 6JH Windlesham
    Surrey
    British51466570001
    GRANT, Ian Alfred
    Luangwa Coed Y Garth
    Furnace
    SY20 8PG Machynlleth
    Powys
    Amministratore
    Luangwa Coed Y Garth
    Furnace
    SY20 8PG Machynlleth
    Powys
    British9559200002
    KILBEE, Michael Peter
    Wychway
    Cavendish Road
    KT13 0JW Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Wychway
    Cavendish Road
    KT13 0JW Weybridge
    Surrey
    British19310990002
    MACLEOD, Donald Miller
    37 Kenningknowes Road
    FK7 9JF Stirling
    Stirlingshire
    Amministratore
    37 Kenningknowes Road
    FK7 9JF Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritish319620001
    MACLEOD, Donald Miller
    37 Kenningknowes Road
    FK7 9JF Stirling
    Stirlingshire
    Amministratore
    37 Kenningknowes Road
    FK7 9JF Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritish319620001
    MCLEAN, Colin Richard
    18 Springfield
    GU18 5XP Lightwater
    Surrey
    Amministratore
    18 Springfield
    GU18 5XP Lightwater
    Surrey
    British5382220001
    ORR, Andrew
    4 Allandale Crescent
    Greenloaning
    FK15 0LR Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    4 Allandale Crescent
    Greenloaning
    FK15 0LR Dunblane
    Perthshire
    British41709940001
    POTTS, David Keith
    23 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    23 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish5774320002
    STAPLES, Martin Kenneth
    1 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    Princes Exchange
    Scotland
    Amministratore
    1 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    Princes Exchange
    Scotland
    ScotlandBritish110383950001
    STEAD, Nigel Cleator
    Northend
    Timble
    LS21 2NN Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Northend
    Timble
    LS21 2NN Otley
    West Yorkshire
    EnglandBritish47582470001
    STEWART, David Howat
    6 Carew Lodge
    Carew Road
    HA6 3NH Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    6 Carew Lodge
    Carew Road
    HA6 3NH Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish108672850001
    STURT SCOBIE, James
    Hazelhurst
    Willow Hall Drive
    HX6 2BL Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hazelhurst
    Willow Hall Drive
    HX6 2BL Halifax
    West Yorkshire
    British65652830001
    SUTTON, Christopher
    Orchard Brae
    EH4 1PF Edinburgh
    Finance House
    United Kingdom
    Amministratore
    Orchard Brae
    EH4 1PF Edinburgh
    Finance House
    United Kingdom
    ScotlandBritish130660440002
    WEIGH, Peter Langford
    191 Windlehurst Road
    High Lane
    SK6 8AG Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    191 Windlehurst Road
    High Lane
    SK6 8AG Stockport
    Cheshire
    British318550002
    WHITE, Adrian Patrick
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    Amministratore
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    EnglandBritish130578200001
    FIRST NATIONAL CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    53-61 College Road
    HA1 1FB Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    53-61 College Road
    HA1 1FB Harrow
    Middlesex
    79989520002

    HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Certificate of assignment
    Creato il 03 dic 1996
    Consegnato il 18 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of any hiring agreements
    Brevi particolari
    All right title and benefit under the sub hire agreements the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 12 set 1996
    Consegnato il 19 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or conditional sale agreements in respect of goods and all other monies payable under or in respect of all hire purchase and conditional sale agreements
    Brevi particolari
    The sub hiring agreements in respect of the goods all monies payable the benefit of all guarantees indemnities and other securities and the benefit of all insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 19 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 09 lug 1996
    Consegnato il 11 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 28TH november 1994
    Brevi particolari
    All rights benefits and interest of the company present and future in and to sub-hire agreements (as defined) and the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection therewith.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 11 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 02 lug 1996
    Consegnato il 03 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or conditional sale agreements in respect of goods ("the goods")
    Brevi particolari
    The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods: vauxhall cavalier 1.8 5DR hatch 5SP reg no piw 4080 and the full benefit and advantage of the said sub-hiring agreements: date of sub-hiring agreement 01/06/95 ref no 106780. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 03 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 02 lug 1996
    Consegnato il 03 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or conditional sale agreements in respect of goods ("the goods")
    Brevi particolari
    The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods: vauxhall cavalier 1.6LS dr hatch reg no M992 gnr and the full benefit and advantage of the said hiring agreements: date of sub-hiring agreement 01/10/95 ref no 106868. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 03 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 02 gen 1996
    Consegnato il 03 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or lease purchase agreements in respect of goods
    Brevi particolari
    The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods as listed in the schedule to the form 395 and the full benefit and advantage of the said sub-hiring agreements (the goods including daimler 4.0, reg. No. 66BWC). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 03 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 02 gen 1996
    Consegnato il 03 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or lease purchase agreements in respect of goods
    Brevi particolari
    The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods listed in the schedule to the form 395 and the full benefit and advantage of the said sub-hiring agreements (the goods including mercedes benz c class 2.2 c, reg. No. M134 tgm). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 03 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 02 gen 1996
    Consegnato il 03 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or lease purchase agreements in respect of goods
    Brevi particolari
    The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods as listed in the schedule to the form 395 and the full benefit and advantage of the said sub-hiring agreements (the goods including mercedes benz e series 3.0 e, reg. No. M135 tgm). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 03 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 02 gen 1996
    Consegnato il 03 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or lease purchase agreements in respect of goods
    Brevi particolari
    The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods as listed in the schedule to the form 395 and the full benefit and advantage of the said sub-hiring agreements (the goods including ford scorpio 2.0 16V ultima reg. No. M125 sna). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 03 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 04 ago 1995
    Consegnato il 05 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the credit agreements (as defined)
    Brevi particolari
    All sub-lease agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mercedes-Benz Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 28 lug 1995
    Consegnato il 31 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 28TH november 1994
    Brevi particolari
    All rights benefit and interest in and to sub-hire agreements between the company and various sub-hirers as specified in the schedule to the assignment and the benefit of all guarantees indemnities etc.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on hiring agreements.
    Creato il 09 mar 1995
    Consegnato il 11 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title and interest in respect of motor vehicles which are from time to time during the continuance of this security in the possession (actual or constructive) ownership or otherwise of the company in whatsoever capacity provided that the motor vehicles charged shall be limited to those motor vehicles which are comprised in the contracts. Please see doc for further details.
    Persone aventi diritto
    • Ford Credit Europe PLC,
    Transazioni
    • 11 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Master agreement and certificate of assignment
    Creato il 30 nov 1994
    Consegnato il 08 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement 28TH november 1994
    Brevi particolari
    All rights benefit and interest in and to sub-hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Master agreement and charge
    Creato il 31 ott 1994
    Consegnato il 31 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to any lease purchase conditional sale or bailement agreement (as defined) and/or this charge
    Brevi particolari
    Any agreement made whether before on or after the date of the charge between the customer (as defined in the charge) and any person to whom the customer lets or agrees to let the goods on hire (the sub lessee) whereby the customer lets or agrees to let the goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Motor Finance Limited Together with Other Companies (As Defined)
    Transazioni
    • 31 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 ott 1994
    Consegnato il 05 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Interest from time to time of the company in all motor vehicles which are now or hereafer becomee mater of a hiring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 05 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HIGHWAY VEHICLE LEASING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 mag 2016Data di scioglimento
    31 dic 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Elizabeth Anne Bingham
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0