SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED

SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSNOWS BUSINESS FORMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01700975
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?

    • fabbricazione di articoli di cartoleria (17230) / Industrie manifatturiere
    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1580 Parkway Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MINKFLOW LIMITED21 feb 198321 feb 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    22 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    48 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA/AM02SOC

    13 pagineAM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit B5 Millbrook Close Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO53 4BZ England a 1580 Parkway Solent Business Park Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AG in data 24 mar 2023

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 dic 2021 al 29 dic 2021

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Mr Maxwell Middleton come persona con controllo significativo il 31 dic 2021

    2 paginePSC04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020

    12 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maxwell Middleton il 15 mar 2020

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Mr Maxwell Middleton come persona con controllo significativo il 15 mar 2020

    2 paginePSC04

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    12 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2018 al 30 dic 2018

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da Snows Business Forms Limited Manor House Avenue Millbrook Southampton SO15 0DF England a Unit B5 Millbrook Close Chandler's Ford Eastleigh Hampshire SO53 4BZ in data 19 ago 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CUTTS, Linda Anne Rachel
    Cull Lane
    BH25 5QH New Milton
    62
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Cull Lane
    BH25 5QH New Milton
    62
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish150994450001
    MIDDLETON, Maxwell
    Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    1580 Parkway
    Hampshire
    Amministratore
    Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    1580 Parkway
    Hampshire
    EnglandBritish62972490010
    CUTTS, Grahame Lindsay
    62 Cull Lane
    BH25 5QH New Milton
    Hampshire
    Segretario
    62 Cull Lane
    BH25 5QH New Milton
    Hampshire
    Australian34864180002
    CUTTS, Linda Anne Rachel
    62 Cull Lane
    BH25 5QH New Milton
    Hampshire
    Segretario
    62 Cull Lane
    BH25 5QH New Milton
    Hampshire
    British59075960001
    WESTWOOD SECRETARIES LIMITED
    Numerica Secretaries Limited
    66 Wigmore Street
    W1U 2HQ London
    Segretario
    Numerica Secretaries Limited
    66 Wigmore Street
    W1U 2HQ London
    72462860002
    ASKHAM, Francis Guy Lewis
    10 Love Lane
    SO51 8DE Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    10 Love Lane
    SO51 8DE Romsey
    Hampshire
    British15237500002
    ASKHAM, Francis Guy Lewis
    Spinney Corner Church Lane
    Braishfield
    SO51 0QH Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    Spinney Corner Church Lane
    Braishfield
    SO51 0QH Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritish15237500001
    CARMICHAEL, Robert Neil Bruce
    82 Stanhope Mews East
    SW7 5QT London
    Amministratore
    82 Stanhope Mews East
    SW7 5QT London
    United KingdomBritish65088590001
    CUTTS, Grahame Lindsay
    62 Cull Lane
    BH25 5QH New Milton
    Hampshire
    Amministratore
    62 Cull Lane
    BH25 5QH New Milton
    Hampshire
    United KingdomAustralian34864180002
    JUDD, David
    66 Sunderton Lane
    PO8 0NT Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    66 Sunderton Lane
    PO8 0NT Waterlooville
    Hampshire
    British62972310001
    JUPE, Andrew Ian
    27 Brook Court
    Brook Valley
    SO16 6SR Southampton
    Amministratore
    27 Brook Court
    Brook Valley
    SO16 6SR Southampton
    British62972580001
    LANDAU, David Aaron
    38 North Audley Street
    Mayfair
    W1K 6ZN London
    Amministratore
    38 North Audley Street
    Mayfair
    W1K 6ZN London
    United KingdomBritish10648180003
    SINGH, Sarvindra
    5 Somerset Gardens
    Highgate Gardens
    N6 5EQ London
    Amministratore
    5 Somerset Gardens
    Highgate Gardens
    N6 5EQ London
    EnglandBritish43283210001
    SMITH, Neil Jonathan
    3 Kestrel Close
    Marchwood
    SO40 4XL Southampton
    Amministratore
    3 Kestrel Close
    Marchwood
    SO40 4XL Southampton
    EnglandBritish62976820003
    STRANGE, Alan Lee
    67 Ardingly Crescent
    Hedge End
    SO30 2TE Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    67 Ardingly Crescent
    Hedge End
    SO30 2TE Southampton
    Hampshire
    British73649120001
    WINTERIDGE, Brian Jack
    St Jaques Cottage
    Old Romsey Road
    SO4 2ND Cadnam
    Hampshire
    Amministratore
    St Jaques Cottage
    Old Romsey Road
    SO4 2ND Cadnam
    Hampshire
    British16732920001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Linda Anne Rachel Cutts
    Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    1580 Parkway
    Hampshire
    06 apr 2016
    Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    1580 Parkway
    Hampshire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr Maxwell Middleton
    Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    1580 Parkway
    Hampshire
    06 apr 2016
    Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    1580 Parkway
    Hampshire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% dei diritti di voto nella società.

    SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 13 ago 2015
    Consegnato il 26 ago 2015
    In corso
    Breve descrizione
    F/H land and buildings lying to the south of millbrook road southampton t/no HP203449.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 feb 2015
    Consegnato il 09 feb 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 07 gen 2015
    Consegnato il 12 gen 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 12 gen 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 set 2005
    Consegnato il 21 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Manor house avenue southampton. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C
    Transazioni
    • 21 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 15 set 2005
    Consegnato il 21 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildingd lying to the south at hillbrook road southampton k/a manor house avenue southampton t/n HP203449. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C
    Transazioni
    • 21 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture deed
    Creato il 30 lug 1998
    Consegnato il 07 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including all monies due or payable by virtue of any guarantee or indemnity given to the chargee by the company under the debt purchase agreement dated 30TH july 1998
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 07 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 30 lug 1998
    Consegnato il 07 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 lug 1998
    Consegnato il 07 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a manor house avenue or as land and buildings lying to the south of millbrook road southampton t/no.HP203449. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 lug 1993
    Consegnato il 16 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 22 apr 1992
    Consegnato il 23 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 new drent gazelle 6 imr continuous paper printing machine serial no P11257335 833.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 23 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 giu 1989
    Consegnato il 13 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings on south side of millbrook road, southampton, hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 giu 1989
    Consegnato il 13 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H premises k/a unit 2 mayflower close, clandlers ford, eastleigh, hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 10 mag 1989
    Consegnato il 17 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book and other debts. Flaotinig charge on all other the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mag 1984
    Consegnato il 19 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts legal mortgage over land & buioldings at the south of milbrook road southampton title no hp 203449 and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 21 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mag 1984
    Consegnato il 01 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit 2 mayflower close, chandlersford industrial, estate, chandlers ford, hampshire and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 21 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal charge
    Creato il 16 giu 1983
    Consegnato il 18 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 14 june 1983.
    Brevi particolari
    Property lying to the south of millrook road, saithampton, tog. With all building, fixtures, fixed plant & machinery thereon title no: 263499.
    Persone aventi diritto
    • Ffi (UK Finance) Public Limited Company
    Transazioni
    • 18 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 14 giu 1983
    Consegnato il 04 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge all book debts and other debts floating charge on (please see doc M13). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 14 giu 1983
    Consegnato il 04 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at the south of middbook road, southampton. Title no hp 203449.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 14 giu 1983
    Consegnato il 18 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges over undertaking and and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, stock in trade work-in progress, investments, cash & pre-payments, tog. With all buildings & fuxtures, fixed plant and machinery (see doc M11).
    Persone aventi diritto
    • Ffi (UK Finance) Public Limited Company
    Transazioni
    • 18 giu 1983Registrazione di un'ipoteca

    SNOWS BUSINESS FORMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 mar 2023Inizio dell'amministrazione
    12 mar 2024Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Smithson
    1580 Parkway
    Solent Business Park
    PO15 7AG Whiteley
    Hampshire
    Praticante
    1580 Parkway
    Solent Business Park
    PO15 7AG Whiteley
    Hampshire
    Michael Robert Fortune
    1580 Parkway Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    Hampshire
    Praticante
    1580 Parkway Solent Business Park
    Whiteley
    PO15 7AG Fareham
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0