01701536 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società01701536 LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01701536
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 01701536 LIMITED?

    • (4511) /

    Dove si trova 01701536 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Tabley Court
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 01701536 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TONY COX (DISMANTLERS) LIMITED22 feb 198322 feb 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di 01701536 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2003
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 lug 2004
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per 01701536 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 lug 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 ago 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per 01701536 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per 01701536 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagineREST-CVL

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed reach environmental\certificate issued on 23/06/20
    pagineCERTNM

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 ago 2016

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2016

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2015

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2015

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2011

    5 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * 6Th Floor Grafton Tower Stamford New Road Altrincham WA14 1DQ* in data 28 giu 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2008

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2008

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    Chi sono gli amministratori di 01701536 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COX, Joanne
    Chorley Road
    WS7 2PQ Burntwood
    212
    Staffordshire
    Segretario
    Chorley Road
    WS7 2PQ Burntwood
    212
    Staffordshire
    British275465270001
    ROEBUCK, Simon Carl
    171 Dickens Lane
    Poynton
    SK12 1NZ Stockport
    Cheshire
    Segretario
    171 Dickens Lane
    Poynton
    SK12 1NZ Stockport
    Cheshire
    British57529610001
    ROEBUCK, Brian
    The Old Police House
    Astbury
    CW12 4RQ Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Police House
    Astbury
    CW12 4RQ Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish148315530001
    ROEBUCK, Gregory John
    Chapel House Farm
    Brickbridge Road, Marple
    SK6 7BQ Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Chapel House Farm
    Brickbridge Road, Marple
    SK6 7BQ Stockport
    Cheshire
    British68547380001
    ROEBUCK, Scott David
    St Marys Cottage
    School Lane Astbury
    CW12 4RG Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    St Marys Cottage
    School Lane Astbury
    CW12 4RG Congleton
    Cheshire
    British38747890002
    ROEBUCK, Simon Carl
    171 Dickens Lane
    Poynton
    SK12 1NZ Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    171 Dickens Lane
    Poynton
    SK12 1NZ Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish57529610001
    COX, Irene
    Holly Farm
    Chorley
    WS13 8DQ Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    Holly Farm
    Chorley
    WS13 8DQ Lichfield
    Staffordshire
    British25778340001
    COX, Tony
    Holly Farm
    Chorley
    WS13 8DQ Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    Holly Farm
    Chorley
    WS13 8DQ Lichfield
    Staffordshire
    British25778330001
    DUDLEY, Mark Ian
    Brookfields Church Lane
    Middleton
    B78 2AN Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Brookfields Church Lane
    Middleton
    B78 2AN Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritish5775690002
    MACKINTOSH, Charles James
    Beamish Lane
    WV7 3JJ Albrighton
    Shropshire
    Amministratore
    Beamish Lane
    WV7 3JJ Albrighton
    Shropshire
    British25778350001

    01701536 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 11 mag 2001
    Consegnato il 22 mag 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at meaford power station and meford farm stone. T/no. SF350714. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 09 mag 2001
    Consegnato il 18 mag 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2002Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 25 mag 2007Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
      • Numero di pratica 1
    Legal charge
    Creato il 18 giu 1998
    Consegnato il 23 giu 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildingsat meaford power station and meaford farm stone staffordshire T.n SF350174.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 23 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 15 giu 1998
    Consegnato il 18 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 18 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 08 ott 1997
    Consegnato il 16 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage
    Brevi particolari
    3 sets of 2 condensers each (ie 6 pieces) weighing approx 200 tonnes made up of 70/30 cupro nickel tubes lying at usk mouth b power station and the benefit of any guarantees warranties and other obligations given by any manufacturer supplier or third party. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Flexdart Limited
    Transazioni
    • 16 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 giu 1997
    Consegnato il 09 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at meaford power station and meaford farm stone staffordshire t/n-SF350714.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of consent and charge
    Creato il 28 ott 1996
    Consegnato il 02 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest of the company in the land k/a chorley hall farm chorley lichefield staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of consent and charge
    Creato il 28 ott 1996
    Consegnato il 02 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from flexdart limited to the chargee on any acount whatsoever
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest of the company in the land k/a chorley hall farm chorley lichfield staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of consent and charge
    Creato il 28 ott 1996
    Consegnato il 02 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from flexdart limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest of the company in the land known as brook farm chorley lichfield staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of consent and charge
    Creato il 25 ott 1996
    Consegnato il 02 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest of the company in the land k/a brook farm chorley lichfield staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 27 set 1996
    Consegnato il 14 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of an agreement dated 27TH september 1996
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east side of south denes road great yarmouth t/n-NK166277.
    Persone aventi diritto
    • Flexdart Limited
    Transazioni
    • 14 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 set 1996
    Consegnato il 04 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and industrial units at the former power station meaford staffs and goodwill of any business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 26 lug 1996
    Consegnato il 08 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Brevi particolari
    Various commercial vehicles & plant as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 ott 1995
    Consegnato il 04 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at south denes road great yarmouth norfolk t/no.NK179144. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First legal charge
    Creato il 12 set 1994
    Consegnato il 27 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 12 august 1994 and this charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being the former south denes power station south denes road great yarmouth. All plant fixtures (including tenant's and trade fixtures) and all machinery fittings and equipment from time to time on the property hereby charged.
    Persone aventi diritto
    • Powergen PLC
    Transazioni
    • 27 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 09 set 1994
    Consegnato il 20 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 02 feb 1989
    Consegnato il 14 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Range rover efi reg. Mark F872 vdh mercedes 420SL reg. Mark: 1COX (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1989
    Consegnato il 13 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The metalgy works, swansfields, great bridge street, sandwell, west midlands, title no wm 242154.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 12 dic 1985
    Consegnato il 02 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See list of motor vehicles doc M10.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 02 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 gen 1984
    Consegnato il 11 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H the former ockerhill power station toll end road tipton west midland s.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 02 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 lug 1983
    Consegnato il 21 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 02 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 1983
    Consegnato il 21 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The former coventry power station alderman's green rd coventry W. midlands.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 02 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    01701536 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 mag 2001Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Neil Tombs
    Grant Thornton Uk Llp
    Enterprise House
    B3 2HJ 115 Edmund Street
    Birmingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    Enterprise House
    B3 2HJ 115 Edmund Street
    Birmingham
    Andrew Michael Menzies
    Grant Thornton Uk Llp
    Enterprise House
    B3 2HJ 115 Edmund Street
    Birmingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    Enterprise House
    B3 2HJ 115 Edmund Street
    Birmingham
    2
    DataTipo
    11 nov 2016Data prevista di scioglimento
    23 ott 2006Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Neil Henry
    Lines Henry
    6th Floor,Grafton Tower
    Stamford New Road
    Altrincham Wa14 1dq
    Praticante
    Lines Henry
    6th Floor,Grafton Tower
    Stamford New Road
    Altrincham Wa14 1dq
    Michael Simister
    Lines Henry
    6th Floor, Grafton Tower
    WA14 1DQ Stamford New Road
    Altrincham
    Praticante
    Lines Henry
    6th Floor, Grafton Tower
    WA14 1DQ Stamford New Road
    Altrincham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0