JARDINERIE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJARDINERIE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01706932
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JARDINERIE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova JARDINERIE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wyevale Garden Centres Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Middlesex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JARDINERIE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KEN ALLEN GARDEN CENTRES LIMITED16 mar 198316 mar 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di JARDINERIE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per JARDINERIE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Roger Mclaughlan come amministratore in data 01 feb 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Mary Elizabeth Bourlet come segretario in data 01 feb 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Laura Harradine-Greene come segretario in data 01 feb 2018

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 25 dic 2016

    4 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Mary Elizabeth Murray il 12 mag 2017

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Gerald Jones il 03 apr 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Justin Matthew King come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mary Elizabeth Murray come segretario in data 25 ago 2016

    2 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2015

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Justin Matthew King come amministratore in data 18 ago 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 18 ago 2016

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Gerald Jones il 22 lug 2016

    2 pagineCH01

    Nomina di Roger Mclaughlan come amministratore in data 10 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nils Olin Steinmeyer come amministratore in data 01 apr 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kevin Michael Bradshaw come amministratore in data 09 mar 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Anthony Gerald Jones come amministratore in data 06 apr 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 06 apr 2016

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Garden Centre Group, Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF in data 24 feb 2016

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di JARDINERIE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARRADINE-GREENE, Laura
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    242726240001
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish212265950002
    ALLEN, Ann Elizabeth
    Brook Cottage
    Kilcot
    GL18 1NR Newent
    Gloucestershire
    Segretario
    Brook Cottage
    Kilcot
    GL18 1NR Newent
    Gloucestershire
    British5527460001
    BOURLET, Mary Elizabeth
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    217312210002
    FOALE, Stephen John
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    Segretario
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    British37403500001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Segretario
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    British76162020001
    ALLEN, Ann Elizabeth
    Brook Cottage
    Kilcot
    GL18 1NR Newent
    Gloucestershire
    Amministratore
    Brook Cottage
    Kilcot
    GL18 1NR Newent
    Gloucestershire
    United KingdomBritish5527460001
    ALLEN, Kenneth Henry
    Brook Cottage
    Kilcot
    GL18 1NR Newent
    Gloucestershire
    Amministratore
    Brook Cottage
    Kilcot
    GL18 1NR Newent
    Gloucestershire
    United KingdomBritish5527470001
    BERTRAM, Richard Christiaan
    18 Ham Island
    Old Windsor
    SL4 2JY Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    18 Ham Island
    Old Windsor
    SL4 2JY Windsor
    Berkshire
    British6217370002
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish124019940001
    BRAID, William
    Beechwood House
    Springfields
    GL17 9BW Drybrook
    Gloucestershire
    Amministratore
    Beechwood House
    Springfields
    GL17 9BW Drybrook
    Gloucestershire
    British72263080001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish195802400001
    FOALE, Stephen John
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    EnglandBritish37403500001
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Amministratore
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritish606430001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish72128340003
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish213157990001
    KING, Wendy
    9 Fielden
    Abbeydale
    GL4 5EW Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    9 Fielden
    Abbeydale
    GL4 5EW Gloucester
    Gloucestershire
    EnglandBritish89910600001
    KITCHING, Jonathan Andrew
    Beech House
    Harp Hill
    GL52 6PR Cheltenham
    Amministratore
    Beech House
    Harp Hill
    GL52 6PR Cheltenham
    EnglandBritish68271660002
    KITCHING, Julie
    Hill View Cottage
    Pamington
    GL20 8LT Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Hill View Cottage
    Pamington
    GL20 8LT Tewkesbury
    Gloucestershire
    British32857190001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124967710001
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish111439220001
    LORIMER, Alistair Martin
    3 Aston Cantlow Road
    Wilmcote
    CV37 9XN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    3 Aston Cantlow Road
    Wilmcote
    CV37 9XN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish64929030001
    LORIMER, Alistair Martin
    3 Aston Cantlow Road
    Wilmcote
    CV37 9XN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    3 Aston Cantlow Road
    Wilmcote
    CV37 9XN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish64929030001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    Amministratore
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    WalesBritish1470180001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish206428840001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish207509410001
    PIERPOINT, David Julian
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    Amministratore
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    EnglandBritish138653690001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Amministratore
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritish76162020001
    SAJID, Salim
    Apple Croft
    9 High Street
    HP17 8ES Haddenham
    Amministratore
    Apple Croft
    9 High Street
    HP17 8ES Haddenham
    British75730550003
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomGerman126422100002
    STEVENSON, Barry John
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    EnglandBritish102595670001
    ULYATT, Patricia Mary
    Northington Cottage
    Awre
    GL14 1BN Newham On Severn
    Gloucestershire
    Amministratore
    Northington Cottage
    Awre
    GL14 1BN Newham On Severn
    Gloucestershire
    British24998620001
    ULYATT, Peter Nicholas
    Northington Cottage
    Awre
    GL14 1BN Newham On Severn
    Gloucestershire
    Amministratore
    Northington Cottage
    Awre
    GL14 1BN Newham On Severn
    Gloucestershire
    British24998630001
    WARES, Hugh David Mcdonald
    12 Old Sneed Park
    BS9 1RF Bristol
    Amministratore
    12 Old Sneed Park
    BS9 1RF Bristol
    British84123870001

    Chi sono le persone con controllo significativo di JARDINERIE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Blooms Of Bressingham Holdings Limited
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres Limited
    England
    06 apr 2016
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres Limited
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England & Wales
    Numero di registrazione03892554
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    JARDINERIE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 24 feb 2009
    Consegnato il 04 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    Transazioni
    • 04 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to the debenture
    Creato il 12 dic 2007
    Consegnato il 21 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For details of properties charged pleas. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 21 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • West Coast Capital (Hortis) Limited
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent for the Finance Parties (Thesecurity Agent)
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 feb 2007
    Consegnato il 24 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 2003
    Consegnato il 05 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a finebush nurseries hay lane studley grange swindon.
    Persone aventi diritto
    • Kenneth Henry Allen as Trustee for the Holders of the Convertible Secured Loanstock of Bloomsof Bressingham Holdings PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 mag 2001
    Consegnato il 24 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as the garden centre at kenilworth rd,hampton in arden,solihull; wm 396108.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 mag 2001
    Consegnato il 24 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as st mellons garden centre,newport rd,cardiff.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 mag 2001
    Consegnato il 24 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as studley garden centre,studley green,high wycombe,buckinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 mag 2001
    Consegnato il 24 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as the garden centre at kenilworth rd,hampton in arden,solihull; wm 402338.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 mag 2001
    Consegnato il 24 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as jardinerie garden centre,evesham rd,bishop cleve together with additional land at evesham rd,bishop cleve,cheltenham,gloucestershire; t/no gr 221868.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 mag 2001
    Consegnato il 24 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as three crowns garden centre,walsall; t/no wm 402337.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 mag 2001
    Consegnato il 24 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as finebush nurseries,hay lane,studley grange,swindon; t/nos wt 140708 and wt 142181.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 mag 2001
    Consegnato il 24 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or blooms of bressingham holdings PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as haresfield garden centre,haresfield,gloucester; t/no gr 183956.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 mag 2001
    Consegnato il 24 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 mag 2001
    Consegnato il 18 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities due or to become due from the company to the chargee as trustee for the holders of the convertible secured loan stock of blooms of bressingham holdings PLC as the same is contributed by an instrument of even date and executed by blooms of bressingham holdings PLC
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the property st mellons garden centre newport road cardiff jardinerie garden centre evesham road bishop cleve together with additional land at evesham road bishop cleve cheltenham gloucestershire haresfield garden centre haresfield gloucester please refer to the form 395 for further details of the property charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kenneth Henry Allen
    Transazioni
    • 18 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 gen 2001
    Consegnato il 04 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    St mellons park garden centre st mellons cardiff.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 ago 2000
    Consegnato il 05 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land on the south side of kenilworth road hampton in arden solihull west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 2000
    Consegnato il 22 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a jardinerie garden centre evesham road cheltenham gloucestershire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1998
    Consegnato il 22 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Jardinerie garden centre hay lane swindon wiltshire t/n WT140708 WT142181.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 nov 1995
    Consegnato il 08 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 1995
    Consegnato il 06 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the south side of kenilworth road, hampton in arden, solihull, west midlands t/no. WM396108.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 1995
    Consegnato il 06 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the south side of kenilworth road, hampton in arden, solihull, west midlands t/no. WM402338.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 mar 1995
    Consegnato il 24 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a finebush garden centre hay lane swindon and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 dic 1993
    Consegnato il 04 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a st. Mellons garden centre newport road cardiff t/n WA683954 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0