SMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED

SMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01712157
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MSQ PARTNERS LIMITED
    90 Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IAS SMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED26 apr 200626 apr 2006
    CITIGATE SMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED23 feb 200523 feb 2005
    CITIGATE COMMUNICATIONS LIMITED 01 mar 200201 mar 2002
    KEY COMMUNICATIONS LIMITED01 set 198301 set 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di SMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A4YPSYL6

    Bilancio annuale redatto al 18 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 set 2015

    Stato del capitale al 30 set 2015

    • Capitale: GBP 2,850
    SH01
    X4GYJJ74

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Fourth Floor, 10 Rathbone Place London W1T 1HP England a C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA

    1 pagineAD02
    X4GYJJ54

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ

    1 pagineAD04
    X4GYJJ5C

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2015

    9 pagineAA
    A4FIBQL4

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 28 feb 2014

    11 pagineAA
    A3JDZYZC

    legacy

    29 paginePARENT_ACC
    A3JDZYY0

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2
    A3JDZYYG

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2
    A3JDZYY8

    Bilancio annuale redatto al 18 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 set 2014

    Stato del capitale al 18 set 2014

    • Capitale: GBP 2,850
    SH01
    X3GPSO7E

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Fourth Floor, 10 Rathbone Place London W1T 1HP

    1 pagineAD03
    X3GPSO5U

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Fourth Floor, 10 Rathbone Place London W1T 1HP

    1 pagineAD02
    X3GPSO5M

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    5 pagineMR04
    A3FLWSAY

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Msq Partners Ltd 6 York Street York Street London W1U 6PL England a C/O Msq Partners Limited 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ in data 13 ago 2014

    1 pagineAD01
    X3E787TM

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2
    A380DR1L

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2
    A380DR1D

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    6 pagineAA
    A2L7RORN

    Bilancio annuale redatto al 18 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 set 2013

    Stato del capitale al 25 set 2013

    • Capitale: GBP 2,850
    SH01
    X2HNHJYW

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Media Square Plc 6 York Street London W1U 6PL United Kingdom* in data 25 set 2013

    1 pagineAD01
    X2HNHJYO

    Nomina di Mr Daniel Yardley come amministratore

    2 pagineAP01
    X2EMY1TT

    Nomina di Mr Peter David Reid come amministratore

    2 pagineAP01
    X29YV4P6

    Cessazione della carica di Dean Wright come amministratore

    1 pagineTM01
    X29YV4BC

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    6 pagineAA
    A1MPIU96

    Chi sono gli amministratori di SMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHAH, Ashish
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Segretario
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    164804650001
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishGroup Ceo147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    Amministratore
    c/o Msq Partners Limited
    Tottenham Court Road
    W1T 4TJ London
    90
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer180507300001
    BATE, Ian Christopher
    23 Clares Green Road
    Spencers Wood
    RG7 1DY Reading
    Berkshire
    Segretario
    23 Clares Green Road
    Spencers Wood
    RG7 1DY Reading
    Berkshire
    BritishFinance Controller50464210001
    BRIGDEN, Colin John
    C/O Media Square Plc, Clarence
    Mill, Clarence Road
    SK10 5JZ Bollington
    Cheshire
    Segretario
    C/O Media Square Plc, Clarence
    Mill, Clarence Road
    SK10 5JZ Bollington
    Cheshire
    147347980001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Segretario
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    British76600500002
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    British53461320002
    GULLIVER, Christopher Robin
    4 Wood End
    RG45 6DQ Crowthorne
    Berkshire
    Segretario
    4 Wood End
    RG45 6DQ Crowthorne
    Berkshire
    British2017070001
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Segretario
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    NICHOLS, Richard Stephen
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant54128690001
    RYDER, Christine Eve
    Pimms Farm
    Stanton Harcourt
    OX8 1AR Oxford
    Segretario
    Pimms Farm
    Stanton Harcourt
    OX8 1AR Oxford
    British6727920001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Segretario
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    BATE, Ian Christopher
    23 Clares Green Road
    Spencers Wood
    RG7 1DY Reading
    Berkshire
    Amministratore
    23 Clares Green Road
    Spencers Wood
    RG7 1DY Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Secretary50464210001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director75720570001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Amministratore
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    EnglandBritishChartered Accountant76600500002
    DAVIES, Christine Joy
    45 Carless Avenue
    Harborne
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    45 Carless Avenue
    Harborne
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    BritishManaging Director40176610002
    DAVIS, David Henry
    67 Albion Gate
    Albion Street
    W2 2LA London
    Amministratore
    67 Albion Gate
    Albion Street
    W2 2LA London
    BritishDirector66447180001
    FRASER, Elizabeth
    42 Garth Road
    TN13 1RX Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    42 Garth Road
    TN13 1RX Sevenoaks
    Kent
    BritishPublic Relations Consultant15022500001
    FRITH, Susan Claire
    80 Main Street
    Foxton Market Harborough
    LE16 7RB Leicester
    Amministratore
    80 Main Street
    Foxton Market Harborough
    LE16 7RB Leicester
    United KingdomBritishCompany Director102752630001
    GULLIVER, Christopher Robin
    4 Wood End
    RG45 6DQ Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    4 Wood End
    RG45 6DQ Crowthorne
    Berkshire
    EnglandBritishDirector2017070001
    KENT, Colin John
    Pond Farm
    Worminghall
    HP18 9JR Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pond Farm
    Worminghall
    HP18 9JR Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector5251440001
    MORRICE, Robert Mcdonald
    12/3 Wellington Place
    EH6 7EQ Edinburgh
    Amministratore
    12/3 Wellington Place
    EH6 7EQ Edinburgh
    BritishDirector38104960005
    NICHOLS, Richard Stephen
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director54128690003
    PEARSON, Harriet Rose
    38 Rose Road
    B17 9LJ Birmingham
    Amministratore
    38 Rose Road
    B17 9LJ Birmingham
    BritishCompany Director103638570001
    READ, Felicity Ann
    2 Manor Cottage
    Kilham Lane Shipton Oliffe
    GL54 4HX Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    2 Manor Cottage
    Kilham Lane Shipton Oliffe
    GL54 4HX Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishPr Consultant65295670003
    ROXAN, Adrian
    40 Cecil Road
    Muswell Hill
    N10 2BU London
    Amministratore
    40 Cecil Road
    Muswell Hill
    N10 2BU London
    BritishCompany Director58198200002
    RYDER, Christine Eve
    Pimms Farm
    Stanton Harcourt
    OX8 1AR Oxford
    Amministratore
    Pimms Farm
    Stanton Harcourt
    OX8 1AR Oxford
    BritishP R Consultant6727920001
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Amministratore
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritishFinance Director10691510002
    STEEDS, Kevin Barrie
    20 Fortismere Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BL London
    Amministratore
    20 Fortismere Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BL London
    BritishChartered Accountant14119150003
    TRIGGS, Mark David
    Griffiths Green
    Claverley
    WV5 7BG Wolverhampton
    The Orchard
    West Midlands
    Amministratore
    Griffiths Green
    Claverley
    WV5 7BG Wolverhampton
    The Orchard
    West Midlands
    EnglandBritishDirector94520260001
    WATSON, David Alan
    Holly House 37 Shirleys
    Ditchling
    BN6 8UD Hassocks
    Sussex
    Amministratore
    Holly House 37 Shirleys
    Ditchling
    BN6 8UD Hassocks
    Sussex
    EnglandBritishPr Consultant21407240002
    WELLS, Robert George
    12 Mowbray Drive
    Linslade
    LU7 7PH Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Amministratore
    12 Mowbray Drive
    Linslade
    LU7 7PH Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishPublishing Director40176680001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Amministratore
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant147948820001
    WRIGHT, David Ernest
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    BritishDirector14119160001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector159138180001

    SMARTS (BIRMINGHAM) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 08 dic 2011
    Consegnato il 29 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Accession deed
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 lug 1999
    Consegnato il 18 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 giu 1990
    Consegnato il 21 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 17 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0