C C S SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | C C S SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01719681 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di C C S SERVICES LIMITED?
- Attività di organizzazioni di categoria di imprenditori e datori di lavoro (94110) / Altre attività di servizi
- Attività di altre organizzazioni di categoria n.c.a. (94990) / Altre attività di servizi
Dove si trova C C S SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 5 1st Floor, 5 Doolittle Yard Froghall Road MK45 2NW Ampthill Bedfordshire England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di C C S SERVICES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per C C S SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2016 al 30 set 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 24 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Donald Alphonsus Gerard Mackinnon come amministratore in data 16 set 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher John Field il 28 set 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Stuart Atchison il 28 set 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Adrian Robert Gibbs come amministratore in data 15 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 91 Fleet Road Fleet Hampshire GU51 3PJ England a 5 1st Floor, 5 Doolittle Yard Froghall Road Ampthill Bedfordshire MK45 2NW in data 19 mag 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Colin Leslie Felton come amministratore in data 07 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Adrian Robert Gibbs come amministratore in data 14 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 91 Victoria Road Aldershot Hampshire GU11 1EJ England a 91 Fleet Road Fleet Hampshire GU51 3PJ in data 10 giu 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Rwf Rubenstein 171 Bury New Road Whitefield Manchester M45 6AB a 91 Victoria Road Aldershot Hampshire GU11 1EJ in data 06 mag 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Colin Michael Hale come amministratore in data 22 apr 2015 | AP01 | |||||||||||
Nomina di Mr Howard Martin Klein come amministratore in data 22 apr 2015 | AP01 | |||||||||||
Chi sono gli amministratori di C C S SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATCHISON, Peter Stuart | Amministratore | 1st Floor, 5 Doolittle Yard Froghall Road MK45 2NW Ampthill 5 Bedfordshire England | England | British | Company Director | 73971760002 | ||||
FELTON, Colin Leslie | Amministratore | Quorn Gardens SS9 2TA Leigh-On-Sea 73 Essex England | United Kingdom | British | Company Director | 13681480001 | ||||
FIELD, Christopher John | Amministratore | 1st Floor, 5 Doolittle Yard Froghall Road MK45 2NW Ampthill 5 Bedfordshire England | England | British | Retired | 6047830003 | ||||
HALE, Colin Michael | Amministratore | Flaxman Road BD2 2EL Bradford 28 West Yorkshire England | United Kingdom | British | Lawyer | 118744540001 | ||||
KLEIN, Howard Martin | Amministratore | Wilderspool Causeway WA4 6PS Warrington St James Court England | England | British | Management Consultant | 54511790001 | ||||
MACKINNON, Donald Alphonsus Gerard | Amministratore | 1st Floor, 5 Doolittle Yard Froghall Road MK45 2NW Ampthill 5 Bedfordshire England | Scotland | British | Chartered Arbitrator, Construction Manager | 119263340001 | ||||
BROUGH, Georgette Hide | Segretario | 7 Olivers Walk Lychpit RG24 8SD Basingstoke Hampshire | British | Administrator | 103917670001 | |||||
HUXTABLE, Peter John Carragher | Segretario | 75 High Street GU11 1BY Aldershot Hampshire | British | 6392690001 | ||||||
LEWIS, Peter Trevor | Segretario | 148b Junction Road Western Mews SP10 3JF Andover Hampshire | British | Commercial Manager | 84142560001 | |||||
PARKES, Amy | Segretario | c/o Rwf Rubenstein Bury New Road Whitefield M45 6AB Manchester 171 United Kingdom | 172421200001 | |||||||
SPANTON, Patricia Anne | Segretario | 102 Beverley Gardens Pinkneys Green SL6 6SW Maidenhead Berkshire | British | Lawyer | 41710590002 | |||||
GIBBS, Adrian Robert | Amministratore | Crookham Road GU51 5DZ Fleet 20 Hampshire England | United Kingdom | Australian | Company Director | 87212340001 | ||||
GIBBS, Adrian Robert | Amministratore | Stanton Lodge South 20 Crookham Road GU51 5DZ Fleet Hampshire | United Kingdom | Australian | Lawyer | 87212340001 | ||||
HUXTABLE, Elisabeth | Amministratore | 10 Crossways GU12 4LX Aldershot Hampshire | British | Director | 6392700002 | |||||
HUXTABLE, Peter John Carragher | Amministratore | 75 High Street GU11 1BY Aldershot Hampshire | British | Director | 6392690001 | |||||
HUXTABLE, Victoria Louise | Amministratore | 10 Crossways GU12 4LX Aldershot Hampshire | British | Student & Part Time Accounts A | 80383860001 | |||||
SPANTON, Patricia Anne | Amministratore | 102 Beverley Gardens Pinkneys Green SL6 6SW Maidenhead Berkshire | British | Lawyer | 41710590002 | |||||
WOOLFE, Stephen Jonathon | Amministratore | 86 Scholes Lane M25 0AU Prestwich Lancashire | England | British | Company Secretary Conductix-Wampfler Ltd | 106024410001 | ||||
WOOLFE, Stephen Jonathon | Amministratore | 86 Scholes Lane M25 0AU Prestwich Lancashire | England | British | Company Accountant | 106024410001 | ||||
WRIGHT, Nicholas John James | Amministratore | 38 Lulworth Close GU14 8TR Farnborough Hampshire | British | Digital Print Manager | 80383830001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per C C S SERVICES LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
22 mar 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
C C S SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creato il 01 ago 2003 Consegnato il 09 ago 2003 | In corso | Importo garantito £5,434.38 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company's interest in the deposit account and all money form time to time withdrawn from the deposit account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 ago 1998 Consegnato il 14 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over book debts | Creato il 25 set 1992 Consegnato il 06 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific charge over the benefit of all book debts and other as are now or may from time to time due or owing to the company but so that the company shall pay into the company's account with the bank. For full details please see doc M69L. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0