ROSGILL GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ROSGILL GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01721195 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ROSGILL GROUP LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ROSGILL GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Church Bridge House Henry Street BB5 4EE Accrington United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ROSGILL GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PINDERGROVE LIMITED | 06 mag 1983 | 06 mag 1983 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ROSGILL GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 26 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per ROSGILL GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Nomina di Mr Michael Arnaouti come amministratore in data 17 dic 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Michael Arnaouti come segretario in data 17 dic 2021 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Mark Ashcroft come segretario in data 16 dic 2021 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Mark Ashcroft come amministratore in data 16 dic 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 26 mar 2021 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 27 mar 2020 | 2 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Philip Binns Maudsley come amministratore in data 26 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 29 mar 2019 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 mar 2018 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mark Ashcroft il 02 apr 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Binns Maudsley il 02 apr 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Murdoch Caldwell il 01 apr 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Modifica dei dettagli di The Dee Group P.L.C. come persona con controllo significativo il 02 mar 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Gregory Street Hyde Cheshire SK14 4th a Church Bridge House Henry Street Accrington BB5 4EE in data 01 mar 2018 | 1 pagine | AD01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Timothy John Kowalski come amministratore in data 05 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mark Ashcroft come amministratore in data 06 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Stuart Murdoch Caldwell come amministratore in data 06 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di ROSGILL GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAOUTI, Michael | Segretario | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | 290653780001 | |||||||
| ARNAOUTI, Michael | Amministratore | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | England | British | 539040004 | |||||
| CALDWELL, Stuart Murdoch | Amministratore | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 229000880001 | |||||
| ASHCROFT, Mark | Segretario | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire United Kingdom | 165368850001 | |||||||
| BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Segretario | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | British | 14333000007 | ||||||
| CANN, Geoffrey | Segretario | 11 Malmesbury Avenue Midway DE11 7PS Swadlincote Derbyshire | British | 12477370001 | ||||||
| HALE, Donald | Segretario | Trees House Staupes Road High Birstwith HG3 2LF Harrogate North Yorkshire | British | 75316130001 | ||||||
| ASHCROFT, Mark | Amministratore | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 113691350001 | |||||
| BELL, Allan Morris | Amministratore | Flat B6 Calthorpe Mansions Calthorpe Road Edgbaston B15 1QS Birmingham West Midlands | British | 47809770001 | ||||||
| BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Amministratore | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | United Kingdom | British | 14333000007 | |||||
| CHAPMAN, Keith | Amministratore | Flasby BD23 3PX Skipton Flasby Hall North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 143093130001 | |||||
| DAVID, Andrew Charles | Amministratore | 56 Wellfield Road Alrewas DE13 7EZ Burton On Trent Staffordshire | British | 37485690001 | ||||||
| HALE, Donald | Amministratore | Trees House Staupes Road High Birstwith HG3 2LF Harrogate North Yorkshire | British | 75316130001 | ||||||
| JOHNSON, David Anthony | Amministratore | Cold Knoll Farm Stanbury BD22 0HH Haworth West Yorkshire | United Kingdom | British | 157156750001 | |||||
| JOLLY, Patrick Edmund | Amministratore | Hill Top Farm Hill Top Lane Skipton Road, BB18 6JN Earby Lancashire | England | British | 75327660001 | |||||
| KING, Dennis | Amministratore | 13 Dower House Crescent TN4 0TT Southborough Kent | British | 55754500001 | ||||||
| KITE, Ronald | Amministratore | Keston Hall Lane Doveridge DE6 5NQ Ashbourne Derbyshire | British | 13131070001 | ||||||
| KOWALSKI, Timothy John | Amministratore | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | Uk | British | 153335190003 | |||||
| MAUDSLEY, Philip Binns | Amministratore | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 15967010001 | |||||
| MOUNTFORD, Ewart | Amministratore | 11 Ambleside Court CW12 4HZ Congleton Cheshire | British | 13300230001 | ||||||
| PHILLIPS, Maureen Edith | Amministratore | 82 Briar Road DA5 2HW Bexley Kent | British | 13176070001 | ||||||
| SIDDLE, Roger William John | Amministratore | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | England | British | 46903210001 | |||||
| TURNER, Christopher Paul | Amministratore | 12 Highcroft NG3 5LP Nottingham | United Kingdom | British | 114003570001 | |||||
| WILLIAMS, Keith John | Amministratore | 12 The Hay Barn Walmley B76 1DE Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 12477390001 | |||||
| WOODS, Roger Slater | Amministratore | 229 Burton Road Branston DE14 3DR Burton On Trent Staffordshire | British | 13300240001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ROSGILL GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Dee Group P.L.C. | 06 apr 2016 | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ROSGILL GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Creato il 20 mag 1991 Consegnato il 05 giu 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 25 nov 1988 Consegnato il 13 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge overthe: undertaking and all property and assets present and future including book debts & uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 03 dic 1986 Consegnato il 04 dic 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a anglesey house anglesey road burton on trent staffordshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 17 feb 1984 Consegnato il 06 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due secured on property acquired by rosgill group limited on 29/4/86 | |
Brevi particolari All book debts and other debts now and from time to time due or owing to holdings (for details please see doc M23). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 17 feb 1984 Consegnato il 02 mar 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (See doc M22). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Series of debentures | Creato il 17 feb 1984 Consegnato il 22 feb 1984 | Soddisfatta integralmente | ||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0