FORECOURT PROPERTIES LIMITED

FORECOURT PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFORECOURT PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01723832
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FORECOURT PROPERTIES LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova FORECOURT PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3rd Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FORECOURT PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JADEFUN LIMITED17 mag 198317 mag 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di FORECOURT PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per FORECOURT PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2011

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 lug 2011

    Stato del capitale al 14 lug 2011

    • Capitale: GBP 3,185,825
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    13 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2010 al 30 mar 2010

    3 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Trafalgar Officers Limited il 22 giu 2010

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Reit(Corporate Services) Limited il 09 dic 2009

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maurice Moses Benady il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    14 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    15 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    8 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    15 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di FORECOURT PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    Amministratore
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6745658
    135316290001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Segretario
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    ROBERTS, Geoffrey Michael
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    Segretario
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    British29217560001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    Amministratore
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    British7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    FORECOURT PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 15 set 2004
    Consegnato il 29 set 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 29 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 19 gen 2000
    Consegnato il 31 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land k/a brimrod high street chalfont st peter and land k/a the grange garage high street chalfont st peter t/nos.BM171862 and BM2130. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 gen 2000
    Consegnato il 20 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land k/a brimrod high street chalfont st peter and land k/a the grange garage high street chalfont st peter t/nos: BM171862 and BM2130. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 18 ott 1999
    Consegnato il 23 ott 1999
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 20 mar 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 mar 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Guarantee and mortgage debenture
    Creato il 04 ago 1992
    Consegnato il 19 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as "security trustee" for itself and the secured parties (all as defined therein ) and to the secured parties on any account whatsoever under the terms of this deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 feb 1992
    Consegnato il 24 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the 02 goodwill book and other debts.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1988
    Consegnato il 06 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    197 high street uxbridge middlesex.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 gen 1986
    Consegnato il 20 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H property k/a 6 chippendale waye, uxbridge, london borough of hillingdon. T/n: ngl 443478.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 10 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 apr 1985
    Consegnato il 03 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 7 chippendale waye uxbridge middlesex t/n:- ngl 360288.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 10 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mar 1985
    Consegnato il 26 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H propety k/a 8 chippendale waye uxbridge middlesex.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 10 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 mar 1984
    Consegnato il 13 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    214-218 high street uxbridge. 4-13 the square, uxbridge and land at the rear tog. With the land edged red on the plan annexed to a transfer dated 9/3/84. title nos:- ngl 229008, mx 79874, mx 95436, mx 223252, mx 113581, mx 270848, mx 108001.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 10 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 1983
    Consegnato il 23 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - 207-211 high street uxbridge L.B. of hillingdon inc. Land at the rear thereof. Title nos:- mx 428528 mx 474398 mx 153714 ngl 118243.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 10 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0