LA LEISURE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLA LEISURE LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01728962
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di LA LEISURE LIMITED?

    • Creazione artistica (90030) / Attività artistiche, sportive e di divertimento
    • Gestione di impianti sportivi (93110) / Attività artistiche, sportive e di divertimento
    • Altre attività di divertimento e di svago n.c.a. (93290) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova LA LEISURE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Pure Gym Limited
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LA LEISURE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    L.A. FITNESS LIMITED28 mag 199928 mag 1999
    C.S. LEISURE LIMITED10 gen 198910 gen 1989
    BRENTLYN LIMITED03 giu 198303 giu 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di LA LEISURE LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per LA LEISURE LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al01 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per LA LEISURE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Mr Clive Alexander Sloan Chesser come amministratore in data 31 dic 2024

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Rebecca Elizabeth Passmore come amministratore in data 31 dic 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Humphrey Michael Cobbold come amministratore in data 31 dic 2024

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2023

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    22 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alexander Basil John Wood il 31 mag 2022

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    21 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    24 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Humphrey Michael Cobbold il 01 nov 2019

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    19 pagineAA

    Nomina di Mr Alexander Basil John Wood come amministratore in data 10 ott 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Adam John Gordon Bellamy come amministratore in data 10 ott 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Adam John Gordon Bellamy come segretario in data 10 ott 2018

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    22 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter William Denby Roberts come amministratore in data 30 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jacques De Bruin come amministratore in data 30 nov 2017

    1 pagineTM01

    Seconda presentazione per la nomina di Jacques De Bruin come amministratore

    6 pagineRP04AP01

    Chi sono gli amministratori di LA LEISURE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHESSER, Clive Alexander Sloan
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive Officer329718250001
    PASSMORE, Rebecca Elizabeth
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Operating Officer330745170001
    WOOD, Alexander Basil John
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer251374440001
    BELLAMY, Adam John Gordon
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Segretario
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    198434650001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    BritishChief Financial Occifer124301460001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Segretario
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    British114849640001
    TAYLOR, Graham
    14 Roupell Street
    SE1 8SP London
    Segretario
    14 Roupell Street
    SE1 8SP London
    British82374420004
    TURNER, David
    1 Village Close
    Belsize Lane Hampstead
    NW3 5AH London
    Segretario
    1 Village Close
    Belsize Lane Hampstead
    NW3 5AH London
    British5194700001
    WENBOURNE, Stewart James
    56 Bladindon Drive
    DA5 3BN Bexley
    Kent
    Segretario
    56 Bladindon Drive
    DA5 3BN Bexley
    Kent
    British49164890001
    BELLAMY, Adam John Gordon
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector172693720002
    BRODY, Rodney David
    Brook House High Road
    IG7 6PX Chigwell
    Essex
    Amministratore
    Brook House High Road
    IG7 6PX Chigwell
    Essex
    BritishManaging Director5194680001
    BROSTER, Stuart Paul
    Greystones Bromley Road
    Cockleford Heath Ardleigh
    CO7 7SE Colchester
    Essex
    Amministratore
    Greystones Bromley Road
    Cockleford Heath Ardleigh
    CO7 7SE Colchester
    Essex
    United KingdomBritishDirector114847350001
    BRUIN, Jacques De
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    United KingdomSouth AfricanDirector198346420001
    CHESTER, Ross Steven
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    BritishDirector137527310001
    COBBOLD, Humphrey Michael
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector100141010002
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishChief Financial Occifer124301460001
    HUGO, Schalk James Burger
    48 Queens Road
    SL4 3BH Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    48 Queens Road
    SL4 3BH Windsor
    Berkshire
    BritishSales Director109942000002
    LONG, Martin
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector125885350001
    MCCOLL, Arthur
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    AustraliaBritishDirector139099550001
    ROBERTS, Peter William Denby
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    The Hutts
    United Kingdom
    Amministratore
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    The Hutts
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector106538510001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector114849640001
    TAYLOR, Jeremy Guy
    59 Sandlands Road
    KT20 7XB Walton On The Hill
    Surrey
    Amministratore
    59 Sandlands Road
    KT20 7XB Walton On The Hill
    Surrey
    BritishDirector117619380001
    TAYLOR, Richard
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    BritishFinance Director71126560002
    TURNER, David
    1 Village Close
    Belsize Lane Hampstead
    NW3 5AH London
    Amministratore
    1 Village Close
    Belsize Lane Hampstead
    NW3 5AH London
    United KingdomBritishDirector5194700001
    TUROK, Frederick Oliver
    1 Broome Hall
    RH5 6HJ Cold Harbour
    Surrey
    Amministratore
    1 Broome Hall
    RH5 6HJ Cold Harbour
    Surrey
    EnglandSouth AfricanDirector41174400002

    Chi sono le persone con controllo significativo di LA LEISURE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03224406
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LA LEISURE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 giu 2015
    Consegnato il 06 lug 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 06 lug 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 ago 2015Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 05 lug 2016Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 26 giu 2014
    Consegnato il 02 lug 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All the property of the company whatsoever and wheresover both present and future, including:. 1. all the lands and premises comprised in an indenture of sub-lease dated 25 september 2002 made between la fitness limited (formerly called la fitness PLC) and la leisure limited being lands and premises at 22 adelaide street, belfast, co. Antrim; and. 2. all the lands and premises comprised in folios DN102644L co. Down being the lands and premises comprised in an indenture of lease dated 7 november 2002 made between la fitness PLC and la leisure limited, comprising a hotel fitness centre at shaws bridge belfast; and. 3. all the lands and premises comprised in folio AR96420L co armagh being the lands and premises comprised in an indenture of lease dated 19 september 2003 made between armagh city hotel limited la leisure limited and la fitness PLC being lands and premises at armagh city hotel, friary road, armagh, co. Armagh.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 giu 2014
    Consegnato il 19 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole 275-309 argyle street, glasgow t/no GLA171048.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 giu 2014
    Consegnato il 19 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole 110-112 main street, milngavie t/no DMB71821.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 05 giu 2014
    Consegnato il 10 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 10 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 mag 2014
    Consegnato il 16 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Leasehold land known as the ground and basement floor 48 leadenhall street london.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 dic 2013
    Consegnato il 31 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H land k/a part sub-basement part basement and ground floor retail unit b the st botolph building 138-139 houndswitch london.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 31 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental security and confirmation deed
    Creato il 30 ago 2011
    Consegnato il 13 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties and all monies due or to become due from the chargors to all or any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its relevant assets as more specifically referred to in the relevant security documents upon the terms contained in the relevant security documents. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 01 dic 2010
    Consegnato il 03 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    £5,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    £5,000.
    Persone aventi diritto
    • Hayfield Investments Inc
    Transazioni
    • 03 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Supplemental mortgage
    Creato il 07 dic 2009
    Consegnato il 11 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/H land at the rear of gravelly lane, erdington, sutton coldfield see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental legal mortgage to a debenture dated 6 may 2005
    Creato il 07 lug 2009
    Consegnato il 15 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land at the rear of gravelly lane erdington sutton coldfield see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 15 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental legal mortgage
    Creato il 21 mag 2009
    Consegnato il 22 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Units 6-8 and units 12-16 the royal oak shopping centre brighton road purley surrey t/no SGL606941.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental legal mortgage
    Creato il 28 apr 2009
    Consegnato il 12 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Under clause 2 of the supplemental legal mortgage by way of legal mortgage its interest in brooklands cricket & lawn tennis club whitehall road sale t/no. GM817392, west cheshire squash club wrexham road chester t/no. CH419565; the security was created as a continuing security to secure the payment and discharge of the secured liabilities see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental legal mortgage
    Creato il 28 apr 2009
    Consegnato il 12 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Under clause 2 of the supplemental legal mortgage by way of legal mortgage its interest in the sub-underlease of the premises in the basement and lower ground floor of 20 little britain london; the security was created as a continuing security to secure the payment and discharge of the secured liabilities see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 21 giu 2006
    Acquisito il 24 apr 2009
    Consegnato il 02 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land k/a 81-83 kimbolton road bedford t/no's BD19226 and BD22062. L/h land k/a dragons health club, chindits lane, warley, brentwood, essex t/no EX590850. L/h land k/a land and buildings on the south east side of liversage road, derby t/no DY136843.for details of further property charged please refer to form 395, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 giu 2009Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 21 giu 2006
    Acquisito il 24 apr 2009
    Consegnato il 02 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole of the l/h land k/a dragons health club, webb ellis road, rugby t/no WK293062 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 giu 2009Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 20 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creato il 21 giu 2006
    Acquisito il 24 apr 2009
    Consegnato il 02 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    L/H lane known as burnham squash club 821A yeovil road trading estate slough t/no BK315801 and l/h land known as northwood squash centre chestnut avenue northwood middlesex t/no AGL37538.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2009Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 20 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creato il 21 giu 2006
    Acquisito il 24 apr 2009
    Consegnato il 02 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    L/H land known as maidstone tennis and fitness centre st peter street maidstone t/no K817534.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2009Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 20 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 mar 2006
    Acquisito il 06 mag 2009
    Consegnato il 02 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south side of rodwell road/western avenue, northolt, ealing. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2009Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 mar 2006
    Acquisito il 24 apr 2009
    Consegnato il 02 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Lingfield leisure health club, ruxley lane, ewell, surrey.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2009Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental deed to a debenture dated 6 may 2005
    Creato il 17 feb 2006
    Consegnato il 28 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all land shares investments plant and machinery book debts non trading debts accounts held with finance parties intellectual property rights goodwill uncalled capital authorisations and assigned agreements by way of floating charge all present and future business undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 28 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental deed supplemental to a debenture dated 6 may 2005 and a security accession deed date 14 july 2005 and
    Creato il 04 ott 2005
    Consegnato il 12 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 12 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed pursuant to a debenture dated 6 may 2005
    Creato il 14 lug 2005
    Consegnato il 22 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The properties at bayswater t/n NGL823877, birmingham t/n WM774269, brighton t/n ESX268707, for details of further properties charged, please refer to form 395 and fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 22 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 29 mag 2003
    Consegnato il 06 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £226,787.03 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The items listed together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation (or any amendments to them) belonging. D355 glidex xt basc.ing PRO600 x 6 serial nos 02002665, 02002690, 02002697, 02002698, 02002703, 02002706. D320 bike xt ing PRO600 x 8 serial nos 02003446, 02003454, 02003734, 02003736, 02003754, 02003755, 02004118, 02004123. for further details of chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 30 ago 2002
    Consegnato il 05 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Allington street victoria london SW1E 5ED (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Secured Parties (Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LA LEISURE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 mar 2014Data della riunione per approvare il CVA
    17 mar 2017Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew David Smith
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Kahn
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0