LA LEISURE LIMITED
Panoramica
Nome della società | LA LEISURE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01728962 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LA LEISURE LIMITED?
- Creazione artistica (90030) / Attività artistiche, sportive e di divertimento
- Gestione di impianti sportivi (93110) / Attività artistiche, sportive e di divertimento
- Altre attività di divertimento e di svago n.c.a. (93290) / Attività artistiche, sportive e di divertimento
Dove si trova LA LEISURE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Pure Gym Limited Town Centre House LS2 8LY Leeds United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LA LEISURE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
L.A. FITNESS LIMITED | 28 mag 1999 | 28 mag 1999 |
C.S. LEISURE LIMITED | 10 gen 1989 | 10 gen 1989 |
BRENTLYN LIMITED | 03 giu 1983 | 03 giu 1983 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LA LEISURE LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per LA LEISURE LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 01 giu 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 15 giu 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 01 giu 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per LA LEISURE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Nomina di Mr Clive Alexander Sloan Chesser come amministratore in data 31 dic 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mrs Rebecca Elizabeth Passmore come amministratore in data 31 dic 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Humphrey Michael Cobbold come amministratore in data 31 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 20 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 21 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 22 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alexander Basil John Wood il 31 mag 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 21 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 24 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Humphrey Michael Cobbold il 01 nov 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 19 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Alexander Basil John Wood come amministratore in data 10 ott 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Adam John Gordon Bellamy come amministratore in data 10 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Adam John Gordon Bellamy come segretario in data 10 ott 2018 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 22 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Peter William Denby Roberts come amministratore in data 30 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Jacques De Bruin come amministratore in data 30 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Seconda presentazione per la nomina di Jacques De Bruin come amministratore | 6 pagine | RP04AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di LA LEISURE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHESSER, Clive Alexander Sloan | Amministratore | Town Centre House LS2 8LY Leeds C/O Pure Gym Limited United Kingdom | England | British | Chief Executive Officer | 329718250001 | ||||
PASSMORE, Rebecca Elizabeth | Amministratore | Town Centre House LS2 8LY Leeds C/O Pure Gym Limited United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 330745170001 | ||||
WOOD, Alexander Basil John | Amministratore | Town Centre House LS2 8LY Leeds C/O Pure Gym Limited United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 251374440001 | ||||
BELLAMY, Adam John Gordon | Segretario | Town Centre House LS2 8LY Leeds C/O Pure Gym Limited United Kingdom | 198434650001 | |||||||
GOSLING, Steven Paul | Segretario | 5 Little Heath Lane Dunham Massey WA14 4TS Altrincham Cheshire | British | Chief Financial Occifer | 124301460001 | |||||
STORR, Christopher James | Segretario | The Grange Hollingdon DE6 3GB Ashbourne Derbyshire | British | 114849640001 | ||||||
TAYLOR, Graham | Segretario | 14 Roupell Street SE1 8SP London | British | 82374420004 | ||||||
TURNER, David | Segretario | 1 Village Close Belsize Lane Hampstead NW3 5AH London | British | 5194700001 | ||||||
WENBOURNE, Stewart James | Segretario | 56 Bladindon Drive DA5 3BN Bexley Kent | British | 49164890001 | ||||||
BELLAMY, Adam John Gordon | Amministratore | Town Centre House LS2 8LY Leeds C/O Pure Gym Limited United Kingdom | England | British | Director | 172693720002 | ||||
BRODY, Rodney David | Amministratore | Brook House High Road IG7 6PX Chigwell Essex | British | Managing Director | 5194680001 | |||||
BROSTER, Stuart Paul | Amministratore | Greystones Bromley Road Cockleford Heath Ardleigh CO7 7SE Colchester Essex | United Kingdom | British | Director | 114847350001 | ||||
BRUIN, Jacques De | Amministratore | Town Centre House LS2 8LY Leeds C/O Pure Gym Limited United Kingdom | United Kingdom | South African | Director | 198346420001 | ||||
CHESTER, Ross Steven | Amministratore | C/O La Fitness Limited Sandall Stones Road Kirk Sandall DN3 1QR Doncaster South Yorkshire | British | Director | 137527310001 | |||||
COBBOLD, Humphrey Michael | Amministratore | Town Centre House LS2 8LY Leeds C/O Pure Gym Limited United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 100141010002 | ||||
GOSLING, Steven Paul | Amministratore | 5 Little Heath Lane Dunham Massey WA14 4TS Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | Chief Financial Occifer | 124301460001 | ||||
HUGO, Schalk James Burger | Amministratore | 48 Queens Road SL4 3BH Windsor Berkshire | British | Sales Director | 109942000002 | |||||
LONG, Martin | Amministratore | C/O La Fitness Limited Sandall Stones Road Kirk Sandall DN3 1QR Doncaster South Yorkshire | England | British | Director | 125885350001 | ||||
MCCOLL, Arthur | Amministratore | C/O La Fitness Limited Sandall Stones Road Kirk Sandall DN3 1QR Doncaster South Yorkshire | Australia | British | Director | 139099550001 | ||||
ROBERTS, Peter William Denby | Amministratore | Hutts Lane, Grewelthorpe HG4 3DA Ripon The Hutts United Kingdom | England | British | Director | 106538510001 | ||||
STORR, Christopher James | Amministratore | The Grange Hollingdon DE6 3GB Ashbourne Derbyshire | United Kingdom | British | Director | 114849640001 | ||||
TAYLOR, Jeremy Guy | Amministratore | 59 Sandlands Road KT20 7XB Walton On The Hill Surrey | British | Director | 117619380001 | |||||
TAYLOR, Richard | Amministratore | 33 Green Lane HA8 7PS Edgware Middlesex | British | Finance Director | 71126560002 | |||||
TURNER, David | Amministratore | 1 Village Close Belsize Lane Hampstead NW3 5AH London | United Kingdom | British | Director | 5194700001 | ||||
TUROK, Frederick Oliver | Amministratore | 1 Broome Hall RH5 6HJ Cold Harbour Surrey | England | South African | Director | 41174400002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LA LEISURE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L A Fitness Limited | 06 apr 2016 | Town Centre House Merrion Centre LS2 8LY Leeds C/O Pure Gym Limited United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
LA LEISURE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 26 giu 2015 Consegnato il 06 lug 2015 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 26 giu 2014 Consegnato il 02 lug 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All the property of the company whatsoever and wheresover both present and future, including:. 1. all the lands and premises comprised in an indenture of sub-lease dated 25 september 2002 made between la fitness limited (formerly called la fitness PLC) and la leisure limited being lands and premises at 22 adelaide street, belfast, co. Antrim; and. 2. all the lands and premises comprised in folios DN102644L co. Down being the lands and premises comprised in an indenture of lease dated 7 november 2002 made between la fitness PLC and la leisure limited, comprising a hotel fitness centre at shaws bridge belfast; and. 3. all the lands and premises comprised in folio AR96420L co armagh being the lands and premises comprised in an indenture of lease dated 19 september 2003 made between armagh city hotel limited la leisure limited and la fitness PLC being lands and premises at armagh city hotel, friary road, armagh, co. Armagh. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 13 giu 2014 Consegnato il 19 giu 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All and whole 275-309 argyle street, glasgow t/no GLA171048. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 13 giu 2014 Consegnato il 19 giu 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All and whole 110-112 main street, milngavie t/no DMB71821. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 05 giu 2014 Consegnato il 10 giu 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 15 mag 2014 Consegnato il 16 mag 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Leasehold land known as the ground and basement floor 48 leadenhall street london. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 30 dic 2013 Consegnato il 31 dic 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione L/H land k/a part sub-basement part basement and ground floor retail unit b the st botolph building 138-139 houndswitch london. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A supplemental security and confirmation deed | Creato il 30 ago 2011 Consegnato il 13 set 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties and all monies due or to become due from the chargors to all or any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Its relevant assets as more specifically referred to in the relevant security documents upon the terms contained in the relevant security documents. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 01 dic 2010 Consegnato il 03 dic 2010 | In corso | Importo garantito £5,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari £5,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental mortgage | Creato il 07 dic 2009 Consegnato il 11 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari L/H land at the rear of gravelly lane, erdington, sutton coldfield see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental legal mortgage to a debenture dated 6 may 2005 | Creato il 07 lug 2009 Consegnato il 15 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H land at the rear of gravelly lane erdington sutton coldfield see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental legal mortgage | Creato il 21 mag 2009 Consegnato il 22 mag 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Units 6-8 and units 12-16 the royal oak shopping centre brighton road purley surrey t/no SGL606941. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A supplemental legal mortgage | Creato il 28 apr 2009 Consegnato il 12 mag 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Under clause 2 of the supplemental legal mortgage by way of legal mortgage its interest in brooklands cricket & lawn tennis club whitehall road sale t/no. GM817392, west cheshire squash club wrexham road chester t/no. CH419565; the security was created as a continuing security to secure the payment and discharge of the secured liabilities see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A supplemental legal mortgage | Creato il 28 apr 2009 Consegnato il 12 mag 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Under clause 2 of the supplemental legal mortgage by way of legal mortgage its interest in the sub-underlease of the premises in the basement and lower ground floor of 20 little britain london; the security was created as a continuing security to secure the payment and discharge of the secured liabilities see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental debenture | Creato il 21 giu 2006 Acquisito il 24 apr 2009 Consegnato il 02 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H land k/a 81-83 kimbolton road bedford t/no's BD19226 and BD22062. L/h land k/a dragons health club, chindits lane, warley, brentwood, essex t/no EX590850. L/h land k/a land and buildings on the south east side of liversage road, derby t/no DY136843.for details of further property charged please refer to form 395, see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental debenture | Creato il 21 giu 2006 Acquisito il 24 apr 2009 Consegnato il 02 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The whole of the l/h land k/a dragons health club, webb ellis road, rugby t/no WK293062 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental debenture | Creato il 21 giu 2006 Acquisito il 24 apr 2009 Consegnato il 02 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari L/H lane known as burnham squash club 821A yeovil road trading estate slough t/no BK315801 and l/h land known as northwood squash centre chestnut avenue northwood middlesex t/no AGL37538. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental debenture | Creato il 21 giu 2006 Acquisito il 24 apr 2009 Consegnato il 02 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari L/H land known as maidstone tennis and fitness centre st peter street maidstone t/no K817534. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 23 mar 2006 Acquisito il 06 mag 2009 Consegnato il 02 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land and buildings on the south side of rodwell road/western avenue, northolt, ealing. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 23 mar 2006 Acquisito il 24 apr 2009 Consegnato il 02 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Lingfield leisure health club, ruxley lane, ewell, surrey. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A supplemental deed to a debenture dated 6 may 2005 | Creato il 17 feb 2006 Consegnato il 28 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of fixed charge all land shares investments plant and machinery book debts non trading debts accounts held with finance parties intellectual property rights goodwill uncalled capital authorisations and assigned agreements by way of floating charge all present and future business undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental deed supplemental to a debenture dated 6 may 2005 and a security accession deed date 14 july 2005 and | Creato il 04 ott 2005 Consegnato il 12 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security accession deed pursuant to a debenture dated 6 may 2005 | Creato il 14 lug 2005 Consegnato il 22 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The properties at bayswater t/n NGL823877, birmingham t/n WM774269, brighton t/n ESX268707, for details of further properties charged, please refer to form 395 and fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 29 mag 2003 Consegnato il 06 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £226,787.03 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The items listed together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation (or any amendments to them) belonging. D355 glidex xt basc.ing PRO600 x 6 serial nos 02002665, 02002690, 02002697, 02002698, 02002703, 02002706. D320 bike xt ing PRO600 x 8 serial nos 02003446, 02003454, 02003734, 02003736, 02003754, 02003755, 02004118, 02004123. for further details of chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating security document | Creato il 30 ago 2002 Consegnato il 05 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Allington street victoria london SW1E 5ED (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
LA LEISURE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0