FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED

FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01730291
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Stretton Green Distribution Centre
    Langford Way
    WA4 4TQ Warrington
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ASSEMBLY & AUTOMATION (ELECTRONICS) LIMITED15 lug 198315 lug 1983
    DIPLEMA THIRTY TWO LIMITED08 giu 198308 giu 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2012

    6 pagineAA

    Nomina di Miss Stephanie Anne Shaw come amministratore in data 10 dic 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Fergus Mckay come amministratore in data 10 dic 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Miss Stephanie Anne Shaw come segretario in data 01 giu 2011

    1 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 08 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 dic 2011

    Stato del capitale al 08 dic 2011

    • Capitale: GBP 186,588
    SH01

    Cessazione della carica di Eversecretary Limited come segretario in data 01 giu 2011

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES Uk in data 24 nov 2011

    2 pagineAD01

    Bilancio per una società di medie dimensioni redatto al 31 mar 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio per una società di medie dimensioni redatto al 31 mar 2010

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2009

    15 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2008

    14 pagineAA

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2007

    14 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHAW, Stephanie Anne
    Langford Way
    WA4 4TQ Warrington
    Stretton Green Distribution Centre
    Cheshire
    Segretario
    Langford Way
    WA4 4TQ Warrington
    Stretton Green Distribution Centre
    Cheshire
    165163250001
    FOSKIN, Richard
    Rocklands Union Road
    IRISH Kilmacthomas
    Waterford
    Ireland
    Amministratore
    Rocklands Union Road
    IRISH Kilmacthomas
    Waterford
    Ireland
    IrelandIrish74069810001
    JOHNSON, Edmund
    83 Wyckham Place
    Wyckham Way
    IRISH Dundrum
    Dublin 16
    Ireland
    Amministratore
    83 Wyckham Place
    Wyckham Way
    IRISH Dundrum
    Dublin 16
    Ireland
    IrelandIrish126453140001
    MCCAFFERTY, Robert Michael
    Keylwerthgasse 10
    FOREIGN Vienna
    A 1190
    Austria
    Amministratore
    Keylwerthgasse 10
    FOREIGN Vienna
    A 1190
    Austria
    AustriaAmerican157079160001
    SHAW, Stephanie Anne
    Langford Way
    WA4 4TQ Warrington
    Stretton Green Distribution Centre
    Cheshire
    Amministratore
    Langford Way
    WA4 4TQ Warrington
    Stretton Green Distribution Centre
    Cheshire
    EnglandBritish174253770001
    BEATTS, Keith Pickwell
    34 Barnhill Drive
    Earnock
    ML3 9EZ Hamilton
    Lanarkshire
    Segretario
    34 Barnhill Drive
    Earnock
    ML3 9EZ Hamilton
    Lanarkshire
    British52854190001
    HODSDEN, Richard
    47 Orchard Grove
    SL9 9ET Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Segretario
    47 Orchard Grove
    SL9 9ET Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British98672820001
    JONES, Keith Wilson
    65 Heol Llanishen Fach
    Rhiwbina
    CF14 6LB Cardiff
    Segretario
    65 Heol Llanishen Fach
    Rhiwbina
    CF14 6LB Cardiff
    British88435330001
    MAY, Geoffrey Charles
    24 Cambourne Avenue
    Whitchurch
    CF4 2AQ Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario
    24 Cambourne Avenue
    Whitchurch
    CF4 2AQ Cardiff
    South Glamorgan
    British10975750001
    READ, Paul
    8 Gelli Fawr Court
    Henllys
    NP44 6ET Cwmbran
    Gwent
    Segretario
    8 Gelli Fawr Court
    Henllys
    NP44 6ET Cwmbran
    Gwent
    British43486210001
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Segretario
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    76729800001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Segretario
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    EVERSECRETARY LIMITED
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Eversheds House
    Segretario
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Eversheds House
    60471940015
    ARNOLD, William Keith
    Wayside House
    Wayloeds Lane
    NP6 6RW Shirenewton
    Gwent
    Amministratore
    Wayside House
    Wayloeds Lane
    NP6 6RW Shirenewton
    Gwent
    British10975760003
    ARNOLD, William Keith
    Wayside House
    Wayloeds Lane
    NP6 6RW Shirenewton
    Gwent
    Amministratore
    Wayside House
    Wayloeds Lane
    NP6 6RW Shirenewton
    Gwent
    British10975760003
    BEATTS, Keith Pickwell
    34 Barnhill Drive
    Earnock
    ML3 9EZ Hamilton
    Lanarkshire
    Amministratore
    34 Barnhill Drive
    Earnock
    ML3 9EZ Hamilton
    Lanarkshire
    British52854190001
    CLEMENTS, Harry Anthony Frank
    20 Millwood
    Lisvane
    CF4 5TL Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    20 Millwood
    Lisvane
    CF4 5TL Cardiff
    South Glamorgan
    British22344480001
    EARLE, Michael Francis Henry
    14 Ash Tree Close
    Radyr
    CF4 8RX Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    14 Ash Tree Close
    Radyr
    CF4 8RX Cardiff
    South Glamorgan
    British58111210001
    EDGE, Christopher
    46 Howards Lane
    Putney
    SW15 6NJ London
    Amministratore
    46 Howards Lane
    Putney
    SW15 6NJ London
    British11465390001
    FARHA, Alfred Sam
    Field Cottage Fritwell Road
    OX27 7NZ Fewcott
    Oxfordshire
    Amministratore
    Field Cottage Fritwell Road
    OX27 7NZ Fewcott
    Oxfordshire
    British113890220001
    HARTY, Bernard Peter
    Lyle House
    2a Eastbury Avenue
    HA6 3LG Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Lyle House
    2a Eastbury Avenue
    HA6 3LG Northwood
    Middlesex
    British36907310002
    HOPKINS, Gary
    11 Forest Hills Drive
    Talbot Green
    CF7 8JB Pontyclun
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    11 Forest Hills Drive
    Talbot Green
    CF7 8JB Pontyclun
    Mid Glamorgan
    British63534990001
    JONES, Keith Wilson
    65 Heol Llanishen Fach
    Rhiwbina
    CF14 6LB Cardiff
    Amministratore
    65 Heol Llanishen Fach
    Rhiwbina
    CF14 6LB Cardiff
    WalesBritish88435330001
    KING, John William
    23 Holmbury Park
    Sunridge Avenue
    BR1 2QS Bromley
    Kent
    Amministratore
    23 Holmbury Park
    Sunridge Avenue
    BR1 2QS Bromley
    Kent
    EnglandBritish596100001
    MAY, Geoffrey Charles
    24 Cambourne Avenue
    Whitchurch
    CF4 2AQ Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    24 Cambourne Avenue
    Whitchurch
    CF4 2AQ Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish10975750001
    MCKAY, Fergus
    58 Cloch Road
    PA19 1AU Gourock
    Renfrewshire
    Amministratore
    58 Cloch Road
    PA19 1AU Gourock
    Renfrewshire
    United KingdomBritish117134180001
    MCKAY, Fergus Andrew
    2 Magpie Crescent
    Inverkip
    PA16 0LW Greenock
    Renfrewshire
    Amministratore
    2 Magpie Crescent
    Inverkip
    PA16 0LW Greenock
    Renfrewshire
    British62269770001
    NILSON, Ronny Stig Kjell
    Vastra Sjogatan 4
    Kalmar
    39232 Kalmar
    Sweden
    Amministratore
    Vastra Sjogatan 4
    Kalmar
    39232 Kalmar
    Sweden
    Swedish56534930001
    NILSSON, Hans Daniel
    30 East Sheen Avenue
    East Sheen
    SW14 8AS London
    Amministratore
    30 East Sheen Avenue
    East Sheen
    SW14 8AS London
    EnglandSwedish55982340002
    PORTER, Humphrey
    Makartstrasse 7
    A2102 Haenbrunn
    Austria
    Amministratore
    Makartstrasse 7
    A2102 Haenbrunn
    Austria
    British63137020001
    READ, Paul
    8 Gelli Fawr Court
    Henllys
    NP44 6ET Cwmbran
    Gwent
    Amministratore
    8 Gelli Fawr Court
    Henllys
    NP44 6ET Cwmbran
    Gwent
    British43486210001
    ROWAN, James
    17 Powmill Road
    KA9 2NX Prestwick
    Ayrshire
    Amministratore
    17 Powmill Road
    KA9 2NX Prestwick
    Ayrshire
    British55159480002
    RYAN, Matthew
    Kingfisher House
    Aberthin Road
    CF7 7EJ Cowbridge
    South Glamorgan
    Amministratore
    Kingfisher House
    Aberthin Road
    CF7 7EJ Cowbridge
    South Glamorgan
    Irish50392750001
    THOMAS, Meirion Lewis
    34 Robert Street
    Glynneath
    SA11 5EG Neath
    West Glamorgan
    Amministratore
    34 Robert Street
    Glynneath
    SA11 5EG Neath
    West Glamorgan
    British50392590001
    TOYE, Daniel
    18 Myvot Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4ND Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    18 Myvot Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4ND Glasgow
    Lanarkshire
    British104183320001

    FLEXTRONICS INTERNATIONAL (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 11 ago 1998
    Consegnato il 22 ago 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date of 8 grove park business estate white waltham county of berkshire between the company and the chargee
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the deposit of £7,750 and all related rights thereto and thereof.
    Persone aventi diritto
    • Michael Shanly Investments Limited
    Transazioni
    • 22 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 27 mar 1997
    Consegnato il 14 apr 1997
    In corso
    Importo garantito
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of any loan document the credit agreements (as defined) and this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston as Agent and Trustee for the Bank Agents and the Banks (As Defined)
    Transazioni
    • 14 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 06 mar 1997
    Consegnato il 18 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 05 feb 1997
    Consegnato il 13 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over the deposit(s) being all sums of money in any currency deposited with the bank or held by the bank pursuant to the deposit being... Flextronics international (UK) LTD us dollar deposit account no 42684555, dollar current account no 42684588 and money market deposit bid no 83615844. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge,
    Creato il 06 set 1994
    Consegnato il 20 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at dinas isaf, taff ely, mid glamorgan,.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC,
    Transazioni
    • 20 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 06 set 1994
    Consegnato il 20 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title and interest in and under the account held with barclays bank PLC reference ;assembly & automation (electronics) limited higher interest business account number 90506168, together with all interest accrued or accruing thereon, please see doc for further details,.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC,
    Transazioni
    • 20 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage,
    Creato il 06 set 1994
    Consegnato il 20 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    P.C.B. assembly machinery comprising ;2/2004 a"gen-rad" model 2271 circuit board test system, no 9953 with monitor ,keyboard, "oki" data microline printer, 1/111-1 a"gen-rad" model 2276E board test work station, no 9877 with monitor ,polar toneohm 550 ohmmeter "digital"TK550 tape streamer,"okidata" microline 192 plus printer, 1/1136/1 a " universal " model 6348 radial printed circuit board inserter, no 10793-8-41953101 , 18IN x 18IN board size ,,40 station automatic COMP0NENT feed with "hewlett packard"vecrta 5 personal computer ,monitor and keyboard, "hewlett packard " quiet jet printer. Please see doc for further details,.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC.
    Transazioni
    • 20 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge .
    Creato il 06 set 1994
    Consegnato il 20 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to barclays bank PLC, supplemental to the terms of a guarantee and debenture dated 8TH april 1991 .
    Brevi particolari
    Fixed charge over right title and interest of the company in or arising out of a factoring or invoice discounting deed dated 6TH september 1994 ,between kellock limited and the company and any deeds amending or replacing the same. Please see doc for further details,.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC,
    Transazioni
    • 20 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Kellock Limited
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 06 set 1994
    Consegnato il 12 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal amount of the stock and all monies due or to become due from the company to the chargee under the deed
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co (Guernsey) Limited
    Transazioni
    • 12 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 08 apr 1991
    Consegnato il 17 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 01 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 gen 1990
    Consegnato il 13 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at dunas isaf edmondstown mid glamorgan t/no (part) wa 165032 (part) wa 384774.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0