HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED

HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01731768
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    • Centri di fitness (93130) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPENCER MOTOR GROUP LIMITED12 gen 199012 gen 1990
    SPENCER OF BRIGG LIMITED14 giu 198314 giu 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE England

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da * Active House 21 North Fourth Street Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1HL* in data 09 ott 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 19 set 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 29 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Nomina di Mr Paul Antony Woolf come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Norman Field come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Matthew Graham Merrick come amministratore

    4 pagineAP01
    Note
    DataNota
    29 set 2011This document is a duplicate of the AP01 registered on 12/09/2011

    Nomina di James Archibald come segretario

    4 pagineAP03
    Note
    DataNota
    29 set 2011This document is a duplicate of the AP03 registered on 12/09/2011

    Nomina di James Archibald come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Matthew Graham Merrick come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARCHIBALD, James
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Segretario
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    British162965050001
    BUCKNALL, Matthew William
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Amministratore
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishCompany Director162066820001
    MERRICK, Matthew Graham
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Amministratore
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishUk Finance Director162110530001
    WOOLF, Paul Antony
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Amministratore
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritishDirector160679880001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Segretario
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    British58961410002
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Segretario
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    BritishDirector58345490001
    LONG, Jean
    19 Cliff Closes Road
    DN15 7HT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Segretario
    19 Cliff Closes Road
    DN15 7HT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    British11609680001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    Segretario
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    BritishChartered Secretary123616460002
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director Esporta Group58961410002
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Amministratore
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritishExecutive Director, Esporta Gr96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector146698270001
    DHODY, Jog
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer, Esporta Gr104269910002
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Amministratore
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    EnglandBritishDirector58345490001
    FIELD, Norman Mark
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomSouth AfricanManaging Director161860310001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Amministratore
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritishChief Executive Esporta Group69204500003
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Amministratore
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    BritishDivisional Director Esporta Gr100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director30306840002
    LEATHERBARROW, David Jon
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector135618280002
    MCCOLLUM, Kevin Boyd
    Waterton Stables
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Waterton Stables
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector121972580001
    MCGUIGAN, Marc Edward
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    Amministratore
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    EnglandBritishOperations Director Esporta Gr93677590002
    MOORE, Trevor Philip
    Malmsmead
    Bayleys Hill
    TN14 6HS Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Malmsmead
    Bayleys Hill
    TN14 6HS Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishManaging Director, Operations113047410001
    SEGAL, Richard Lawrence
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector138744060001
    SPENCER, Elizabeth Laura
    Humberston Country Club
    Humberston Avenue Humberston
    DN36 4SJ Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Humberston Country Club
    Humberston Avenue Humberston
    DN36 4SJ Grimsby
    North East Lincolnshire
    BritishHousewife19057710002
    SPENCER, Jonathan Graham
    Humberston Country Club
    Humberston Avenue Humberston
    DN36 4SJ Grimsby
    North Eastlincolnshire
    Amministratore
    Humberston Country Club
    Humberston Avenue Humberston
    DN36 4SJ Grimsby
    North Eastlincolnshire
    BritishSales Manager20593340002
    TIMMS, Glenn Gordon
    8 Haywards Close
    RG9 1UY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    8 Haywards Close
    RG9 1UY Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishChief Executive, Esporta Group54133140004
    WEATHERLEY, Kenneth Frank
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    BritishDirector50477690001

    HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 18 giu 2009
    Consegnato il 26 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 26 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Group debenture
    Creato il 08 feb 2006
    Consegnato il 18 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transazioni
    • 18 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 gen 2004
    Consegnato il 07 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Electra Partners Europe Limited as Noteholders' Agent and Noteholders' Security Trustee Andnoteholders Security Trust (The "Noteholders' Security Trustee")
    Transazioni
    • 07 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 gen 2004
    Consegnato il 03 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 28 nov 2003
    Consegnato il 12 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property being humberston country club, humberston avenue, humberston, grimsby all property, present and future book debts, all equipment, present and future licences, insurances, indebtedness owed by esporta h & f fropco (1B) limited to the company.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 set 2002
    Consegnato il 09 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the issuer and by each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all properties now owned by or vested in each charging company including t/n HS280597 land and buildings lying to the north of humberston avenue, humberston. T/n HS226008 humberston country club, humberston avenue, grimsby and t/n HS226007 humberston country club, humberston avenue, grimsby. By way of first fixed mortgage the securities, first fixed charge all properties thereafter acquired, all present and future interests in or over freehold or leasehold property; all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to the properties.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Electra Partners Europe Limited (As Noteholders' Agent and Noteholders' Security Agent for Thenote Finance Parties)
    Transazioni
    • 09 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ott 1999
    Consegnato il 23 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the mezzanine financing documents (including the guarantee dated 15TH october 1999 and the debenture)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Electra Managers Limited(The "Mezzanine Security Agent")
    Transazioni
    • 23 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ott 1999
    Consegnato il 28 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and security trustee for the finance parties (as therein defined)) on any account whatsoever, under or in connection with the financing documents (including, without limitation, the guarantee and debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 28 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 mar 1999
    Consegnato il 24 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kingsway Nominees Limitedas Trustee on Behalf of Electra Fleming Privateequity Partners (The Lender)
    Transazioni
    • 24 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 mar 1999
    Consegnato il 23 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of humberston avenue grimsby t/no;-HS226007 and HS226008 and land at the rear of 191 humberston avenue t/no;-HS228117 (part). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 23 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 apr 1994
    Consegnato il 06 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north side of humberston avenue grimsby humberside t/n HS226OO7.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 dic 1990
    Consegnato il 04 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings in winterton road scunthorpe humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 feb 1989
    Consegnato il 27 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings to the north of brumby wood lane scunthorpe humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 feb 1989
    Consegnato il 27 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Garage premises situate and k/a 5 brumby wood lane, scunthorpe humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 07 set 1987
    Consegnato il 08 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a consignment agreement d/d 7/9/87
    Brevi particolari
    All the chargor's interest in any vehicle delivered to it under the terms of the said consignment agreement.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 08 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 17 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1987
    Consegnato il 13 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    106 scotter road scunthorpe county of humberside title no: ll 4401.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 17 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 06 mag 1987
    Consegnato il 08 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All new and unused passenger cars and light commercial vehicles (please see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 08 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 17 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 mag 1984
    Consegnato il 24 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 18 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HUMBERSTON COUNTRY CLUB LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 set 2013Inizio della liquidazione
    20 nov 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Praticante
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0