LENSTEC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLENSTEC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01734416
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LENSTEC LIMITED?

    • fabbricazione di prodotti refrattari (23200) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova LENSTEC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LENSTEC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per LENSTEC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di James Michael Smith come amministratore in data 07 ott 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Heights Legal the Courtyard Parc Busnes Edwards Llantrisant Mid Glamorgan CF72 8QZ United Kingdom a Suite 5 Block D the Octagon Caerphilly Business Park Caerphilly CF83 3ED

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Unit 8 Bedwas Business Centre Bedwas Caerphilly CF83 8DU

    1 pagineAD04

    Cessazione della carica di Gerard Joseph Donovan come segretario in data 29 ott 2021

    1 pagineTM02

    Notifica di Lenstec Optical Group Limited come persona con controllo significativo il 29 ott 2021

    2 paginePSC02

    Cessazione di Nigel Castle come persona con controllo significativo il 29 ott 2021

    1 paginePSC07

    Cessazione di Shamir Uk Limited come persona con controllo significativo il 29 ott 2021

    1 paginePSC07

    Nomina di Mr James Michael Smith come amministratore in data 29 ott 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Precious come amministratore in data 29 ott 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gerard Joseph Donovan come amministratore in data 29 ott 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel Castle come amministratore in data 29 ott 2021

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    7 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Heights Legal Limited 2 Elms Park Miskin Pontyclun Mid Glamorgan CF72 8PU United Kingdom a C/O Heights Legal the Courtyard Parc Busnes Edwards Llantrisant Mid Glamorgan CF72 8QZ

    1 pagineAD02

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 dic 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Chi sono gli amministratori di LENSTEC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRECIOUS, Timothy James
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    Amministratore
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    EnglandBritishDirector289285130001
    ARBUTHNOT, Edward Victor
    6 Broad Street
    CF62 7XP Barry
    South Glamorgan
    Segretario
    6 Broad Street
    CF62 7XP Barry
    South Glamorgan
    British25653170001
    DONOVAN, Gerard Joseph
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    Segretario
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    British154195160001
    HARRIS, John Henry
    93 Cardiff Road
    CF83 1WS Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Segretario
    93 Cardiff Road
    CF83 1WS Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British25653160002
    ARBUTHNOT, Edward Victor
    6 Broad Street
    CF62 7XP Barry
    South Glamorgan
    Amministratore
    6 Broad Street
    CF62 7XP Barry
    South Glamorgan
    United KingdomBritishOptician25653170001
    BURROUGHS, Martin Glen
    Vole House
    Brook Street North Newton
    TA7 0BL Bridgwater
    Somerset
    Amministratore
    Vole House
    Brook Street North Newton
    TA7 0BL Bridgwater
    Somerset
    United KingdomBritishCompany Director97285670001
    CARRIGAN, David Arthur
    29 Graigview
    Machen
    NP1 8SD Newport
    Gwent
    Amministratore
    29 Graigview
    Machen
    NP1 8SD Newport
    Gwent
    BritishOptical Manufacturer37937080001
    CASTLE, Nigel
    13 Tyn-Y-Coedcae Waterloo
    NP1 8NJ Rudry
    Gwent
    Amministratore
    13 Tyn-Y-Coedcae Waterloo
    NP1 8NJ Rudry
    Gwent
    WalesBritishDirector25653200002
    DONOVAN, Gerard Joseph
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    Amministratore
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    United KingdomBritishDirector53872380002
    HAILES, John Warren
    Bronllys
    Portland Place Lisvane
    Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Bronllys
    Portland Place Lisvane
    Cardiff
    South Glamorgan
    BritishOptician25653190001
    HARRIS, John Henry
    93 Cardiff Road
    CF83 1WS Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    93 Cardiff Road
    CF83 1WS Caerphilly
    Mid Glamorgan
    BritishOptician25653160002
    MURPHY, Peter Alton
    Rhosgoch Farm
    LL66 0AB Rhosgoch
    Anglesey
    Amministratore
    Rhosgoch Farm
    LL66 0AB Rhosgoch
    Anglesey
    WalesWelshDirector7312760001
    PALMER, Stanley Victor
    50 Norwood
    Thornhill
    CF4 9DE Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    50 Norwood
    Thornhill
    CF4 9DE Cardiff
    South Glamorgan
    BritishManufacturing Optician25653180001
    SMITH, James Michael
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    Amministratore
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    EnglandBritishFinance Director151557480001
    WALDEN, Paul
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    Amministratore
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    EnglandBritishTechnical And Sales Director105812630003

    Chi sono le persone con controllo significativo di LENSTEC LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Lenstec Optical Group Limited
    Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    Unit 8
    Wales
    29 ott 2021
    Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    Unit 8
    Wales
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies For England And Wales
    Numero di registrazione08225487
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Shamir Uk Limited
    Bar Hill
    PO BOX 76
    CB23 8SH Cambridge
    Bridge House
    England
    06 apr 2016
    Bar Hill
    PO BOX 76
    CB23 8SH Cambridge
    Bridge House
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione02317763
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Nigel Castle
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    06 apr 2016
    Unit 8 Bedwas Business Centre
    Bedwas
    CF83 8DU Caerphilly
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Wales
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    LENSTEC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 mag 2013
    Consegnato il 20 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Edward Victor Arbuthnot
    Transazioni
    • 20 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 07 mar 2011
    Consegnato il 18 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 11 bedwas industrial estate bedwas by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 18 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 07 mar 2011
    Consegnato il 18 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 8 bedwas industrial estate bedwas by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 18 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 nov 2008
    Consegnato il 11 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Finance Wales Investments Limited
    Transazioni
    • 11 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 18 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 1 bedwas industrial estate bedwas caerphilly. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 08 apr 2004
    Consegnato il 10 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 10 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 01 set 2000
    Consegnato il 13 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a unit 8 bedwas business centre caerphilly t/n WA796271 & WA617345. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 set 2000
    Consegnato il 02 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 27 lug 1995
    Consegnato il 04 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Former concept recycling premises,bedwas industrial estate,bedwas,mid-glamorgan together with the assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hodge Bank Limited
    Transazioni
    • 04 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 ott 1992
    Consegnato il 05 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0