SHORELINE CARS LIMITED

SHORELINE CARS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHORELINE CARS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01738745
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHORELINE CARS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SHORELINE CARS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    770 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SHORELINE CARS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RIMMERGROVE LIMITED12 lug 198312 lug 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHORELINE CARS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per SHORELINE CARS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 30 lug 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    legacy

    49 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Matthew Bishop come amministratore in data 01 gen 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David John Muir come amministratore in data 01 gen 2019

    2 pagineAP01

    legacy

    44 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    3 pagineAGREEMENT1

    legacy

    49 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    51 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Chi sono gli amministratori di SHORELINE CARS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FINCH, Mark
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    175767070001
    FINCH, Mark Charles
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish175612870001
    MUIR, David John
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish254017640001
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    149319790001
    WARD, Andrew Ian
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    Segretario
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    British360770001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Segretario
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Uk74385360001
    MATHESON & CO LIMITED
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Segretario
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    1947590001
    ATKIN, John Richard
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    British20102900001
    BEATTIE, Craig Alan
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish177627900001
    BEYNON, Peter
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish38504390006
    BISHOP, Matthew
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish206755450002
    CHAMBERS, Paul Jonathan
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    British1188140001
    HERBERT, Mark Philip
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish123285980005
    HOUSTON, Samuel George
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    Amministratore
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    British75730290003
    JONES, Alun Morton
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish12785600004
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish149294820002
    POTTS, Derek
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    Amministratore
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish52485510001
    RITCHIE, John Muir
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    Amministratore
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    British22325820001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Amministratore
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    EnglandUk74385360001
    WILLIAMS, Steven Wyn
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish54580940001
    WILLIAMSON, Michael Granville
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    British57360160001
    WITT, John Raymond
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Canadian51303670001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SHORELINE CARS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione192238
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SHORELINE CARS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 14 ott 1986
    Consegnato il 30 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    117 redcar lane, redcar and stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel & Co LTD
    Transazioni
    • 30 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 10 gen 1985
    Consegnato il 11 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's present and future stock of motor vehicles (for full details see doc M22).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 11 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 25 mag 1984
    Consegnato il 08 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the compan to the chargee
    Brevi particolari
    All those monies which may from time to time be owing to shareline cars LTD by va g (united kingdom) limited (see doc M21 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 08 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 16 mag 1984
    Consegnato il 19 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property situate and being zetland park garage, redcar, cleveland.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transazioni
    • 19 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 01 mag 1984
    Consegnato il 12 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transazioni
    • 12 mag 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0