DORSUB (RSH) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DORSUB (RSH) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01738921 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DORSUB (RSH) LIMITED?
- (7499) /
Dove si trova DORSUB (RSH) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DORSUB (RSH) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| RICHARD SHOPS HOLDINGS LIMITED | 16 set 1983 | 16 set 1983 |
| PRECIS (183) LIMITED | 12 lug 1983 | 12 lug 1983 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DORSUB (RSH) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 29 ago 2009 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DORSUB (RSH) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per DORSUB (RSH) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 11 pagine | 4.72 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 feb 2014 | 16 pagine | 4.68 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 43-45 Portman Square London W1H 6LY in data 22 lug 2013 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 feb 2013 | 14 pagine | 4.68 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 2 pagine | F10.2 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 feb 2012 | 20 pagine | 2.24B | ||||||||||
Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori | 1 pagine | 2.34B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 set 2011 | 16 pagine | 2.24B | ||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B | 13 pagine | 2.16B | ||||||||||
Risultato della riunione dei creditori | 2 pagine | 2.23B | ||||||||||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 32 pagine | 2.17B | ||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B | 7 pagine | 2.16B | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Colegrave House 70 Berners Street London W1T 3NL in data 08 apr 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 1 pagine | 2.12B | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Gillian Hague il 12 gen 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Anthony Healey il 12 gen 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Leeroy Burchill il 07 gen 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed richard shops holdings LIMITED\certificate issued on 25/10/10 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Leeroy Burchill il 14 apr 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 29 ago 2009 | 9 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 6 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DORSUB (RSH) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODIE, Kimberly Donna | Segretario | Falcon Grove SW11 2ST Clapham 26 London United Kingdom | Other | 134585610002 | ||||||
| BURCHILL, Richard Leeroy | Amministratore | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House England | United Kingdom | British | 115568070002 | |||||
| DUCKELS, Colin Peter | Amministratore | 14 Woodlands Park Scarcroft LS14 3JU Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 44237310004 | |||||
| HAGUE, Gillian Anne | Amministratore | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House England | United Kingdom | British | 99223490001 | |||||
| HEALEY, Mark Anthony | Amministratore | 70 Berners Street W1T 3NL London Colegrave House England | England | British | 77432550002 | |||||
| BERGAMIN, Jayabaduri | Segretario | 12 Newry Road TW1 1PL Twickenham Middlesex | British | 116935080001 | ||||||
| CASH, Daphne Valerie | Segretario | 20 Chichester Mews SE27 0NS London | British | 59646330004 | ||||||
| COX, Michelle Hazel | Segretario | 154 Eastwood Road North SS9 4LZ Leigh On Sea Essex | British | 104461530003 | ||||||
| HAIG, Colin | Segretario | 33 South Way CR0 8RH Croydon Surrey | British | 56710270001 | ||||||
| HICKS, Beverley | Segretario | 7 Westminster Court King & Queen Wharf Rotherhithe SE16 5SY London | British | 92357410001 | ||||||
| JACKMAN, Ian Peter | Segretario | Flat 11 Macready House 75 Crawford Street W1H 5LR London | British | 71660800001 | ||||||
| JOHN, Elizabeth Mary | Segretario | Glenview Hillside Road WD3 5AP Chorley Wood Hertfordshire | British | 9203980001 | ||||||
| STEVENSON, Rebecca Jayne | Segretario | 49 Rivulet Road Tottenham N17 7JT London | British | 71917770002 | ||||||
| BROWN, David Nigel | Amministratore | 116 Clarence Road AL1 4NW St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 40354400003 | |||||
| CLARK, John Macaulay Lambie | Amministratore | One Garrick Road NW9 6AU London | British | 47116520001 | ||||||
| COACKLEY, Paul | Amministratore | 1 Garrick Road NW9 6AU London | British | 63400650001 | ||||||
| CROSSLAND, Julie Sook Hein | Amministratore | 9 Rowallan Road SW6 6AF London | England | British | 70464290002 | |||||
| GARTH, David | Amministratore | One Garrick Road Hendon NW9 6AU London | British | 59815470003 | ||||||
| GLANVILLE, Richard Spencer | Amministratore | One Garrick Road NW9 6AU London | British | 69669910003 | ||||||
| GOLDMAN, Adam Alexander | Amministratore | 4 Jenner Way Clarendon Park KT19 7LJ Epsom Surrey | England | British | 28466260004 | |||||
| HAIG, Colin | Amministratore | 33 South Way CR0 8RH Croydon Surrey | British | 56710270001 | ||||||
| JACKMAN, Ian Peter | Amministratore | Flat 11 Macready House 75 Crawford Street W1H 5LR London | British | 71660800001 | ||||||
| JOHN, Elizabeth Mary | Amministratore | Glenview Hillside Road WD3 5AP Chorley Wood Hertfordshire | British | 9203980001 | ||||||
| LOVELOCK, Derek John | Amministratore | Oldfields Farm Amersham Road HP9 2UG Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 116560620001 | |||||
| RENNISON, Gordon | Amministratore | 6 Burnaston Crescent Shirley B90 4LT Solihull West Midlands | British | 59804930001 | ||||||
| SMITH, Nicholas Leigh | Amministratore | 34 Castle Hill Avenue HP4 1HJ Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 45625440002 | |||||
| TUFFY, William Patrick | Amministratore | Flat 2 Goldhurst Terrace West Hampstead NW6 3HU London | British | 35553620001 | ||||||
| ZEITLIN, David | Amministratore | 72 Northumberland Road North Harrow HA2 7RE Harrow Middlesex | British | 9203990001 | ||||||
| SEARS CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Amministratore | 3rd Floor 20 St James Street SW1A 1ES London | 62697590001 |
DORSUB (RSH) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed charge | Creato il 06 gen 1984 Consegnato il 23 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of facility letters 19.12.83 | |
Brevi particolari All debts at anytime due to the company in respect of certain properties pursuant to a deed of indemnity given by hansontrust PLC. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 gen 1984 Consegnato il 23 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 198/204 high street, lewisham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 gen 1984 Consegnato il 23 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 25 a/b/c north brook, newbury, berkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 gen 1984 Consegnato il 23 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 41 high street, birmingham title no. 197272. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 gen 1984 Consegnato il 23 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 60-62 northumberland street, newcastle upon-tyne. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 gen 1984 Consegnato il 23 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 46 high street, warcester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 gen 1984 Consegnato il 23 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 17/19 land street and 62/64 stafford street, hanley. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 gen 1984 Consegnato il 23 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 43/51 church street, liverpool. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 gen 1984 Consegnato il 23 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 22 james street, harogate. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 gen 1984 Consegnato il 23 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 149/151 high street, chatham kent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 gen 1984 Consegnato il 23 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 232 high street, exeter title no. Dn 52475. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 gen 1984 Consegnato il 23 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 29/31 newport street, bolton, lancs. Title no: la 372559. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
DORSUB (RSH) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In amministrazione |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0