IN-TO-SAVE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIN-TO-SAVE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01739084
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IN-TO-SAVE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova IN-TO-SAVE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Novomatic House South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Wales
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di IN-TO-SAVE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per IN-TO-SAVE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Zane Cedomir Mersich il 11 gen 2022

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Astra House Kingsway Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3RY Wales a Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Zane Cedomir Mersich il 22 set 2020

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB Wales a Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB in data 13 lug 2020

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Birch House Woodlands Business Park Milton Keynes Buckinghamshire MK14 6EW England a Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB in data 16 mar 2020

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Neil Paramore come amministratore in data 28 gen 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neil Paramore come segretario in data 28 gen 2020

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Andrew Mark Glennon come segretario in data 28 gen 2020

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Andrew Mark Glennon come amministratore in data 28 gen 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 11 giu 2016

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di IN-TO-SAVE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Segretario
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    266960810001
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Amministratore
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    WalesBritish260666740001
    MERSICH, Zane Cedomir
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Amministratore
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    EnglandSouth African131382980002
    HARVEY, Peter James
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    British103770410001
    HUGHES, Harry Stuart
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    Segretario
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    British7148530001
    PARAMORE, Neil
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Segretario
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    209558860001
    WILSON, Karen
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British151965340002
    YANTIN, Gary Laurence
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    Segretario
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    British119004760001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Segretario
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    BOGG, Dyson Peter Kelly
    Fosbury Mews
    Bayswater
    W2 3JE London
    8
    Amministratore
    Fosbury Mews
    Bayswater
    W2 3JE London
    8
    Australian113701350003
    BRYDON, Leslie
    1 Victoria House
    Market Place
    DL8 4NP Middleham
    North Yorkshire
    Amministratore
    1 Victoria House
    Market Place
    DL8 4NP Middleham
    North Yorkshire
    British103621720001
    EVANS, Byron
    Keepers Cottage
    46 High Street Whittlebury
    NN12 8JX Northampton
    Amministratore
    Keepers Cottage
    46 High Street Whittlebury
    NN12 8JX Northampton
    British105734100001
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HARDING, Nicholas Simon
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    EnglandBritish150860820001
    HARVEY, Peter James
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103770410003
    HUGHES, Harry Stuart
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    Amministratore
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    United KingdomBritish7148530001
    HUGHES, John Ashley
    Longwood
    Darlington Road
    DL10 7EB Richmond
    North Yorkshire
    Amministratore
    Longwood
    Darlington Road
    DL10 7EB Richmond
    North Yorkshire
    United KingdomBritish112694600001
    PARAMORE, Neil
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Amministratore
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    WalesBritish79707840002
    REDMOND, Brendan Patrick
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    Amministratore
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    AustraliaIrish117576220001

    Chi sono le persone con controllo significativo di IN-TO-SAVE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    06 apr 2016
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05382157
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    IN-TO-SAVE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 04 apr 2007
    Consegnato il 17 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transazioni
    • 17 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 08 feb 2007
    Consegnato il 14 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the benefit of the finance parties (the "the security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 lug 2005
    Consegnato il 09 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mag 1998
    Consegnato il 30 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Creato il 09 set 1996
    Consegnato il 17 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the standard security
    Brevi particolari
    The plot or area of ground lying in the burgh of kirkcaldy and county of fife extending to 865 square metres bounded on or twoards the southwest by whytescauseway, kirkcaldy along which it extends 15.3 metres.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 ago 1994
    Consegnato il 10 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from leisure promotions limited to the chargee on any accouny whatsoever and by the company under the provisions of the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings on south side of boathouse lane stockton on tees. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 ago 1994
    Consegnato il 10 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a bridge end saw mills boathouse lane stockton on tees. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 21 lug 1994
    Consegnato il 22 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 set 1992
    Consegnato il 02 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref M366C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 12 mar 1991
    Consegnato il 27 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit G3, boathouse lane stockton-on-tees cleveland title no ce 76294.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 giu 1988
    Consegnato il 22 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bridge end saw mills boathouse lane stockton on tees cleveland. Title no ce 60319.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 16 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 set 1984
    Consegnato il 14 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 16 gen 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0