PRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED

PRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01744913
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova PRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O MAZARS LLP
    First Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRODUCT PLUS (LONDON) LIMITED09 ago 198309 ago 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per PRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Broadway Trafford Wharf Road Manchester M17 1DD

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Broadway Trafford Wharf Road Manchester M17 1DD a First Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX in data 17 giu 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 giu 2022

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 08 dic 2021

    2 paginePSC09

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Stato del capitale al 18 nov 2021

    • Capitale: GBP 764.18
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 17 nov 2021

    • Capitale: GBP 76,418
    3 pagineSH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Claire Louise Thomson come segretario in data 28 gen 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Lucy Claire Penfold come segretario in data 28 gen 2021

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 017449130006 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PENFOLD, Lucy Claire
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    First Floor
    Segretario
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    First Floor
    279209360001
    LEE, Christopher
    Trafford Wharf Road
    M17 1DD Manchester
    Broadway
    United Kingdom
    Amministratore
    Trafford Wharf Road
    M17 1DD Manchester
    Broadway
    United Kingdom
    United KingdomBritish165964010001
    THOMSON, Claire Louise
    Trafford Wharf Road
    M17 1DD Manchester
    Broadway
    United Kingdom
    Amministratore
    Trafford Wharf Road
    M17 1DD Manchester
    Broadway
    United Kingdom
    United KingdomBritish165964020001
    HARRISON, Richard
    The Barn Main Street
    Tibthorpe
    YO25 9LA Driffield
    East Yorkshire
    Segretario
    The Barn Main Street
    Tibthorpe
    YO25 9LA Driffield
    East Yorkshire
    British549980003
    SCULL, Andrew James
    Kelling House
    18 Grantham Road
    NG13 0EG Bottesford
    Nottinghamshire
    Segretario
    Kelling House
    18 Grantham Road
    NG13 0EG Bottesford
    Nottinghamshire
    British99150360001
    SLATER, Richard Craig Alan
    Westleigh
    Stannage Lane Churton
    CH3 6LE Chester
    Segretario
    Westleigh
    Stannage Lane Churton
    CH3 6LE Chester
    British37111560008
    THOMSON, Claire Louise
    Trafford Wharf Road
    M17 1DD Manchester
    Broadway
    United Kingdom
    Segretario
    Trafford Wharf Road
    M17 1DD Manchester
    Broadway
    United Kingdom
    British167878640001
    WOOLLEY, Diana Rosemary
    8 Randolph Avenue
    W9 1BP London
    Segretario
    8 Randolph Avenue
    W9 1BP London
    British1459550001
    BENNINGTON, Graham James
    Ings House The Green
    Ellerker
    HU15 2DP Brough
    East Yorkshire
    Amministratore
    Ings House The Green
    Ellerker
    HU15 2DP Brough
    East Yorkshire
    British28380700002
    BIRKIN, Michael John
    Ferry Barn
    Smugglers Lane, Bosham
    PO18 8QW Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Ferry Barn
    Smugglers Lane, Bosham
    PO18 8QW Chichester
    West Sussex
    British23500200005
    BOOTH, Stephen Rodger Gavin
    Lund Farm
    Lund
    YO25 9TE Driffield
    East Yorkshire
    Amministratore
    Lund Farm
    Lund
    YO25 9TE Driffield
    East Yorkshire
    United KingdomBritish177741550001
    BOTTERILL, Andrew Douglas
    Chenies
    35 Pheasants Way
    WD3 7EX Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Chenies
    35 Pheasants Way
    WD3 7EX Rickmansworth
    Hertfordshire
    British9578130002
    CUMMINGS, Ian Charles
    9 Parkland Drive
    AL3 4AH St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Parkland Drive
    AL3 4AH St Albans
    Hertfordshire
    British8811380002
    DAVIES, Gillian
    Flat 15
    51 Iverna Gardens, Kensington
    W8 6TP London
    Amministratore
    Flat 15
    51 Iverna Gardens, Kensington
    W8 6TP London
    EnglandBritish101918890003
    DEIGHTON, Rowland Simon Martin
    Laurel House
    29 Church Road, Aspley Heath
    MK17 8TG Woburn Sands
    Bedfordshire
    Amministratore
    Laurel House
    29 Church Road, Aspley Heath
    MK17 8TG Woburn Sands
    Bedfordshire
    British116132640001
    DEIGHTON, Rowland Simon Martin
    Laurel House
    29 Church Road, Aspley Heath
    MK17 8TG Woburn Sands
    Bedfordshire
    Amministratore
    Laurel House
    29 Church Road, Aspley Heath
    MK17 8TG Woburn Sands
    Bedfordshire
    British116132640001
    HARRISON, Richard
    The Barn Main Street
    Tibthorpe
    YO25 9LA Driffield
    East Yorkshire
    Amministratore
    The Barn Main Street
    Tibthorpe
    YO25 9LA Driffield
    East Yorkshire
    British549980003
    JONES, Peter Ivan
    Melplash Farmhouse
    Melplash
    DT6 Bridport
    Dorset
    Amministratore
    Melplash Farmhouse
    Melplash
    DT6 Bridport
    Dorset
    EnglandBritish302037220001
    MCCARTHY, Terence Edward
    High Pines
    Bishops Walk
    CR0 5BA Croydon
    Surrey
    Amministratore
    High Pines
    Bishops Walk
    CR0 5BA Croydon
    Surrey
    EnglandBritish71363730001
    O'MAHONY, John Finbarr
    80 Tithe Barn Drive
    Bray
    SL6 2DE Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    80 Tithe Barn Drive
    Bray
    SL6 2DE Maidenhead
    Berkshire
    British57965750001
    PENROSE, Noel Richard
    Dunvegan House The Street
    Shurlock Row
    RG10 0PR Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Dunvegan House The Street
    Shurlock Row
    RG10 0PR Reading
    Berkshire
    EnglandBritish41781310002
    SCULL, Andrew James
    Kelling House
    18 Grantham Road
    NG13 0EG Bottesford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Kelling House
    18 Grantham Road
    NG13 0EG Bottesford
    Nottinghamshire
    EnglandBritish99150360001
    SEEKINGS, David John Emmott
    2411 Newport Court
    Oshkosh
    Wisconsin 54904
    America
    Amministratore
    2411 Newport Court
    Oshkosh
    Wisconsin 54904
    America
    British94654400001
    SLATER, Richard Craig Alan
    Westleigh
    Stannage Lane Churton
    CH3 6LE Chester
    Amministratore
    Westleigh
    Stannage Lane Churton
    CH3 6LE Chester
    United KingdomBritish37111560008
    SQUIRRELL, Colin Paul
    96 Sandy Lane
    GU22 8BH Woking
    Surrey
    Amministratore
    96 Sandy Lane
    GU22 8BH Woking
    Surrey
    British53203910003
    VARLEY, Martin
    313 Stand Lane
    M26 1JA Radcliffe
    Greater Manchester
    Amministratore
    313 Stand Lane
    M26 1JA Radcliffe
    Greater Manchester
    British118718830001
    WALTON, John Clive
    10 Faircross Way
    AL1 4SD St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    10 Faircross Way
    AL1 4SD St Albans
    Hertfordshire
    British43310680001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Brand Addition Limited
    Trafford Wharf Road
    Trafford Park
    M17 1DD Manchester
    Broadway House
    England
    05 dic 2016
    Trafford Wharf Road
    Trafford Park
    M17 1DD Manchester
    Broadway House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleUk Company Law
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per PRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    05 dic 201605 dic 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    PRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 mag 2017
    Consegnato il 12 mag 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent)
    Transazioni
    • 12 mag 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 mar 2012
    Consegnato il 30 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 feb 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 5 august 2008 and
    Creato il 07 ott 2008
    Consegnato il 15 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An omnibus letter of set-off
    Creato il 05 ago 2008
    Consegnato il 08 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Letter of charge
    Creato il 04 nov 1985
    Consegnato il 14 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys standing to the credit of any account of the company with the bank designated barclays bank PLC re product plus (london) limited.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ott 1983
    Consegnato il 09 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc M9). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PRODUCT PLUS INTERNATIONAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 giu 2022Inizio della liquidazione
    19 set 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Conrad Alexander Pearson
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Simon David Chandler
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0