PIFC CONSULTING LIMITED

PIFC CONSULTING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPIFC CONSULTING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01751876
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PIFC CONSULTING LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
    • Assicurazioni sulla vita (65110) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova PIFC CONSULTING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PIFC CONSULTING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PIFC CONSULTING PLC27 mar 200327 mar 2003
    PIFC BENEFIT CONSULTANTS PLC12 lug 199412 lug 1994
    PIFC INVESTMENT SERVICES LIMITED04 set 198704 set 1987
    PENSIONS, INSURANCE & FINANCIAL CONSULTANCY LIMITED09 set 198309 set 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di PIFC CONSULTING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PIFC CONSULTING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 mar 2019

    10 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 17 Rochester Row London SW1P 1QT a 1 More London Place London SE1 2AF in data 29 mar 2018

    2 pagineAD01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 71 Victoria Street London SW1H 0XA

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 71 Victoria Street London SW1H 0XA

    2 pagineAD02

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 07 mar 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di Mrs Francesca Anne Todd come amministratore in data 05 mar 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew John Bowman come amministratore in data 05 mar 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Susan Lesley Ring come amministratore in data 05 mar 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2016

    Stato del capitale al 15 apr 2016

    • Capitale: GBP 2,100,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Nomina di Capita Corporate Director Limited come amministratore in data 09 lug 2015

    2 pagineAP02

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    AR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 apr 2015

    Stato del capitale al 22 apr 2015

    • Capitale: GBP 2,100,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Anthony Nicholas Greatorex come amministratore in data 05 set 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew John Bowman come amministratore in data 05 set 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Susan Lesley Ring come amministratore in data 12 ago 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nicholas Mckenzie Herbert Burns come amministratore in data 12 ago 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 apr 2014

    Stato del capitale al 24 apr 2014

    • Capitale: GBP 2,100,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di PIFC CONSULTING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Segretario
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2376959
    135207160001
    TODD, Francesca Anne
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish72249980002
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5641516
    129795770003
    BAILEY, Brian John
    Weirmead Farmhouse
    Wheelers Lane, Brockham
    RH3 7HJ Betchworth
    Surrey
    Segretario
    Weirmead Farmhouse
    Wheelers Lane, Brockham
    RH3 7HJ Betchworth
    Surrey
    British75022770001
    HOLT, Antony Vincent
    12 Mymms Drive
    AL9 7AF Brookmans Park
    Hertfordshire
    Segretario
    12 Mymms Drive
    AL9 7AF Brookmans Park
    Hertfordshire
    British190351400001
    PENNINGTON LEGH, Peter Russell
    Vasterne Manor
    Wootton Bassett
    SN4 7PB Swindon
    Wiltshire
    Segretario
    Vasterne Manor
    Wootton Bassett
    SN4 7PB Swindon
    Wiltshire
    British42158460004
    RENNSION, Roderic Henry Patrick
    Old Westmill Farmhouse
    Westmil Lane Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Hertfordshire
    Segretario
    Old Westmill Farmhouse
    Westmil Lane Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Hertfordshire
    British126530510001
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Segretario
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    British67168210001
    SMITH, Andrew George
    69 Hemnall Street
    CM16 4LZ Epping
    Essex
    Segretario
    69 Hemnall Street
    CM16 4LZ Epping
    Essex
    British5842510002
    SWEENEY, John
    36 Carew Road
    CR7 7RE Thornton Heath
    Surrey
    Segretario
    36 Carew Road
    CR7 7RE Thornton Heath
    Surrey
    British18585520001
    WATSON, William Anthony
    Steep
    Hook Hill
    CR2 0LB Sanderstead
    Surrey
    Segretario
    Steep
    Hook Hill
    CR2 0LB Sanderstead
    Surrey
    British20191840001
    ANDERSON, Philip John
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    UkBritish79136250001
    BAMFORD, David
    The Oaks
    Smock Alley, West Chiltington
    RH20 2QX Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    The Oaks
    Smock Alley, West Chiltington
    RH20 2QX Pulborough
    West Sussex
    British65783710001
    BEDFORD, Nicolas Norman
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish147404780001
    BENNETT, Terence Bernard
    29 The Bridle Road
    CR8 3JB Purley
    Surrey
    Amministratore
    29 The Bridle Road
    CR8 3JB Purley
    Surrey
    EnglandBritish16939410001
    BOWMAN, Andrew John
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish190287270001
    BROWN, Duncan Morrison
    19 The Drive
    SM6 9LY Wallington
    Surrey
    Amministratore
    19 The Drive
    SM6 9LY Wallington
    Surrey
    United KingdomBritish31708430001
    BURNS, Nicholas Mckenzie Herbert
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish31708440014
    COX, Vanda Suzanne
    44 Northumberland Place
    W2 5AS London
    Amministratore
    44 Northumberland Place
    W2 5AS London
    United KingdomBritish77637810002
    CRAWFORD, David William
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish315434370001
    GRAY, Peter
    Nursery Road
    KT20 7TZ Walton On The Hill
    The Cobbles
    Surrey
    Amministratore
    Nursery Road
    KT20 7TZ Walton On The Hill
    The Cobbles
    Surrey
    United KingdomBritish2358790004
    GREATOREX, Anthony Nicholas
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish90617270001
    HIRD, Ann
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish155208660001
    HOLLAND, David Antony
    10a Hanyards Lane
    EN6 4AT Cuffley
    Hertfordshire
    Amministratore
    10a Hanyards Lane
    EN6 4AT Cuffley
    Hertfordshire
    United KingdomBritish23017240001
    HOLT, Antony Vincent
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    EnglandBritish190351400001
    HOWLETT, Mark Alan
    6 Bunyon Close
    Gamlingay
    SG19 3JD Sandy
    Bedfordshire
    Amministratore
    6 Bunyon Close
    Gamlingay
    SG19 3JD Sandy
    Bedfordshire
    United KingdomBritish103974610001
    MARTIN, Andrew James Donald
    30 Carshalton Park Road
    SM5 3SS Carshalton
    Surrey
    Amministratore
    30 Carshalton Park Road
    SM5 3SS Carshalton
    Surrey
    British49731720001
    MCGARRIGLE, Charles
    14 Kearton Close
    CR8 5EN Kenley
    Surrey
    Amministratore
    14 Kearton Close
    CR8 5EN Kenley
    Surrey
    British28807780001
    NELSON, James Jonathan, The Hon
    Forest Lodge
    Penselwood
    BA9 8LL Wincanton
    Somerset
    Amministratore
    Forest Lodge
    Penselwood
    BA9 8LL Wincanton
    Somerset
    United KingdomBritish113284780001
    PEARSON, Mark Robert
    Holmwood
    Bolney Road
    RH17 5AW Ansty
    West Sussex
    Amministratore
    Holmwood
    Bolney Road
    RH17 5AW Ansty
    West Sussex
    EnglandBritish294328240001
    PHILLIPS, Jonathan Mark
    83 Farmcombe Road
    TN2 5DQ Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    83 Farmcombe Road
    TN2 5DQ Tunbridge Wells
    Kent
    British78342490003
    RING, Susan Lesley
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish63513940002
    RYAN, Georgia
    Hill Farmhouse
    Norwich Road
    NR35 2DE Hedenham
    Norfolk
    Amministratore
    Hill Farmhouse
    Norwich Road
    NR35 2DE Hedenham
    Norfolk
    British77863970002
    SHARP, Stephen
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish138474120001
    SIMMONDS, John Robert
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritish81157250001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PIFC CONSULTING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06722404
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PIFC CONSULTING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 09 ago 2002
    Consegnato il 10 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 29 mar 1999
    Consegnato il 13 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a unit 1A, 1 & 1A church road croydon surrey. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mar 1999
    Consegnato il 13 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 07 feb 1992
    Consegnato il 19 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeversupplemental to the principal charge dated 14/12/87
    Brevi particolari
    First fixed charge on all goodwill & uncalled capital & all patents/applications inventions trade marks/names & registered designs copyrights & all licences.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 mar 1990
    Consegnato il 03 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the principal deed dated 2.3.87 and the legal charge.
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 1A, 1 and 1A church road l/b of croydon.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Assurance PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 12 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 14 dic 1987
    Consegnato il 18 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book and other debts floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mar 1987
    Consegnato il 13 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £305,000
    Brevi particolari
    F/H - unit 1A, 1 and 1A church rd, l/b of croydon.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Assurance PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PIFC CONSULTING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 mar 2018Inizio della liquidazione
    04 giu 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0