MATTHEW ROYCE MANUFACTURING LIMITED
Panoramica
Nome della società | MATTHEW ROYCE MANUFACTURING LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01752476 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MATTHEW ROYCE MANUFACTURING LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MATTHEW ROYCE MANUFACTURING LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 32-38 Scrutton Street EC2A 4RQ London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MATTHEW ROYCE MANUFACTURING LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SANDELICO LIMITED | 13 set 1983 | 13 set 1983 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MATTHEW ROYCE MANUFACTURING LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 gen 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per MATTHEW ROYCE MANUFACTURING LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 ott 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 gen 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 46 Colebrooke Row London N1 8AF a 32-38 Scrutton Street London EC2A 4RQ in data 17 mag 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tim Morgan Davies come amministratore in data 08 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Timothy Morgan Davies come amministratore in data 23 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Teresa Tideman come amministratore in data 23 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Shaun Simon Wills come amministratore in data 23 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Joanne Clare Bennett come amministratore in data 23 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 25 gen 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Joanne Clare Bennett come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Johnson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 26 gen 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Amanda Claire Fogg come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip Watt come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Ms Teresa Tideman come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Morris come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 apr 2012 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Sarah Morris come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Allen come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MATTHEW ROYCE MANUFACTURING LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGG, Amanda Claire | Segretario | Scrutton Street EC2A 4RQ London 32-38 England | 181381240001 | |||||||
WILLS, Shaun Simon | Amministratore | Scrutton Street EC2A 4RQ London 32-38 England | England | British | Chief Financial Officer | 185717270001 | ||||
ALLEN, Paul Christopher | Segretario | Wescott, 8 Beacon Rise TN13 2NJ Sevenoaks Kent | Irish | 54253320002 | ||||||
BRYAN, Paul Anthony Edward Peter | Segretario | 37 Chantry Avenue Hartley DA3 8DD Longfield Kent | British | Company Secretary | 25267050001 | |||||
CASH, Daphne Valerie | Segretario | 9 Marquis Close AL5 5QZ Harpenden Hertfordshire | British | Chartered Secretary | 59646330005 | |||||
HEARD, Nicholas James | Segretario | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | British | Company Secretary | 132971860002 | |||||
JOHNSON, Ian Paul | Segretario | Tugwood Kings Lane SL6 9TZ Cookham Dean Berkshire | British | 76187110001 | ||||||
MYLVAGAHAM, Sagitharan | Segretario | 9 Ashwell Avenue GU15 2AR Camberley Surrey | British | 17075960001 | ||||||
WARBURTON, Jenny | Segretario | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | 156886890001 | |||||||
WATT, Philip Graham | Segretario | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | 164016810001 | |||||||
WILLIAMS, Denise | Segretario | 38 Lynton Road South DA11 7NF Gravesend Kent | British | 24311940001 | ||||||
ALLEN, Paul Christopher | Amministratore | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | United Kingdom | Irish | Accountant | 185112730001 | ||||
ASHFORTH, Phillip John | Amministratore | Woodside 17 Garth Road TN13 1RT Sevenoaks Kent Kent | United Kingdom | British | Finance Director | 1311000004 | ||||
BENNETT, Joanne Clare | Amministratore | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | England | British | Chief Finance Officer | 184759270001 | ||||
BLACKLOCK, Duncan | Amministratore | 37 Darras Road Darras Hall HE20 9PD Ponteland Northumberland | British | Manufacturing Director | 17076030001 | |||||
BRYAN, Paul Anthony Edward Peter | Amministratore | 37 Chantry Avenue Hartley DA3 8DD Longfield Kent | British | Company Secretary | 25267050001 | |||||
CASH, Daphne Valerie | Amministratore | 9 Marquis Close AL5 5QZ Harpenden Hertfordshire | British | Chartered Secretary | 59646330005 | |||||
CYNAMON, Jack | Amministratore | Boundaries House 106 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NX Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 142370750001 | ||||
DAVIES, Tim Morgan | Amministratore | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 197113400001 | ||||
GREEN, Alan Michael | Amministratore | Threshers Threshersbush CM17 0NP Harlow Essex | British | Company Director | 94836450001 | |||||
HEALD, Malcolm Barclay | Amministratore | Summerley House Ellwood Road HP9 1EN Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | Chartered Accountant | 1605080001 | ||||
HEILBRON, Brian | Amministratore | 6 Nafferton Rise IG10 1UB Loughton Essex | England | British | Company Director | 102947240001 | ||||
JOHNSON, Ian Paul | Amministratore | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | United Kingdom | British | Finance Director | 76187110001 | ||||
MONTGOMERY, Antony Peter | Amministratore | 6 Greencroft GU1 2SY Guildford Surrey | British | Director | 55319870001 | |||||
MORRIS, Sarah | Amministratore | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | England | British | Director | 174804590001 | ||||
MYLVAGAHAM, Sagitharan | Amministratore | 9 Ashwell Avenue GU15 2AR Camberley Surrey | British | Chartered Accountant | 17075960001 | |||||
REID, William | Amministratore | Baykers Lamb Lane, Sible Hedingham CO9 3RS Halstead Essex | British | Director | 66677420001 | |||||
RIGGS, Joyce | Amministratore | 144 Temple Park Road South Shields Tyne & Wear | British | Factory Manageress | 17091700002 | |||||
TIDEMAN, Teresa Mary | Amministratore | 46 Colebrooke Row London N1 8AF | England | British | Company Director | 150161210001 | ||||
TIEDMAN, David Arthur | Amministratore | 26 Hartland Road CM16 4PE Epping Essex | British | Managing Director | 17080540001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MATTHEW ROYCE MANUFACTURING LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style Group Brands Limited | 06 apr 2016 | Scrutton Street EC2A 4RQ London 32-38 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
MATTHEW ROYCE MANUFACTURING LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge | Creato il 19 ago 1993 Consegnato il 27 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 ago 1992 Consegnato il 24 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 ago 1992 Consegnato il 26 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 24 gen 1984 Consegnato il 06 feb 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or matthew royce limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0