STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)

STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01753736
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?

    Indirizzo della sede legale
    Wyevale Garden Centres Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Middlesex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DANEMOOR LIMITED16 set 198316 set 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Justin Matthew King come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2015

    8 pagineAA

    Seconda presentazione per la cessazione di Kevin Michael Bradshaw come amministratore

    4 pagineRP04TM01

    Nomina di Mr Justin Matthew King come amministratore in data 18 ago 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 18 ago 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Mary Elizabeth Murray come segretario in data 25 ago 2016

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Gerald Jones il 22 lug 2016

    2 pagineCH01

    Nomina di Roger Mclaughlan come amministratore in data 10 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elizabeth Ann Ward come segretario in data 13 lug 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Kevin Michael Bradshaw come amministratore in data 09 mar 2016

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    22 set 2016Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016.

    Cessazione della carica di Nils Olin Steinmeyer come amministratore in data 01 apr 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Anthony Gerald Jones come amministratore in data 06 apr 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 06 apr 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Elizabeth Ann Ward come segretario in data 11 feb 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Nils Olin Steinmeyer come segretario in data 11 feb 2016

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da The Garden Centre Group, Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF in data 24 feb 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 gen 2016

    Stato del capitale al 04 gen 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF a The Garden Centre Group, Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF in data 04 gen 2016

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 gen 2015

    Stato del capitale al 23 gen 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Garden Centre Group Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF in data 23 gen 2015

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MURRAY, Mary Elizabeth
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    213045220001
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish212265950001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish206428840001
    FOALE, Stephen John
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    Segretario
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    British37403500001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    Segretario
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    British72128340003
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Segretario
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    British76162020001
    ROGERS, May Elizabeth
    7 Croft Lane
    SG6 1AS Letchworth
    Hertfordshire
    Segretario
    7 Croft Lane
    SG6 1AS Letchworth
    Hertfordshire
    British28069990001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    173142280001
    WARD, Elizabeth Ann
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    205459140001
    WHITTAKER, Janet Mary
    32 Whitney Drive
    SG1 4BH Stevenage
    Hertfordshire
    Segretario
    32 Whitney Drive
    SG1 4BH Stevenage
    Hertfordshire
    British28070010001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish124019940001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish195802400001
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Amministratore
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritish606430001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish72128340003
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish213157990001
    KING, Wendy
    9 Fielden
    Abbeydale
    GL4 5EW Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    9 Fielden
    Abbeydale
    GL4 5EW Gloucester
    Gloucestershire
    EnglandBritish89910600001
    KITCHING, Jonathan Andrew
    Beech House
    Harp Hill
    GL52 6PR Cheltenham
    Amministratore
    Beech House
    Harp Hill
    GL52 6PR Cheltenham
    EnglandBritish68271660002
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124967710001
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish111439220001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    Amministratore
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    WalesBritish1470180001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish207509410001
    PIERPOINT, David Julian
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    Amministratore
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    EnglandBritish138653690001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Amministratore
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritish76162020001
    ROGERS, May Elizabeth
    7 Croft Lane
    SG6 1AS Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Croft Lane
    SG6 1AS Letchworth
    Hertfordshire
    British28069990001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomGerman126422100002
    STEVENSON, Barry John
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    EnglandBritish102595670001
    WHITTAKER, Barrington
    32 Whitney Drive
    SG1 4BH Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    32 Whitney Drive
    SG1 4BH Stevenage
    Hertfordshire
    British28070000001
    WHITTAKER, Janet Mary
    32 Whitney Drive
    SG1 4BH Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    32 Whitney Drive
    SG1 4BH Stevenage
    Hertfordshire
    United KingdomBritish28070010001

    Chi sono le persone con controllo significativo di STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wyevale Garden Cedntres Holdings Limited
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    England
    06 apr 2016
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England & Wales
    Numero di registrazione01972554
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 24 feb 2009
    Consegnato il 04 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    Transazioni
    • 04 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to the debenture
    Creato il 12 dic 2007
    Consegnato il 21 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and property situated on the south east side of graveley road stevenage and adjoining land at the junction of B197 and graveley road stevenage t/nos hd. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 21 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 01 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any acount whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H st mellons park garden centre newport road st mellons cardiff fixed charge all buildings & other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the proeprty fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Finance Parties
    Transazioni
    • 01 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 01 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H st mellons park garden centre newport road st mellons cardiff fixed charge all buildings & other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the proeprty fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • West Coast Capital (Hortis) Limited
    Transazioni
    • 01 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to a debenture
    Creato il 29 mar 2007
    Consegnato il 17 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Agent for Thefinance Parties
    Transazioni
    • 17 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to a debenture
    Creato il 29 mar 2007
    Consegnato il 17 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • West Coast Capital (Hortis) Limited
    Transazioni
    • 17 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 23 feb 2007
    Consegnato il 27 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at the junction of the B197 and graveley road stevenage t/no HD451252.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 feb 2007
    Consegnato il 27 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the north west and north east sides of graveley road stevenage t/no hd 392392.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 feb 2007
    Consegnato il 24 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer
    Creato il 06 feb 2006
    Consegnato il 18 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    The triangualr shaped piece of land forming part of stevenage garden centre as shown on the plan attached to the transfer.
    Persone aventi diritto
    • K V Stevens (Stevanage) Limited
    Transazioni
    • 18 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Transfer
    Creato il 27 gen 2006
    Consegnato il 17 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Stevenage garden centre graveley road stevenage hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Commission for the New Towns
    Transazioni
    • 17 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 mag 1989
    Consegnato il 16 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 14 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 mag 1989
    Consegnato il 19 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £264,345.09 and all other moneys due or to become due from the company to csl holdings limited.
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Csl Holdings Limited
    Transazioni
    • 19 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 14 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 apr 1987
    Consegnato il 16 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Nursery at north road and graveley link stevenage hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 feb 1987
    Consegnato il 17 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or C.S.l business systems limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0