STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)
Panoramica
| Nome della società | STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE) |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01753736 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
| Indirizzo della sede legale | Wyevale Garden Centres Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Middlesex England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DANEMOOR LIMITED | 16 set 1983 | 16 set 1983 |
Quali sono gli ultimi bilanci di STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 27 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Justin Matthew King come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Seconda presentazione per la cessazione di Kevin Michael Bradshaw come amministratore | 4 pagine | RP04TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Justin Matthew King come amministratore in data 18 ago 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 18 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Mary Elizabeth Murray come segretario in data 25 ago 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Gerald Jones il 22 lug 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Roger Mclaughlan come amministratore in data 10 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Elizabeth Ann Ward come segretario in data 13 lug 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Michael Bradshaw come amministratore in data 09 mar 2016 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Nils Olin Steinmeyer come amministratore in data 01 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Anthony Gerald Jones come amministratore in data 06 apr 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 06 apr 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Elizabeth Ann Ward come segretario in data 11 feb 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nils Olin Steinmeyer come segretario in data 11 feb 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Garden Centre Group, Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF in data 24 feb 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF a The Garden Centre Group, Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF in data 04 gen 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Garden Centre Group Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF in data 23 gen 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURRAY, Mary Elizabeth | Segretario | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 213045220001 | |||||||
| JONES, Anthony Gerald | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 212265950001 | |||||
| MCLAUGHLAN, Roger | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 206428840001 | |||||
| FOALE, Stephen John | Segretario | 42 Holmbury Avenue RG45 6TQ Crowthorne Berkshire | British | 37403500001 | ||||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Segretario | 8 Stanmore Beedon RG20 8SR Newbury Berkshire | British | 72128340003 | ||||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Segretario | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | British | 76162020001 | ||||||
| ROGERS, May Elizabeth | Segretario | 7 Croft Lane SG6 1AS Letchworth Hertfordshire | British | 28069990001 | ||||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Segretario | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 173142280001 | |||||||
| WARD, Elizabeth Ann | Segretario | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 205459140001 | |||||||
| WHITTAKER, Janet Mary | Segretario | 32 Whitney Drive SG1 4BH Stevenage Hertfordshire | British | 28070010001 | ||||||
| BRADSHAW, Kevin Michael | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 124019940001 | |||||
| BRIGDEN, Peter | Amministratore | 16 Woodstock Gardens Appleton WA4 5HN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 195802400001 | |||||
| HODKINSON, James Clifford | Amministratore | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | 606430001 | |||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Amministratore | 8 Stanmore Beedon RG20 8SR Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 72128340003 | |||||
| KING, Justin Matthew | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 213157990001 | |||||
| KING, Wendy | Amministratore | 9 Fielden Abbeydale GL4 5EW Gloucester Gloucestershire | England | British | 89910600001 | |||||
| KITCHING, Jonathan Andrew | Amministratore | Beech House Harp Hill GL52 6PR Cheltenham | England | British | 68271660002 | |||||
| KOZLOWSKI, Richard Leon | Amministratore | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | 124967710001 | |||||
| LIVINGSTON, William Andrew | Amministratore | 3 Barnes Close St Cross SO23 9QX Winchester Hampshire | England | British | 111439220001 | |||||
| MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Amministratore | Glan Honddu House Llandefaelog Fach LD3 9PP Brecon Powys | Wales | British | 1470180001 | |||||
| MURPHY, Stephen Thomas | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 207509410001 | |||||
| PIERPOINT, David Julian | Amministratore | 33 West Street RH7 6QP Dormsland Rockvale Surrey | England | British | 138653690001 | |||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Amministratore | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | England | British | 76162020001 | |||||
| ROGERS, May Elizabeth | Amministratore | 7 Croft Lane SG6 1AS Letchworth Hertfordshire | British | 28069990001 | ||||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | German | 126422100002 | |||||
| STEVENSON, Barry John | Amministratore | Cherry Trees Cane End RG4 9HG Reading Berkshire | England | British | 102595670001 | |||||
| WHITTAKER, Barrington | Amministratore | 32 Whitney Drive SG1 4BH Stevenage Hertfordshire | British | 28070000001 | ||||||
| WHITTAKER, Janet Mary | Amministratore | 32 Whitney Drive SG1 4BH Stevenage Hertfordshire | United Kingdom | British | 28070010001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE)?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyevale Garden Cedntres Holdings Limited | 06 apr 2016 | Syon Park, London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
STEVENAGE GARDEN CENTRE LIMITED(THE) ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 24 feb 2009 Consegnato il 04 mar 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession to the debenture | Creato il 12 dic 2007 Consegnato il 21 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land and property situated on the south east side of graveley road stevenage and adjoining land at the junction of B197 and graveley road stevenage t/nos hd. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 19 set 2007 Consegnato il 01 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any acount whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H st mellons park garden centre newport road st mellons cardiff fixed charge all buildings & other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the proeprty fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 19 set 2007 Consegnato il 01 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H st mellons park garden centre newport road st mellons cardiff fixed charge all buildings & other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the proeprty fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession to a debenture | Creato il 29 mar 2007 Consegnato il 17 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession to a debenture | Creato il 29 mar 2007 Consegnato il 17 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from a chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 feb 2007 Consegnato il 27 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a land at the junction of the B197 and graveley road stevenage t/no HD451252. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 feb 2007 Consegnato il 27 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land on the north west and north east sides of graveley road stevenage t/no hd 392392. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 20 feb 2007 Consegnato il 24 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Transfer | Creato il 06 feb 2006 Consegnato il 18 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1 and all other monies due or to become due | |
Brevi particolari The triangualr shaped piece of land forming part of stevenage garden centre as shown on the plan attached to the transfer. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Transfer | Creato il 27 gen 2006 Consegnato il 17 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1 and all other monies due or to become due | |
Brevi particolari Stevenage garden centre graveley road stevenage hertfordshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 10 mag 1989 Consegnato il 16 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 mag 1989 Consegnato il 19 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £264,345.09 and all other moneys due or to become due from the company to csl holdings limited. | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 08 apr 1987 Consegnato il 16 apr 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Nursery at north road and graveley link stevenage hertfordshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 11 feb 1987 Consegnato il 17 feb 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or C.S.l business systems limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0