SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED

SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01759149
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 ott 2015

    • Capitale: GBP 650
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 lug 2015

    Stato del capitale al 23 lug 2015

    • Capitale: GBP 65,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 31 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 lug 2014

    Stato del capitale al 31 lug 2014

    • Capitale: GBP 65,000
    SH01

    Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* in data 21 feb 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Calveley come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ian Richard Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 lug 2013

    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188580810001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Amministratore
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritish184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish150511890001
    JOBSON, Timothy Akers
    6 Redhouse Road
    Tettenhall
    WV6 8ST Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    6 Redhouse Road
    Tettenhall
    WV6 8ST Wolverhampton
    West Midlands
    British34676900001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Segretario
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    KYRIAKOU, Patricia Linda
    The Rectory Rectory Road
    Donington Albrighton
    WV7 3EP Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    The Rectory Rectory Road
    Donington Albrighton
    WV7 3EP Wolverhampton
    West Midlands
    British2118290001
    WK COMPANY SERVICES LIMITED
    5 & 6 Northumberland Building
    Queen Square
    BA1 2JE Bath
    Avon
    Segretario
    5 & 6 Northumberland Building
    Queen Square
    BA1 2JE Bath
    Avon
    101282840001
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    British107751890001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Amministratore
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish131468590001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Amministratore
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    HILL, Peter
    Manor Farm Springhill Lane
    WV4 4UH Lower Penn
    Staffordshire
    Amministratore
    Manor Farm Springhill Lane
    WV4 4UH Lower Penn
    Staffordshire
    British60631360001
    JOBSON, Timothy Akers
    6 Redhouse Road
    Tettenhall
    WV6 8ST Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    6 Redhouse Road
    Tettenhall
    WV6 8ST Wolverhampton
    West Midlands
    British34676900001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Amministratore
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish145920530001
    KILGOUR, Robert Dow
    26 Beveridge Road
    KY1 1UY Kirkcaldy
    Fife
    Amministratore
    26 Beveridge Road
    KY1 1UY Kirkcaldy
    Fife
    British494960001
    KYRIAKOU, Michael Andreas
    La Rizonne
    Vanxains
    24600
    France
    Amministratore
    La Rizonne
    Vanxains
    24600
    France
    FranceBritish64115610001
    KYRIAKOU, Patricia Linda
    The Rectory Rectory Road
    Donington Albrighton
    WV7 3EP Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    The Rectory Rectory Road
    Donington Albrighton
    WV7 3EP Wolverhampton
    West Midlands
    British2118290001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritish145102120001
    WILLIS, Graeme
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    British71527500002
    WILLIS, Graeme
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    British71527500002

    SPRINGFIELD HOUSE (OAKEN) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rhyme debenture
    Creato il 12 nov 2004
    Consegnato il 30 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 30 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ott 2001
    Consegnato il 30 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a oakfield house, 126 barkham road, wokingham, berkshire t/no BK303511.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 ott 2001
    Consegnato il 26 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 ott 1999
    Consegnato il 12 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or group company (as defined) to the chargee under the debenture or otherwise
    Brevi particolari
    The leasehold property known as springfield house, oaken lane, wolverhampton west midlands WV8 2EE. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Carlton Healthcare Properties Limited
    Transazioni
    • 12 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 ago 1998
    Consegnato il 16 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies,other liabilities and other costs charges and expenses due or to become due from the company to the charge under a lease dated 28TH august 1998 and all other monies due under or pursuant to any clause of the debenture
    Brevi particolari
    L/H property k/a springfield house oaken lane codsall woverhampton west midlands. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Carlton Healthcare Properties Limited
    Transazioni
    • 16 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 ago 1984
    Consegnato il 14 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold springfield house, oaken, codsall, staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 ott 1983
    Consegnato il 20 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures (including trade) fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0