THE MORTGAGE CORPORATION
Panoramica
| Nome della società | THE MORTGAGE CORPORATION |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
| Numero di società | 01759546 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE MORTGAGE CORPORATION?
- Attività delle società di finanziamento ipotecario (64922) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova THE MORTGAGE CORPORATION?
| Indirizzo della sede legale | 1 Dorset Street SO15 2DP Southampton Hampshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE MORTGAGE CORPORATION?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PHILIPP BROTHERS TRADE FINANCE LIMITED | 15 dic 1983 | 15 dic 1983 |
| WALLSEA LIMITED | 07 ott 1983 | 07 ott 1983 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE MORTGAGE CORPORATION?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE MORTGAGE CORPORATION?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | 4.71 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Group Secretariat the Royal Bank of Scotland Group Plc 1 Princes Street London EC2R 8PB a 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP in data 04 gen 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 2 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Richard Browne il 26 mag 2014 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Emma Dignam come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Rbs Secretarial Services Limited come segretario | 3 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mary Mullen come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 15 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 15 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr John Richard Browne come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Marie Baird come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 15 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Marie Claire Baird il 30 giu 2011 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 15 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE MORTGAGE CORPORATION?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24-25 Midlothian Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| BROWNE, John Richard | Amministratore | Donegall Square East BT1 5UB Belfast 11-16 Antrim | Northern Ireland | British | 133984130003 | |||||||||
| MCKAVANAGH, Michael | Amministratore | Donegall Square East BT1 5UB Belfast 11-16 County Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | British | 144285280001 | |||||||||
| DIGNAM, Emma | Segretario | Sandy Road Dublin Cillview Ireland | British | 138386380001 | ||||||||||
| MULLEN, Mary | Segretario | 24 Glenbourne Green Leopardstown Valley Dublin 18 Republic Of Ireland | British | 56577720001 | ||||||||||
| PELLOW, Ian Anthony | Segretario | 6 Meadowside Tilehurst RG31 5QE Reading Berkshire | British | 33098310002 | ||||||||||
| WARREN, Anthony John | Segretario | 4 Station Road Wilmcote CV37 9UN Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 98775740001 | ||||||||||
| WELLMAN, Gillian Margaret | Segretario | 9 Ormonde Place Old Avenue KT13 0PE Weybridge Surrey | British | 80029900001 | ||||||||||
| BAIRD, Marie Claire | Amministratore | Donegall Square East BT1 5UB Belfast 11-16 County Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | British | 146713200004 | |||||||||
| BAKER, Robin Gregory | Amministratore | Doddinghurst Road CM15 9EH Brentwood Essex | United Kingdom | British | 35557610004 | |||||||||
| BAKER, Robin Gregory | Amministratore | Doddinghurst Road CM15 9EH Brentwood Essex | United Kingdom | British | 35557610004 | |||||||||
| BARRETT, Kevin Christopher | Amministratore | Buichas IRISH Kilquade Co Wicklow Ireland | Irish | 81923740001 | ||||||||||
| BERGIN, Robert Kevin | Amministratore | 10 Merton Drive Ranalagh Dublin 6 Ireland | Ireland | Irish | 186573040001 | |||||||||
| BRACKEN, Maurice John | Amministratore | 45 College Grove Castlerock IRISH Dublin 15 Ireland | Irish | 49068010001 | ||||||||||
| HOLMES, Conor Fintan | Amministratore | Troll Heim Balkill Road Howth County Dublin Republic Of Ireland | Irish | 41683950001 | ||||||||||
| HOLMES, Conor Fintan | Amministratore | Troll Heim Balkill Road Howth County Dublin Republic Of Ireland | Irish | 41683950001 | ||||||||||
| HOWARD, Donald Searcy | Amministratore | 3 Hook Harbor Road 07716 Atlantic Highlands New Jersey Usa | American | 3351880001 | ||||||||||
| JARVIS, David | Amministratore | 64 Cadogan Square SW1 London | American/British | 53825690001 | ||||||||||
| KELLY, Colin Pierce | Amministratore | 11 Glenbourne Crescent Leopardstown Valley Leopardstown Dublin 18 Ireland | Irish | 105811410002 | ||||||||||
| KHERAJ, Naguib | Amministratore | 2 Cedarland Terrace Copse Hill SW20 0NB London | British | 24278650002 | ||||||||||
| MASSEY, James Lee | Amministratore | 99 Roundhill Road 06831 Greenwich Connecticut Usa | American | 2686350002 | ||||||||||
| MCDERMOTT, Martin | Amministratore | 6 Lovett Green MK45 4SP Sharpenhoe Bedfordshire | England | British | 74724160001 | |||||||||
| MCSLOY, Peter James | Amministratore | 1 Glebe Place SW3 5LB London | British | 34595110001 | ||||||||||
| MIDDLETON, Peter James | Amministratore | 3 Kempson Road SW6 4PX London | British | 41093880002 | ||||||||||
| MINOPRIO, Piers | Amministratore | The Kennels Bells Yew Green Frant TN3 9AX Tunbridge Wells Kent | British | 61163800001 | ||||||||||
| MULLEN, Peter | Amministratore | Flat 2 115 St Georges Square SW1V 3QP London | American | 71882710002 | ||||||||||
| NAU, Robert Andrew | Amministratore | 9 Beechwood Road Bronxville FOREIGN New York Ny 10708 Usa | American | 12951210001 | ||||||||||
| ROGERS, Paul Robert | Amministratore | 2 Zig Zag Road CR8 5EL Kenley Surrey | England | British | 53567140002 | |||||||||
| ROGERS, Paul Robert | Amministratore | 2 Zig Zag Road CR8 5EL Kenley Surrey | England | British | 53567140002 | |||||||||
| ROTHE, Leroy Jay | Amministratore | 39 Chester Row SW1W 9JE London | American | 30999610001 | ||||||||||
| SHANAHAN, Michael Anthony | Amministratore | Mahermore 7 Cenacle Grove Killiney Hill Road Killiney County Dublin Ireland | Irish | 74277830003 | ||||||||||
| WARD, Anthony John | Amministratore | Maynards Appledore Road Leigh Green TN30 7DE Tenterden Kent | England | British | 106674440001 | |||||||||
| WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LONDON) LIMITED | Amministratore | Tower 42 (Level 11) International Financial Centre 25 Old Broad Street EC2N 1HQ London | 24311810024 |
THE MORTGAGE CORPORATION ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of agreements for the purchase of cavendish homes no 3 PLC property portfolio | Creato il 25 giu 1997 Consegnato il 04 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter and all other sums due under the deed and under the facility letter | |
Brevi particolari Ash house bridge road bleadon weston-super-mare avon t/n-AV130936, 20 queens rise and garage tutbury burton on trent t/n-SF280644, "koala" laughan road salehurst t/n-ESX15679.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of agreements (for the purchase of cavendish homes no 1 PLC property portfolio) | Creato il 25 giu 1997 Consegnato il 04 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter dated 21 may 1997 and all other sums becoming due and interest payable under the deed and under the facility letter | |
Brevi particolari The beneficial and equitable interest of the company in the properties details of which are set out in the schedule attached to form M395 comprising the premises as defined in the option agreements dated 14/1/97 providing for the sale and purchase of the properties as varied by a variation agreement of 25/6/97, the properties being: flat 11 st joseph's court forest view chingford t/n EGL208338; 157 vivian way wembley t/n MX447228 and 16 tenby drive luton t/n BD12929, for details of further property charged please refer to form M395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of agreements (for the purchase of cavendish homes no 2 PLC property portfolio) | Creato il 25 giu 1997 Consegnato il 04 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter dated 21 may 1997 and all other sums becoming due and interest payable under the deed and under the facility letter | |
Brevi particolari The beneficial and equitable interest of the company in the properties being those set out in the schedule to form M395 comprising the premises as defined in the option agreements dated 14/1/97 providing for the sale and purchase of the properties varied by a variation agreement of 25/6/97, the properties being:49 easingwold gardens luton and garage t/n BD11519; the pines hay green road terrington st clement norfolk t/n NK97260, 72 betsham road maidstone kent t/n K560427, for details of further properties charged please refer to form M395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 30 mag 1997 Consegnato il 14 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The obligations of first national building society ("fnbs") to (subject to any applicable grace periods) discharge each and every liability when the same becomes due and payable which it may at the dated of the floating charge or thereafter have to the chargee under clause 1 and clause 12 of a guarantee dated 31ST may 1996 between fnbs and the insurers pursuant to which fnbs has guaranteed certain obligations of the company to the insurers | |
Brevi particolari All rights and claims to which the company has at the date of the floating charge and all entitlement in relation to the monies standing to the credit of bank account 00884243 with barclays bank PLC (the "account"). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Shares charge | Creato il 28 mag 1997 Consegnato il 10 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed, the counter-indemnity or the credit agreement | |
Brevi particolari All present and future interest in and to the shares and the shares rights. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge and set off deed | Creato il 21 mag 1997 Consegnato il 05 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the credit agreement and the counter-indemnity both of even date and therein defined | |
Brevi particolari First fixed charge the deposit monies as continuing security for the secured sums which means all monies from time to time held to the credit of the chargor by the bank on the account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of undertaking | Creato il 14 nov 1996 Consegnato il 05 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £75,000,000 under the terms of the letter | |
Brevi particolari Any sums advanced by the purchaseres pursuant to the support agreements any claims against any of the issuers or insurers any sumd recieved from any sub-issuer or applicable insurer. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 ago 1996 Consegnato il 12 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of an agreement dated 7/8/96 and this charge | |
Brevi particolari Floating charge over the whole of the company's undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge on cash deposits | Creato il 13 mag 1991 Consegnato il 29 mag 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of an interest rate and currency exchange agreement dated 6TH octomber 1989 | |
Brevi particolari The sum of £11,792,726 and any other sum or sums which and from time to time deposited (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 27 giu 1989 Consegnato il 05 lug 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a funding agreement of even date and under the terms of this charge | |
Brevi particolari First floating charge the mortages and each of them and all its rights title interest and benefit present and future therein subject to the rights of redemption of the borrowers (see form 395 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assingment | Creato il 26 feb 1988 Consegnato il 26 feb 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a servicing agreement of even date and under the terms of the charge | |
Brevi particolari All the mortgagor's right title interest and benefit present and future under an agreement dated 26/2/88 (see from 395 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
THE MORTGAGE CORPORATION ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0