THE MORTGAGE CORPORATION

THE MORTGAGE CORPORATION

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE MORTGAGE CORPORATION
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 01759546
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE MORTGAGE CORPORATION?

    • Attività delle società di finanziamento ipotecario (64922) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova THE MORTGAGE CORPORATION?

    Indirizzo della sede legale
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE MORTGAGE CORPORATION?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PHILIPP BROTHERS TRADE FINANCE LIMITED15 dic 198315 dic 1983
    WALLSEA LIMITED07 ott 198307 ott 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE MORTGAGE CORPORATION?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per THE MORTGAGE CORPORATION?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Group Secretariat the Royal Bank of Scotland Group Plc 1 Princes Street London EC2R 8PB a 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP in data 04 gen 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 dic 2015

    LRESSP

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 dic 2014

    Stato del capitale al 02 dic 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    15 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Richard Browne il 26 mag 2014

    3 pagineCH01

    Cessazione della carica di Emma Dignam come segretario

    2 pagineTM02

    Nomina di Rbs Secretarial Services Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Cessazione della carica di Mary Mullen come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 dic 2013

    Stato del capitale al 04 dic 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    19 pagineAA

    Nomina di Mr John Richard Browne come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Marie Baird come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    19 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Marie Claire Baird il 30 giu 2011

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 06 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di THE MORTGAGE CORPORATION?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24-25
    Midlothian
    Scotland
    Segretario
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24-25
    Midlothian
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC269847
    169073830001
    BROWNE, John Richard
    Donegall Square East
    BT1 5UB Belfast
    11-16
    Antrim
    Amministratore
    Donegall Square East
    BT1 5UB Belfast
    11-16
    Antrim
    Northern IrelandBritish133984130003
    MCKAVANAGH, Michael
    Donegall Square East
    BT1 5UB Belfast
    11-16
    County Antrim
    Northern Ireland
    Amministratore
    Donegall Square East
    BT1 5UB Belfast
    11-16
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish144285280001
    DIGNAM, Emma
    Sandy Road
    Dublin
    Cillview
    Ireland
    Segretario
    Sandy Road
    Dublin
    Cillview
    Ireland
    British138386380001
    MULLEN, Mary
    24 Glenbourne Green
    Leopardstown Valley
    Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Segretario
    24 Glenbourne Green
    Leopardstown Valley
    Dublin 18
    Republic Of Ireland
    British56577720001
    PELLOW, Ian Anthony
    6 Meadowside
    Tilehurst
    RG31 5QE Reading
    Berkshire
    Segretario
    6 Meadowside
    Tilehurst
    RG31 5QE Reading
    Berkshire
    British33098310002
    WARREN, Anthony John
    4 Station Road
    Wilmcote
    CV37 9UN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Segretario
    4 Station Road
    Wilmcote
    CV37 9UN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British98775740001
    WELLMAN, Gillian Margaret
    9 Ormonde Place
    Old Avenue
    KT13 0PE Weybridge
    Surrey
    Segretario
    9 Ormonde Place
    Old Avenue
    KT13 0PE Weybridge
    Surrey
    British80029900001
    BAIRD, Marie Claire
    Donegall Square East
    BT1 5UB Belfast
    11-16
    County Antrim
    Northern Ireland
    Amministratore
    Donegall Square East
    BT1 5UB Belfast
    11-16
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish146713200004
    BAKER, Robin Gregory
    Doddinghurst Road
    CM15 9EH Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Doddinghurst Road
    CM15 9EH Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish35557610004
    BAKER, Robin Gregory
    Doddinghurst Road
    CM15 9EH Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Doddinghurst Road
    CM15 9EH Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish35557610004
    BARRETT, Kevin Christopher
    Buichas
    IRISH Kilquade
    Co Wicklow
    Ireland
    Amministratore
    Buichas
    IRISH Kilquade
    Co Wicklow
    Ireland
    Irish81923740001
    BERGIN, Robert Kevin
    10 Merton Drive
    Ranalagh
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    10 Merton Drive
    Ranalagh
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish186573040001
    BRACKEN, Maurice John
    45 College Grove
    Castlerock
    IRISH Dublin 15
    Ireland
    Amministratore
    45 College Grove
    Castlerock
    IRISH Dublin 15
    Ireland
    Irish49068010001
    HOLMES, Conor Fintan
    Troll Heim
    Balkill Road
    Howth
    County Dublin
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    Troll Heim
    Balkill Road
    Howth
    County Dublin
    Republic Of Ireland
    Irish41683950001
    HOLMES, Conor Fintan
    Troll Heim
    Balkill Road
    Howth
    County Dublin
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    Troll Heim
    Balkill Road
    Howth
    County Dublin
    Republic Of Ireland
    Irish41683950001
    HOWARD, Donald Searcy
    3 Hook Harbor Road
    07716 Atlantic Highlands
    New Jersey
    Usa
    Amministratore
    3 Hook Harbor Road
    07716 Atlantic Highlands
    New Jersey
    Usa
    American3351880001
    JARVIS, David
    64 Cadogan Square
    SW1 London
    Amministratore
    64 Cadogan Square
    SW1 London
    American/British53825690001
    KELLY, Colin Pierce
    11 Glenbourne Crescent
    Leopardstown Valley
    Leopardstown Dublin 18
    Ireland
    Amministratore
    11 Glenbourne Crescent
    Leopardstown Valley
    Leopardstown Dublin 18
    Ireland
    Irish105811410002
    KHERAJ, Naguib
    2 Cedarland Terrace
    Copse Hill
    SW20 0NB London
    Amministratore
    2 Cedarland Terrace
    Copse Hill
    SW20 0NB London
    British24278650002
    MASSEY, James Lee
    99 Roundhill Road
    06831 Greenwich
    Connecticut
    Usa
    Amministratore
    99 Roundhill Road
    06831 Greenwich
    Connecticut
    Usa
    American2686350002
    MCDERMOTT, Martin
    6 Lovett Green
    MK45 4SP Sharpenhoe
    Bedfordshire
    Amministratore
    6 Lovett Green
    MK45 4SP Sharpenhoe
    Bedfordshire
    EnglandBritish74724160001
    MCSLOY, Peter James
    1 Glebe Place
    SW3 5LB London
    Amministratore
    1 Glebe Place
    SW3 5LB London
    British34595110001
    MIDDLETON, Peter James
    3 Kempson Road
    SW6 4PX London
    Amministratore
    3 Kempson Road
    SW6 4PX London
    British41093880002
    MINOPRIO, Piers
    The Kennels Bells Yew Green
    Frant
    TN3 9AX Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    The Kennels Bells Yew Green
    Frant
    TN3 9AX Tunbridge Wells
    Kent
    British61163800001
    MULLEN, Peter
    Flat 2
    115 St Georges Square
    SW1V 3QP London
    Amministratore
    Flat 2
    115 St Georges Square
    SW1V 3QP London
    American71882710002
    NAU, Robert Andrew
    9 Beechwood Road
    Bronxville
    FOREIGN New York Ny 10708
    Usa
    Amministratore
    9 Beechwood Road
    Bronxville
    FOREIGN New York Ny 10708
    Usa
    American12951210001
    ROGERS, Paul Robert
    2 Zig Zag Road
    CR8 5EL Kenley
    Surrey
    Amministratore
    2 Zig Zag Road
    CR8 5EL Kenley
    Surrey
    EnglandBritish53567140002
    ROGERS, Paul Robert
    2 Zig Zag Road
    CR8 5EL Kenley
    Surrey
    Amministratore
    2 Zig Zag Road
    CR8 5EL Kenley
    Surrey
    EnglandBritish53567140002
    ROTHE, Leroy Jay
    39 Chester Row
    SW1W 9JE London
    Amministratore
    39 Chester Row
    SW1W 9JE London
    American30999610001
    SHANAHAN, Michael Anthony
    Mahermore 7 Cenacle Grove
    Killiney Hill Road
    Killiney
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Mahermore 7 Cenacle Grove
    Killiney Hill Road
    Killiney
    County Dublin
    Ireland
    Irish74277830003
    WARD, Anthony John
    Maynards Appledore Road
    Leigh Green
    TN30 7DE Tenterden
    Kent
    Amministratore
    Maynards Appledore Road
    Leigh Green
    TN30 7DE Tenterden
    Kent
    EnglandBritish106674440001
    WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LONDON) LIMITED
    Tower 42 (Level 11) International Financial Centre
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Amministratore
    Tower 42 (Level 11) International Financial Centre
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    24311810024

    THE MORTGAGE CORPORATION ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of agreements for the purchase of cavendish homes no 3 PLC property portfolio
    Creato il 25 giu 1997
    Consegnato il 04 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter and all other sums due under the deed and under the facility letter
    Brevi particolari
    Ash house bridge road bleadon weston-super-mare avon t/n-AV130936, 20 queens rise and garage tutbury burton on trent t/n-SF280644, "koala" laughan road salehurst t/n-ESX15679.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of agreements (for the purchase of cavendish homes no 1 PLC property portfolio)
    Creato il 25 giu 1997
    Consegnato il 04 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter dated 21 may 1997 and all other sums becoming due and interest payable under the deed and under the facility letter
    Brevi particolari
    The beneficial and equitable interest of the company in the properties details of which are set out in the schedule attached to form M395 comprising the premises as defined in the option agreements dated 14/1/97 providing for the sale and purchase of the properties as varied by a variation agreement of 25/6/97, the properties being: flat 11 st joseph's court forest view chingford t/n EGL208338; 157 vivian way wembley t/n MX447228 and 16 tenby drive luton t/n BD12929, for details of further property charged please refer to form M395.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of agreements (for the purchase of cavendish homes no 2 PLC property portfolio)
    Creato il 25 giu 1997
    Consegnato il 04 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter dated 21 may 1997 and all other sums becoming due and interest payable under the deed and under the facility letter
    Brevi particolari
    The beneficial and equitable interest of the company in the properties being those set out in the schedule to form M395 comprising the premises as defined in the option agreements dated 14/1/97 providing for the sale and purchase of the properties varied by a variation agreement of 25/6/97, the properties being:49 easingwold gardens luton and garage t/n BD11519; the pines hay green road terrington st clement norfolk t/n NK97260, 72 betsham road maidstone kent t/n K560427, for details of further properties charged please refer to form M395.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 30 mag 1997
    Consegnato il 14 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations of first national building society ("fnbs") to (subject to any applicable grace periods) discharge each and every liability when the same becomes due and payable which it may at the dated of the floating charge or thereafter have to the chargee under clause 1 and clause 12 of a guarantee dated 31ST may 1996 between fnbs and the insurers pursuant to which fnbs has guaranteed certain obligations of the company to the insurers
    Brevi particolari
    All rights and claims to which the company has at the date of the floating charge and all entitlement in relation to the monies standing to the credit of bank account 00884243 with barclays bank PLC (the "account"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sun Alliance and London Insurance PLC and Royal Insurance (UK) Limited(Together the "Insurers")
    Transazioni
    • 14 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Shares charge
    Creato il 28 mag 1997
    Consegnato il 10 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed, the counter-indemnity or the credit agreement
    Brevi particolari
    All present and future interest in and to the shares and the shares rights.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge and set off deed
    Creato il 21 mag 1997
    Consegnato il 05 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the credit agreement and the counter-indemnity both of even date and therein defined
    Brevi particolari
    First fixed charge the deposit monies as continuing security for the secured sums which means all monies from time to time held to the credit of the chargor by the bank on the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of undertaking
    Creato il 14 nov 1996
    Consegnato il 05 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £75,000,000 under the terms of the letter
    Brevi particolari
    Any sums advanced by the purchaseres pursuant to the support agreements any claims against any of the issuers or insurers any sumd recieved from any sub-issuer or applicable insurer.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transazioni
    • 05 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 ago 1996
    Consegnato il 12 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of an agreement dated 7/8/96 and this charge
    Brevi particolari
    Floating charge over the whole of the company's undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 12 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 19 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge on cash deposits
    Creato il 13 mag 1991
    Consegnato il 29 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of an interest rate and currency exchange agreement dated 6TH octomber 1989
    Brevi particolari
    The sum of £11,792,726 and any other sum or sums which and from time to time deposited (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 29 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 27 giu 1989
    Consegnato il 05 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a funding agreement of even date and under the terms of this charge
    Brevi particolari
    First floating charge the mortages and each of them and all its rights title interest and benefit present and future therein subject to the rights of redemption of the borrowers (see form 395 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Salomon Brothers International Limited
    Transazioni
    • 05 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 14 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assingment
    Creato il 26 feb 1988
    Consegnato il 26 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a servicing agreement of even date and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All the mortgagor's right title interest and benefit present and future under an agreement dated 26/2/88 (see from 395 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Tmc Private Placements No 1 Limited
    Transazioni
    • 26 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THE MORTGAGE CORPORATION ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 dic 2015Inizio della liquidazione
    07 gen 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0