STERLING TRUST LIMITED

STERLING TRUST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTERLING TRUST LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01761400
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di STERLING TRUST LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova STERLING TRUST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o DOW SCHOFIELD WATTS BUSINESS RECOVERY LLP
    7400 Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    Warrington
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STERLING TRUST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DEWEY WARREN HOLDINGS PLC13 ott 198313 ott 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di STERLING TRUST LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2015
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2016
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per STERLING TRUST LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al02 apr 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma16 apr 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per STERLING TRUST LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per STERLING TRUST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 set 2025

    19 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 set 2024

    18 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    26 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Cessazione della carica di Catherine Lucy Hudson come amministratore in data 10 gen 2023

    1 pagineTM01

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 16 mar 2017

    21 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 16 set 2016

    19 pagine2.24B

    Chi sono gli amministratori di STERLING TRUST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRAVO QUITERIO, Maria Jose
    c/o Dow Schofield Watts Business Recovery Llp
    Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    7400
    Warrington
    Segretario
    c/o Dow Schofield Watts Business Recovery Llp
    Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    7400
    Warrington
    188949290001
    EMSON, Colin Jack
    c/o Dow Schofield Watts Business Recovery Llp
    Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    7400
    Warrington
    Amministratore
    c/o Dow Schofield Watts Business Recovery Llp
    Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    7400
    Warrington
    United KingdomBritish112674450001
    FARRELL, John Kevin
    c/o Dow Schofield Watts Business Recovery Llp
    Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    7400
    Warrington
    Amministratore
    c/o Dow Schofield Watts Business Recovery Llp
    Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    7400
    Warrington
    EnglandBritish42388910001
    TRACHTENBERG, Larry Steven
    Crediton Hill
    NW6 1HS London
    37
    United Kingdom
    Amministratore
    Crediton Hill
    NW6 1HS London
    37
    United Kingdom
    EnglandBritish4331320001
    BOTTOMLEY, John Michael
    Crosswall
    EC3N 2SG London
    One America Square
    Segretario
    Crosswall
    EC3N 2SG London
    One America Square
    British4250040006
    CHARLTON, Stephen
    115 Ember Lane
    KT10 8EQ Esher
    Surrey
    Segretario
    115 Ember Lane
    KT10 8EQ Esher
    Surrey
    British27588400002
    CLISSOLD, Graeme David Robert
    8 Cottons Field
    Dry Drayton
    CB3 8DG Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    8 Cottons Field
    Dry Drayton
    CB3 8DG Cambridge
    Cambridgeshire
    British71817350001
    BOTTOMLEY, John Michael
    Crosswall
    EC3N 2SG London
    One America Square
    Amministratore
    Crosswall
    EC3N 2SG London
    One America Square
    EnglandBritish4250040006
    BOTTOMLEY, John Michael
    The Beeches
    Church Road
    GU51 4LY Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    The Beeches
    Church Road
    GU51 4LY Fleet
    Hampshire
    British4250040001
    CHARLTON, Stephen
    115 Ember Lane
    KT10 8EQ Esher
    Surrey
    Amministratore
    115 Ember Lane
    KT10 8EQ Esher
    Surrey
    British27588400002
    COURTNEY, Rohan Richard
    Deepwood
    Lower Wood Road
    SY8 2JQ Ludlow
    Shropshire
    Amministratore
    Deepwood
    Lower Wood Road
    SY8 2JQ Ludlow
    Shropshire
    British9512790002
    EMSON, Colin Jack
    29 Albemarle Street
    W1X 3FA London
    Amministratore
    29 Albemarle Street
    W1X 3FA London
    EnglandBritish666630001
    FRESSON, Michael John
    11 Cadogan Gardens
    SW3 2RJ London
    Amministratore
    11 Cadogan Gardens
    SW3 2RJ London
    British13382990001
    HART, David Ward
    89 Garden Road
    GU15 2JE Camberley
    Victoria Cottage
    Surrey
    Amministratore
    89 Garden Road
    GU15 2JE Camberley
    Victoria Cottage
    Surrey
    EnglandBritish666620002
    HOLDEN, Harry James
    Cornfields
    Whitway Burghclere
    RG15 9LE Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Cornfields
    Whitway Burghclere
    RG15 9LE Newbury
    Berkshire
    British47585810001
    HUDSON, Catherine Lucy
    c/o Dow Schofield Watts Business Recovery Llp
    Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    7400
    Warrington
    Amministratore
    c/o Dow Schofield Watts Business Recovery Llp
    Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    7400
    Warrington
    EnglandBritish90214490004
    KEEGAN, Mark Fitzpatrick
    Grizebeck
    LA17 7XN Kirkby In Furness
    Ashlack Hall
    England
    England
    Amministratore
    Grizebeck
    LA17 7XN Kirkby In Furness
    Ashlack Hall
    England
    England
    EnglandBritish3122690001
    LYTTLETON, Jonathan Andrew
    2 Elm Walk
    NW3 7UP London
    Amministratore
    2 Elm Walk
    NW3 7UP London
    British7415630001
    PILBROW, Nicholas David
    21-24 Millbank
    17th Floor
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    Amministratore
    21-24 Millbank
    17th Floor
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    United KingdomBritish79033130004
    REMINGTON-HOBBS, James
    Steyne House Steyne Farm Shop
    Steyne Cross
    PO35 5PF Bembridge
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Steyne House Steyne Farm Shop
    Steyne Cross
    PO35 5PF Bembridge
    Isle Of Wight
    British75010140003
    WHITE, Robert Glanville
    10 Killieser Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4NT London
    Amministratore
    10 Killieser Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4NT London
    United KingdomBritish40217100001
    EQUITY COMMERCIAL INVESTMENTS LIMITED
    Index House
    St Georges Lane
    SL5 7EU Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Index House
    St Georges Lane
    SL5 7EU Ascot
    Berkshire
    31943620001

    STERLING TRUST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 giu 2013
    Consegnato il 28 giu 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Grenda Investments Limited
    Transazioni
    • 28 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 giu 2013
    Consegnato il 28 giu 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bluestone Securities Limited
    Transazioni
    • 28 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Share charge
    Creato il 02 mar 2012
    Consegnato il 20 mar 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from C.B.T. partners limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Full title guarantee and as security for the payment discharge and performance of all secured liabilities charged in favour of the charge. Sterling trust relec PLC ordinary shares number held 210,361,181 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Seabreeze Enterprises Limited
    Transazioni
    • 20 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 set 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Intercreditor deed
    Creato il 28 mar 2006
    Consegnato il 18 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The investor debt, and any payment or distribution of any kind and all and any rights in respect thereof whether in cash,securities or other property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Trustee)
    Transazioni
    • 18 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Intercreditor deed
    Creato il 28 mar 2006
    Consegnato il 18 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    £16,000,000 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    The investor debt, and any payment or distribution of any kind and all and any rights in respect thereof whether in cash,securities or other property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Lender)
    Transazioni
    • 18 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Intercreditor deed
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 30 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    If any insolvency event occurs then the investor debt will be postponed to the bos debt and each of the investors will file any proof or other claim necessary for the recovery of the investor debt; any payment or distribution and all any rights in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge
    Creato il 05 apr 2002
    Consegnato il 25 giu 2002
    In corso
    Importo garantito
    £750,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Sterling Property Holdings Limited
    Transazioni
    • 25 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 mar 1998
    Consegnato il 27 mar 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 7 to 13 cadogan gardens london SW3 2RS and 164 to 170 pavilion road london SW3 t/n NGL345754. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Maclew Limited
    Transazioni
    • 27 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 mar 1998
    Consegnato il 27 mar 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 29 gen 1998
    Consegnato il 05 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter and/or the deed of charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking rights and assets whasoever and wheresoever both present and future including goodwill and uncalled capital and all book debts and other debts.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 06 set 1994
    Consegnato il 27 set 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The principal sum held by the bank on an account numbered 97653349 (at lombard street branch) and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over bank account
    Creato il 06 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any security document (as defined in the deed) on any account whatsoever not exceeding £250,000
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge, the deposit and all the company's right, title and interest in and to the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Unibank a/S
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 18 set 1992
    Consegnato il 22 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or argyle trust PLC to the chargee pursuant to an agreement dated 2ND september 1992 and/or the deed of covenant entered into pursuant to the agreement and/or under clauses 3.3 or 31 of the agreement
    Brevi particolari
    All sums standing to the credit of account number 639062-gbp-1000-08 (the "account")see doc ref M588C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Beneficial Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 18 set 1992
    Consegnato il 22 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or argyle trust PLC to the chargee pursuant to an agreement dated 2ND september 1992 and/or the deed of covenant entered into pursuant to the agreement and/or under clauses 3.3 and 31 of the agreement
    Brevi particolari
    All sums standing to the credit of account number 639054-gbp-1000-06 (the"account")see doc ref M587C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Beneficial Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Revolving credit agreement
    Creato il 09 dic 1991
    Consegnato il 19 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Under the credit agreement the company agrees to hold on trust for the bank and immediately pay to the bank any amount recieved or recovered by the company see form 395 for full details ref M128.
    Persone aventi diritto
    • Unibank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 09 dic 1991
    Consegnato il 19 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge,the credit agreement of even date and the sterling trust debenture
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the issued shares see form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Unibank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 09 dic 1991
    Consegnato il 19 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge,the credit agreement of even date and the sterling trust debenture
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the issued shares (as defined therein).
    Persone aventi diritto
    • Unibank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 dic 1991
    Consegnato il 19 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture and the credit agreement of even date
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the issued shares and all interests in the issued shares see form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Unibank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on cash
    Creato il 06 feb 1989
    Consegnato il 14 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection wtih the security documents as defined in the facility letter dated 6/2/89 and this charge.
    Brevi particolari
    First fixed charge on all sums standing to the credit of the company in the charged accounts.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 28 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on shares
    Creato il 06 feb 1989
    Consegnato il 14 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the security documents as defined in the facility letter dated 6/2/89 and this charge.
    Brevi particolari
    All interest and dividends paid or payable after 6/2/89 on all or any of the charged shares. Floating charge or all the company'S. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 dic 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    STERLING TRUST LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 ott 2015Inizio dell'amministrazione
    12 set 2023Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Allan Carpenter
    7400 Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    Cheshire
    Praticante
    7400 Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    Cheshire
    Christopher Benjamin Barrett
    7400 Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    Cheshire
    Praticante
    7400 Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    Cheshire
    2
    DataTipo
    12 set 2023Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Allan Carpenter
    7400 Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4BS Warrington
    Cheshire
    Praticante
    7400 Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4BS Warrington
    Cheshire
    Christopher Benjamin Barrett
    7400 Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    Cheshire
    Praticante
    7400 Daresbury Park
    WA4 4BS Daresbury
    Cheshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0